ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED

ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01951290
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    100 Victoria Street
    SW1E 5JL London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CLAYFORM DEVELOPMENTS LIMITED26 nov 198526 nov 1985
    CUTEDEL LIMITED30 set 198530 set 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2023

    Quali sono le ultime deposizioni per ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione della carica di Development Securities Estates Limited come amministratore in data 16 feb 2024

    1 pagineTM01

    Notifica di Land Securities Spv’S Limited come persona con controllo significativo il 12 feb 2024

    2 paginePSC02

    Cessazione di U and I Exit Limited come persona con controllo significativo il 12 feb 2024

    1 paginePSC07

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2023

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 apr 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Development Securities Estates Limited il 06 ott 2022

    1 pagineCH02

    Dettagli del direttore cambiati per Development Securities Estates Plc il 04 ott 2019

    1 pagineCH02

    Modifica dei dettagli di U and I Exit Limited come persona con controllo significativo il 06 ott 2022

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    6 pagineAA

    Nomina di U and I Company Secretaries Limited come segretario in data 05 ott 2022

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Ls Company Secretaries Limited come segretario in data 05 ott 2022

    1 pagineTM02

    Nomina di U and I Director 2 Limited come amministratore in data 05 ott 2022

    2 pagineAP02

    Nomina di U and I Director 1 Limited come amministratore in data 05 ott 2022

    2 pagineAP02

    Indirizzo della sede legale modificato da 7a Howick Place London SW1P 1DZ United Kingdom a 100 Victoria Street London SW1E 5JL in data 06 ott 2022

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr George Mark Richardson il 18 ago 2022

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Richard Upton come amministratore in data 30 apr 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Jamie Graham Christmas come amministratore in data 31 mar 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Chris Barton come segretario in data 17 dic 2021

    1 pagineTM02

    Nomina di Ls Company Secretaries Limited come segretario in data 17 dic 2021

    2 pagineAP04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    10 pagineAA

    Nomina di Mr Jamie Graham Christmas come amministratore in data 31 mag 2021

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    U AND I COMPANY SECRETARIES LIMITED
    SW1E 5JL London
    100 Victoria Street
    England
    Segretario
    SW1E 5JL London
    100 Victoria Street
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione14397831
    301504670001
    RICHARDSON, George Mark
    SW1E 5JL London
    100 Victoria Street
    England
    Amministratore
    SW1E 5JL London
    100 Victoria Street
    England
    United KingdomBritish300754680001
    U AND I DIRECTOR 1 LIMITED
    SW1E 5JL London
    100 Victoria Street
    England
    Amministratore
    SW1E 5JL London
    100 Victoria Street
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione14396718
    301323850001
    U AND I DIRECTOR 2 LIMITED
    SW1E 5JL London
    100 Victoria Street
    England
    Amministratore
    SW1E 5JL London
    100 Victoria Street
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione14396827
    301323930001
    BARTON, Chris
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Segretario
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    193936360001
    BRAYSHAW, Martin John
    87 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    Segretario
    87 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    British8606990001
    CROMPTON, Rita Mary
    36 Priory Avenue
    N8 7RN London
    Segretario
    36 Priory Avenue
    N8 7RN London
    British4779150001
    LANES, Stephen Alec
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    Segretario
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    British1266100003
    RATSEY, Helen Maria
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    Segretario
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    British158443240001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    Segretario
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    190689580001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    3 Bayliss Road
    Wargrave
    RG10 8DR Reading
    Berkshire
    Segretario
    3 Bayliss Road
    Wargrave
    RG10 8DR Reading
    Berkshire
    British4779170001
    LS COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    England
    England
    Segretario
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    England
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione04365193
    159674790001
    BODIE, Anthony Ellyah
    112 Clifton Hill
    NW8 OJS London
    Amministratore
    112 Clifton Hill
    NW8 OJS London
    British34902790002
    BURLETSON, Bryan Richard
    Farmhouse
    Templecombe
    RG9 3HP Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Farmhouse
    Templecombe
    RG9 3HP Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish57633110005
    CHATTERJEE, Vivienne Teresa
    18 Belsize Crescent
    NW3 5QU London
    Amministratore
    18 Belsize Crescent
    NW3 5QU London
    British9092320001
    CHRISTMAS, Jamie Graham
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United Kingdom
    United KingdomBritish162910480002
    CORDEREY, Neil Sinclair
    5 Barton Road
    AL4 8QG Wheathampstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Barton Road
    AL4 8QG Wheathampstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish74024640001
    DOWLING, Brian Sidney Preston
    Crest House
    Silver Street Goffs Oak
    EN7 5JE Cheshunt
    Amministratore
    Crest House
    Silver Street Goffs Oak
    EN7 5JE Cheshunt
    British36851910001
    MARX, Michael Henry
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish35019090001
    UPTON, Richard
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritish204950320001
    VAUGHAN, Steven Mark
    16 Kittiwake Close
    Woodley
    RG5 4UF Reading
    Berkshire
    Amministratore
    16 Kittiwake Close
    Woodley
    RG5 4UF Reading
    Berkshire
    British9092330001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    3 Bayliss Road
    Wargrave
    RG10 8DR Reading
    Berkshire
    Amministratore
    3 Bayliss Road
    Wargrave
    RG10 8DR Reading
    Berkshire
    British4779170001
    WEINER, Matthew Simon
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish72888710002
    DEVELOPMENT SECURITIES ESTATES LIMITED
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    England
    Amministratore
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione657311
    53858600004

    Chi sono le persone con controllo significativo di ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    England
    12 feb 2024
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneUnited Kingdom
    Numero di registrazione4365195
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    SW1E 5JL London
    100 Victoria Street
    England
    24 nov 2020
    SW1E 5JL London
    100 Victoria Street
    England
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione12791105
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00701787
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of release and substitution
    Creato il 13 ott 1993
    Consegnato il 18 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £20,000,000 11 percent. First mortgage debenture stock 2016 of clayform holdings PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental
    Brevi particolari
    The capital sum of £3,050,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 18 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of admission
    Creato il 05 mag 1993
    Consegnato il 12 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h & l/h property of the company both present and future including all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time on any such property and all vendor's liens mortgages charges options agreements and rights titles and interests in or over land of whatever description both present and future (for full details see form 395 and contd sheets attached).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 apr 1993
    Consegnato il 30 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 19 apr 1993
    Consegnato il 28 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 25 nov 1992
    Consegnato il 30 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £20,000,000 11 per cent first mortgage debenture stock 2016 of clayform holdings PLC and all other monies intended to be secured by the deed and the existing deeds (as defined) to which it is supplemental
    Brevi particolari
    The capital sum of £450,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 30 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 apr 1992
    Consegnato il 16 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of white lion road amersham bucks t/no.bm 117999.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creato il 06 apr 1992
    Consegnato il 08 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Principal and interest on £20,000,000 11% first mortgage debenture stock 2016 of clayform holdings PLC and all other moneys intended to be secured by this deed and the existing deeds (as defined) to which it is supplemental
    Brevi particolari
    Freehold property known as repton place white lion road amersham buckinghamshiresee form 395 ref M114.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 08 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 02 set 1991
    Consegnato il 20 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of loan agreements (as defined) and/or this charge
    Brevi particolari
    F/H repton place land and buildings on the north side of white lion road amersham, bucks t/no bm 117999. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limited(As Agent for the Banks)
    Transazioni
    • 20 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 27 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 ago 1990
    Consegnato il 29 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Land & buildings on the north side of white lion road, amersham buckinghamshire title no:- bm 177999.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 08 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 feb 1990
    Consegnato il 28 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and clayform properties to the chargee.
    Brevi particolari
    F/H convergent house white lion road amersham buckinghamshire t/no bm 117999.
    Persone aventi diritto
    • Banque National De Paris PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 16 dic 1988
    Acquisito il 31 mar 1989
    Consegnato il 20 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due
    Brevi particolari
    Convergent house (formerly meteor house) white lion road, amersham chiltern, bucks t/no bm 117999.
    Persone aventi diritto
    • Banque National De Paris PLC
    Transazioni
    • 20 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    First mortgage
    Creato il 04 feb 1988
    Acquisito il 31 mar 1989
    Consegnato il 20 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due
    Brevi particolari
    75,77,79 morsey street tower hamlets london t/no ln 136773.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 27 feb 1986
    Consegnato il 19 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    56 and 58 middle street yeovil somerset.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 06 gen 1986
    Consegnato il 15 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    49-52 st johns square and 8 jerusalem passage l/b of islington title nos 309848 433334 ln 5306.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 23 dic 1985
    Consegnato il 02 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    77/77A high street, andover, hampshire t/n hp 197774.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 gen 1986Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0