ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01951290 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 100 Victoria Street SW1E 5JL London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CLAYFORM DEVELOPMENTS LIMITED | 26 nov 1985 | 26 nov 1985 |
| CUTEDEL LIMITED | 30 set 1985 | 30 set 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2023 |
Quali sono le ultime deposizioni per ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Cessazione della carica di Development Securities Estates Limited come amministratore in data 16 feb 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Notifica di Land Securities Spv’S Limited come persona con controllo significativo il 12 feb 2024 | 2 pagine | PSC02 | ||
Cessazione di U and I Exit Limited come persona con controllo significativo il 12 feb 2024 | 1 pagine | PSC07 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2023 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 apr 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Development Securities Estates Limited il 06 ott 2022 | 1 pagine | CH02 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Development Securities Estates Plc il 04 ott 2019 | 1 pagine | CH02 | ||
Modifica dei dettagli di U and I Exit Limited come persona con controllo significativo il 06 ott 2022 | 2 pagine | PSC05 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022 | 6 pagine | AA | ||
Nomina di U and I Company Secretaries Limited come segretario in data 05 ott 2022 | 2 pagine | AP04 | ||
Cessazione della carica di Ls Company Secretaries Limited come segretario in data 05 ott 2022 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di U and I Director 2 Limited come amministratore in data 05 ott 2022 | 2 pagine | AP02 | ||
Nomina di U and I Director 1 Limited come amministratore in data 05 ott 2022 | 2 pagine | AP02 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 7a Howick Place London SW1P 1DZ United Kingdom a 100 Victoria Street London SW1E 5JL in data 06 ott 2022 | 1 pagine | AD01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr George Mark Richardson il 18 ago 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Cessazione della carica di Richard Upton come amministratore in data 30 apr 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Jamie Graham Christmas come amministratore in data 31 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Chris Barton come segretario in data 17 dic 2021 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Ls Company Secretaries Limited come segretario in data 17 dic 2021 | 2 pagine | AP04 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 10 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Jamie Graham Christmas come amministratore in data 31 mag 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U AND I COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | SW1E 5JL London 100 Victoria Street England |
| 301504670001 | ||||||||||
| RICHARDSON, George Mark | Amministratore | SW1E 5JL London 100 Victoria Street England | United Kingdom | British | 300754680001 | |||||||||
| U AND I DIRECTOR 1 LIMITED | Amministratore | SW1E 5JL London 100 Victoria Street England |
| 301323850001 | ||||||||||
| U AND I DIRECTOR 2 LIMITED | Amministratore | SW1E 5JL London 100 Victoria Street England |
| 301323930001 | ||||||||||
| BARTON, Chris | Segretario | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | 193936360001 | |||||||||||
| BRAYSHAW, Martin John | Segretario | 87 Main Street Lyddington LE15 9LS Oakham Leicestershire | British | 8606990001 | ||||||||||
| CROMPTON, Rita Mary | Segretario | 36 Priory Avenue N8 7RN London | British | 4779150001 | ||||||||||
| LANES, Stephen Alec | Segretario | Thorpe House 105 Mycenae Road Blackheath SE3 7RX London | British | 1266100003 | ||||||||||
| RATSEY, Helen Maria | Segretario | Bressenden Place SW1E 5DS London Portland House England | British | 158443240001 | ||||||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Segretario | Bressenden Place SW1E 5DS London Portland House England England | 190689580001 | |||||||||||
| WARE, Robert Thomas Ernest | Segretario | 3 Bayliss Road Wargrave RG10 8DR Reading Berkshire | British | 4779170001 | ||||||||||
| LS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England England |
| 159674790001 | ||||||||||
| BODIE, Anthony Ellyah | Amministratore | 112 Clifton Hill NW8 OJS London | British | 34902790002 | ||||||||||
| BURLETSON, Bryan Richard | Amministratore | Farmhouse Templecombe RG9 3HP Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 57633110005 | |||||||||
| CHATTERJEE, Vivienne Teresa | Amministratore | 18 Belsize Crescent NW3 5QU London | British | 9092320001 | ||||||||||
| CHRISTMAS, Jamie Graham | Amministratore | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 162910480002 | |||||||||
| CORDEREY, Neil Sinclair | Amministratore | 5 Barton Road AL4 8QG Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 74024640001 | |||||||||
| DOWLING, Brian Sidney Preston | Amministratore | Crest House Silver Street Goffs Oak EN7 5JE Cheshunt | British | 36851910001 | ||||||||||
| MARX, Michael Henry | Amministratore | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | United Kingdom | British | 35019090001 | |||||||||
| UPTON, Richard | Amministratore | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | England | British | 204950320001 | |||||||||
| VAUGHAN, Steven Mark | Amministratore | 16 Kittiwake Close Woodley RG5 4UF Reading Berkshire | British | 9092330001 | ||||||||||
| WARE, Robert Thomas Ernest | Amministratore | 3 Bayliss Road Wargrave RG10 8DR Reading Berkshire | British | 4779170001 | ||||||||||
| WEINER, Matthew Simon | Amministratore | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | United Kingdom | British | 72888710002 | |||||||||
| DEVELOPMENT SECURITIES ESTATES LIMITED | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England |
| 53858600004 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Securities Spv’S Limited | 12 feb 2024 | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| U And I Exit Limited | 24 nov 2020 | SW1E 5JL London 100 Victoria Street England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Development Securities (Investments) Plc | 06 apr 2016 | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of release and substitution | Creato il 13 ott 1993 Consegnato il 18 ott 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the £20,000,000 11 percent. First mortgage debenture stock 2016 of clayform holdings PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental | |
Brevi particolari The capital sum of £3,050,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of admission | Creato il 05 mag 1993 Consegnato il 12 mag 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h & l/h property of the company both present and future including all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time on any such property and all vendor's liens mortgages charges options agreements and rights titles and interests in or over land of whatever description both present and future (for full details see form 395 and contd sheets attached). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 19 apr 1993 Consegnato il 30 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 19 apr 1993 Consegnato il 28 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and substitution | Creato il 25 nov 1992 Consegnato il 30 nov 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the £20,000,000 11 per cent first mortgage debenture stock 2016 of clayform holdings PLC and all other monies intended to be secured by the deed and the existing deeds (as defined) to which it is supplemental | |
Brevi particolari The capital sum of £450,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 08 apr 1992 Consegnato il 16 apr 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the north side of white lion road amersham bucks t/no.bm 117999. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental trust deed | Creato il 06 apr 1992 Consegnato il 08 apr 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Principal and interest on £20,000,000 11% first mortgage debenture stock 2016 of clayform holdings PLC and all other moneys intended to be secured by this deed and the existing deeds (as defined) to which it is supplemental | |
Brevi particolari Freehold property known as repton place white lion road amersham buckinghamshiresee form 395 ref M114. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 02 set 1991 Consegnato il 20 set 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of loan agreements (as defined) and/or this charge | |
Brevi particolari F/H repton place land and buildings on the north side of white lion road amersham, bucks t/no bm 117999. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 17 ago 1990 Consegnato il 29 ago 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Land & buildings on the north side of white lion road, amersham buckinghamshire title no:- bm 177999. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 12 feb 1990 Consegnato il 28 feb 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and clayform properties to the chargee. | |
Brevi particolari F/H convergent house white lion road amersham buckinghamshire t/no bm 117999. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 16 dic 1988 Acquisito il 31 mar 1989 Consegnato il 20 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due | |
Brevi particolari Convergent house (formerly meteor house) white lion road, amersham chiltern, bucks t/no bm 117999. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| First mortgage | Creato il 04 feb 1988 Acquisito il 31 mar 1989 Consegnato il 20 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due | |
Brevi particolari 75,77,79 morsey street tower hamlets london t/no ln 136773. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 27 feb 1986 Consegnato il 19 mar 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari 56 and 58 middle street yeovil somerset. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 gen 1986 Consegnato il 15 gen 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari 49-52 st johns square and 8 jerusalem passage l/b of islington title nos 309848 433334 ln 5306. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 dic 1985 Consegnato il 02 gen 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or clayform properties PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari 77/77A high street, andover, hampshire t/n hp 197774. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0