WICKES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | WICKES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01954281 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WICKES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova WICKES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | MAZARS LLP 45 Church Street B3 2RT Birmingham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WICKES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CALLNEXT LIMITED | 04 nov 1985 | 04 nov 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WICKES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 giu 2015 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mar 2016 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Quali sono le ultime deposizioni per WICKES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Miss Deborah Grimason il 13 ott 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 6 pagine | 4.71 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton Northamptonshire NN5 7UG a 45 Church Street Birmingham B3 2RT in data 06 gen 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 14 dic 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Miss Deborah Grimason come amministratore in data 10 set 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2014 al 30 giu 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Peter Carter come amministratore in data 10 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony David Buffin come amministratore in data 10 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Stephen Pike come segretario in data 23 set 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Tp Directors Ltd come amministratore in data 19 set 2014 | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 16 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Anthony David Buffin il 12 nov 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Anthony Buffin come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WICKES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIMASON, Deborah | Amministratore | Church Street B3 2RT Birmingham 45 | England | British | Company Secretary | 185755960002 | ||||||||
TP DIRECTORS LTD | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
PIKE, Andrew Stephen | Segretario | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | Secretary | 65678800002 | |||||||||
RIMMER, Barbara | Segretario | 28 Chapel Lane Hale Barns WA15 0HN Altrincham Cheshire | British | 76973560002 | ||||||||||
STOKES-SMITH, Keith Reginald | Segretario | 5a The Broadway Penn Road HP9 2PD Beaconsfield Buckinghamshire | British | 75650590001 | ||||||||||
BATTERSBY, Geoffrey Brian | Amministratore | 13 15 Westcombe Park Road Blackheath SE3 7RE London | British | Financial Controller | 41548740003 | |||||||||
BHOTE, Sanaya Homi | Amministratore | 50 Bonnersfield Lane HA1 2LE Harrow Middlesex | British | Director Of Finance | 72716110002 | |||||||||
BIRD, Richard Sidney | Amministratore | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | British | Director | 111500210001 | |||||||||
BUFFIN, Anthony David | Amministratore | Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | England | British | Company Director | 178011680002 | ||||||||
CARTER, John Peter | Amministratore | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | Director | 46226920007 | ||||||||
CORNER, Michael Richmond | Amministratore | 95 Castelnau Barnes SW13 London | British | Barrister | 21206150001 | |||||||||
GRAY, Philip Ralph | Amministratore | 24 Cumberland Close HP7 9NH Little Chalfont Buckinghamshire | British | Director | 60550130001 | |||||||||
GRIMSEY, William | Amministratore | The Capita Group Plc 71 Victoria Street SW1H 0XA London | United Kingdom | British | Chief Executive | 50647840002 | ||||||||
HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Amministratore | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 72135950007 | ||||||||
HOSKINS, William John | Amministratore | 3 Homewood Road AL1 4BE St. Albans Hertfordshire | British | Finance Director | 49295070002 | |||||||||
LLEWELLYN, Trefor Wilmot | Amministratore | Hill Farm House Ipsden OX10 6AD Wallingford Oxfordshire | England | British | Finance Director | 107250730001 | ||||||||
PENNY, Michael William Harrison | Amministratore | Windrush 9 Downsway GU1 2YA Guildford Surrey | United Kingdom | British | Director | 144262470001 | ||||||||
STOKES-SMITH, Keith Reginald | Amministratore | 5a The Broadway Penn Road HP9 2PD Beaconsfield Buckinghamshire | British | Company Secretary | 75650590001 | |||||||||
STRADLING, Stuart Rhys | Amministratore | 68 Howards Lane Putney SW15 6QD London | United Kingdom | British | Finance Director | 44265550001 | ||||||||
SWEETBAUM, Henry Alan | Amministratore | 11 Park Village West NW1 4AE London | United Kingdom | American | Chairman & Chief Executive | 10349960001 |
WICKES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Creato il 07 gen 1997 Consegnato il 15 gen 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities due owing or incurred in any manner by each charging company to the chargee (as security trustee for and on behalf of the banks) in accordance with any applicable facilities agreement | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Limited recourse guarantee and debenture | Creato il 12 dic 1996 Consegnato il 20 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) under the facilities agreement (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 03 lug 1996 Consegnato il 10 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All the new money liabilities (as defined therein) outstanding, due or owing or incurred by the charging companies (as defined therein) to the chargee | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
WICKES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0