PGIM EUROPEAN SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PGIM EUROPEAN SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01957069 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PGIM EUROPEAN SERVICES LIMITED?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova PGIM EUROPEAN SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Grand Buildings 1-3 Strand WC2N 5HR London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PGIM EUROPEAN SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PBI (UK) LIMITED | 11 ott 2004 | 11 ott 2004 |
| PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL (UK) LIMITED | 12 feb 1987 | 12 feb 1987 |
| SIDEBACK LIMITED | 11 nov 1985 | 11 nov 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PGIM EUROPEAN SERVICES LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per PGIM EUROPEAN SERVICES LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 15 mar 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 29 mar 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 15 mar 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per PGIM EUROPEAN SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Bilancio redatto al 31 dic 2024 | 41 pagine | AA | ||
Cessazione di The Prudential Insurance Company of America come persona con controllo significativo il 15 ott 2020 | 1 pagine | PSC07 | ||
Notifica di Prudential Financial, Inc. come persona con controllo significativo il 15 ott 2020 | 2 pagine | PSC02 | ||
Cessazione della carica di Paul Seth Aronoff come amministratore in data 20 ago 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 30 lug 2025
| 3 pagine | SH01 | ||
Nomina di Darren Edward Nicholls come amministratore in data 29 lug 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2023 | 34 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 38 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 37 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 36 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Paul Michael East come amministratore in data 30 giu 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Gillian Murphy come amministratore in data 30 giu 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Notifica di The Prudential Insurance Company of America come persona con controllo significativo il 15 ott 2020 | 2 pagine | PSC02 | ||
Cessazione di Pramerica Holdings Limited come persona con controllo significativo il 15 ott 2020 | 1 pagine | PSC07 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 31 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Ms Laura Downes King come segretario in data 11 ott 2019 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Mark Gerald Fresson come segretario in data 11 ott 2019 | 1 pagine | TM02 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 26 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di PGIM EUROPEAN SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING, Laura Downes | Segretario | 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings | 263441720001 | |||||||
| EAST, Paul Michael | Amministratore | 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings | England | British | 263429020001 | |||||
| FRESSON, Mark Gerald | Amministratore | 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings United Kingdom | England | British | 160978930001 | |||||
| NICHOLLS, Darren Edward | Amministratore | 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings | England | British | 303009500001 | |||||
| POLLARD, Susan Lee | Amministratore | 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings | England | British | 129859750001 | |||||
| BAGSHAW, Joanne Louise | Segretario | Flat 2 44 Eardley Road TN13 1XT Sevenoaks Kent | British | 81157100001 | ||||||
| DAVIES, Stephen John | Segretario | 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings United Kingdom | 161261990001 | |||||||
| DAWREEAWOO, Batoolah | Segretario | 9 Devonshire Square London EC2M 4HP | British | 81320790002 | ||||||
| FRESSON, Mark Gerald | Segretario | 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings | 240557680001 | |||||||
| JONES, William Nigel Henry | Segretario | Elphicks Barn Water Lane ME15 0SG Hunton Kent | British | 35883860003 | ||||||
| WARRACK, Anne Victoria Mary | Segretario | The Maltings Vicarage Lane Ugley CM22 6HU Bishops Stortford Hertfordshire | British | 54164090001 | ||||||
| ARONOFF, Paul Seth | Amministratore | 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings United Kingdom | United States | American | 161146370001 | |||||
| BAGSHAW, Joanne Louise | Amministratore | Flat 2 44 Eardley Road TN13 1XT Sevenoaks Kent | British | 81157100001 | ||||||
| BING, Gordon John Plowman | Amministratore | Mount Rethy 9 Mount Avenue Hutton CM13 2NU Brentwood Essex | British | 26068970001 | ||||||
| BRODY, Alan Jeffrey | Amministratore | 10 Hanover House St Johns Wood High Street NW8 7DX London | American | 71828800002 | ||||||
| BUNTING, Geoffrey Cooke | Amministratore | 97 Whitehall Court SW1A 2EL London | Usa | 59695100001 | ||||||
| COHEN, Andrew | Amministratore | 151 Willifield Way NW11 6XY London | British | 13908600001 | ||||||
| DATTANI, Vasant Gopaldas | Amministratore | 9 Devonshire Square London EC2M 4HP | England | British | 92234190001 | |||||
| DAVIES, Stephen John | Amministratore | 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings United Kingdom | United Kingdom | British | 160978960001 | |||||
| GROTZ, Robert Henry | Amministratore | 207 Cardamon Building 31 Shad Thames SE1 2YR London | American | 32954920001 | ||||||
| GROTZ, Robert Henry | Amministratore | 207 Cardamon Building 31 Shad Thames SE1 2YR London | American | 32954920001 | ||||||
| HASSETT, Ian Geoffrey | Amministratore | 49 Oakley Gardens SW3 5QQ London | British | 52491990001 | ||||||
| IVANS, Ronald Joseph | Amministratore | 9 Devonshire Square London EC2M 4HP | Usa | American | 111456110001 | |||||
| JONES, William Nigel Henry | Amministratore | Elphicks Barn Water Lane ME15 0SG Hunton Kent | British | 35883860003 | ||||||
| LLOYD, Geoffrey Gordon | Amministratore | 19 Eglantine Road SW18 2DE London | England | British | 6680010001 | |||||
| MASSEY, Stephen Leigh | Amministratore | 66 Elsworthy Road NW3 3BP London | United Kingdom | British | 14331620001 | |||||
| MCALEENAN, Jill Patricia | Amministratore | 78 Hazlewell Road SW15 6UR London | England | British | 49030880001 | |||||
| MCALEENAN, Jill Patricia | Amministratore | 78 Hazlewell Road SW15 6UR London | England | British | 49030880001 | |||||
| MCALEENAN, Jill Patricia | Amministratore | 78 Hazlewell Road SW15 6UR London | England | British | 49030880001 | |||||
| MCALEENAN, Jill Patricia | Amministratore | 78 Hazlewell Road SW15 6UR London | England | British | 49030880001 | |||||
| MCALEENAN, Jill Patricia | Amministratore | 78 Hazlewell Road SW15 6UR London | England | British | 49030880001 | |||||
| MCALEENAN, Jill Patricia | Amministratore | 78 Hazlewell Road SW15 6UR London | England | British | 49030880001 | |||||
| MCALEENAN, Jill Patricia | Amministratore | 78 Hazlewell Road SW15 6UR London | England | British | 49030880001 | |||||
| MCALEENAN, Jill Patricia | Amministratore | 78 Hazlewell Road SW15 6UR London | England | British | 49030880001 | |||||
| MCALEENAN, Jill Patricia | Amministratore | 78 Hazlewell Road SW15 6UR London | England | British | 49030880001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PGIM EUROPEAN SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Prudential Insurance Company Of America | 15 ott 2020 | Essex Newark 751 Broad Street New Jersey, 07102 United States | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. | 15 ott 2020 | Broad Street Newark 751 New Jersey Nj07102 United States | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Pramerica Holdings Limited | 06 apr 2016 | 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0