J & N WADE LIMITED.

J & N WADE LIMITED.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJ & N WADE LIMITED.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01957925
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di J & N WADE LIMITED.?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova J & N WADE LIMITED.?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di J & N WADE LIMITED.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BAILCROFT LIMITED12 nov 198512 nov 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di J & N WADE LIMITED.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per J & N WADE LIMITED.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    17 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor, Eagle Court 2 Hatchford Brook Hatchford Way Sheldon Birmingham B26 3RZ England a C/O Bdo Llp 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH in data 15 mar 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 24 feb 2022

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Marcus Leek come amministratore in data 01 dic 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Christopher James Hogan come amministratore in data 01 dic 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    5 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Seconda presentazione per la nomina di Toby Train come amministratore

    6 pagineRP04AP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 5th Floor Maple House Mutton Lane Potters Bar Hertfordshire EN6 5BS a Ground Floor, Eagle Court 2 Hatchford Brook Hatchford Way Sheldon Birmingham B26 3RZ in data 11 mag 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di J & N WADE LIMITED.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEEK, Marcus
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Amministratore
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    EnglandBritish236640560001
    TRAIN, Toby
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Amministratore
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    United KingdomBritish124023220002
    ANGEL, Barry Paul
    41 Frampton Way
    Totton
    SO40 9AD Southampton
    Hampshire
    Segretario
    41 Frampton Way
    Totton
    SO40 9AD Southampton
    Hampshire
    British9549440001
    ATKINS, David Edward
    22 Marshwood Road
    GU18 5QZ Lightwater
    Surrey
    Segretario
    22 Marshwood Road
    GU18 5QZ Lightwater
    Surrey
    British2809620002
    EVETTS, John Graham
    72 Sycamore Avenue
    RM14 2HS Upminster
    Essex
    Segretario
    72 Sycamore Avenue
    RM14 2HS Upminster
    Essex
    Pollish/British56188860003
    JAMES, Simon Michael
    37 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    Yorkshire
    Segretario
    37 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    Yorkshire
    British111338120001
    TALLIS, Aleksandra Jadwiga
    6 St Chads Grove
    LS6 3PN Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    6 St Chads Grove
    LS6 3PN Leeds
    West Yorkshire
    Polish34638000004
    AMOS, Michael Charles Gilbert
    1 Harlands Grove
    BR6 7WB Orpington
    Kent
    Amministratore
    1 Harlands Grove
    BR6 7WB Orpington
    Kent
    British9904110001
    ANGEL, Barry Paul
    41 Frampton Way
    Totton
    SO40 9AD Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    41 Frampton Way
    Totton
    SO40 9AD Southampton
    Hampshire
    British9549440001
    BURR, Anthony Hugh
    Woodend House
    33 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    Woodend House
    33 Woodlands Avenue
    WS5 3LN Walsall
    West Midlands
    British986020002
    CHARMAN, Kenneth
    21 Old Bridge Close
    Bursledon
    SO31 8AX Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    21 Old Bridge Close
    Bursledon
    SO31 8AX Southampton
    Hampshire
    British14909700001
    CROXSON, Neil Michael
    Floor
    Maple House Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Maple House Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Hertfordshire
    United Kingdom
    UkBritish96469690006
    DELANY, Martin
    79 Merrion Village
    Merrion Road
    Dublin 4
    Ireland
    Amministratore
    79 Merrion Village
    Merrion Road
    Dublin 4
    Ireland
    Irish44130110002
    FITCHETT, David John
    22 Lynwood Heights
    WD3 4ED Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    22 Lynwood Heights
    WD3 4ED Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandUnited Kingdom83165530001
    FORRESTER, Andrew John
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Amministratore
    The Shieling
    70 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    United KingdomBritish97001960001
    FRASER, Angus Maclean
    3 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    3 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Irish70451130001
    HAMMERSCHMID, Thomas
    86 Centenary Plaza
    Holliday Street
    B1 1HH Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    86 Centenary Plaza
    Holliday Street
    B1 1HH Birmingham
    West Midlands
    Austrian114541610001
    HAYWOOD, Timothy Paul
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    Amministratore
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritish62962370002
    HOGAN, John Christopher James
    Maple House
    EN6 5BS Potters Bar
    Maple House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Maple House
    EN6 5BS Potters Bar
    Maple House
    Hertfordshire
    England
    United KingdomIrish197357940001
    HOGG, David Ribton
    Farleton
    282 Botley Road Burridge
    SO31 1BQ Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Farleton
    282 Botley Road Burridge
    SO31 1BQ Southampton
    Hampshire
    British2809630001
    HUNTER, Andrew James Woosnam
    11 Riverholme
    Hampton Court
    KT8 9BP East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    11 Riverholme
    Hampton Court
    KT8 9BP East Molesey
    Surrey
    British14909690001
    JORDAN, Alan
    56 Chiltley Way
    GU30 7HE Liphook
    Hampshire
    Amministratore
    56 Chiltley Way
    GU30 7HE Liphook
    Hampshire
    Irish73934080001
    LASCHKAR, Henri-Paul
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Herts
    Amministratore
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th
    Herts
    UkFrench139160640005
    LAYCOCK, Derek Francis
    The Fosse
    4 Fitzroy Road
    GU51 4JH Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    The Fosse
    4 Fitzroy Road
    GU51 4JH Fleet
    Hampshire
    British78294880001
    LILLIS, James Anthony
    10 Offington Drive
    Sutton
    13 Dublin
    Ireland
    Amministratore
    10 Offington Drive
    Sutton
    13 Dublin
    Ireland
    Irish49070590001
    MOLLOY, Brian Patrick
    Columbine Lodge
    Cornelscourt
    IRISH Dublin 18
    Eire
    Amministratore
    Columbine Lodge
    Cornelscourt
    IRISH Dublin 18
    Eire
    IrelandIrish49573400001
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Amministratore
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomScottish146642810001
    NICHOLS, Matt Ward, Mr.
    18 Sweetpool Lane
    Hagley
    DY8 2XH Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    18 Sweetpool Lane
    Hagley
    DY8 2XH Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish177829370001
    PASSMAN, Jonathan Richard
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    Amministratore
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    British122460330002
    ROFF, Alan
    25 College Close
    PO9 6AJ Rowlands Castle
    Hampshire
    Amministratore
    25 College Close
    PO9 6AJ Rowlands Castle
    Hampshire
    EnglandBritish205772150001
    ROSE, Richard Sidney
    Ivonbrook
    27 Totteridge Village
    N20 8PN London
    Amministratore
    Ivonbrook
    27 Totteridge Village
    N20 8PN London
    EnglandBritish20113670001
    WESTMAN, Lawrence
    Whitescross
    Foxrock
    IRISH Dublin 18
    Newpark House
    Ireland
    Amministratore
    Whitescross
    Foxrock
    IRISH Dublin 18
    Newpark House
    Ireland
    IrelandIrish241846320001
    WOUTERSE, Alexander Jan
    Van Beeverlaan 15,
    1251 Es Laren
    Netherlands
    Amministratore
    Van Beeverlaan 15,
    1251 Es Laren
    Netherlands
    Dutch105846620001

    Chi sono le persone con controllo significativo di J & N WADE LIMITED.?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wf Electrical Limited
    Hatchford Way
    Sheldon
    B26 3RZ Birmingham
    Eagle Court 2
    England
    30 giu 2016
    Hatchford Way
    Sheldon
    B26 3RZ Birmingham
    Eagle Court 2
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneUk Company Register
    Numero di registrazione00085004
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    J & N WADE LIMITED. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Confirmatory charge
    Creato il 10 feb 1986
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 11 gen 1986
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 17 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing form time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M34). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 ago 1983
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properies floating charge over the (see doc M28). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 02 ago 1983
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book & other debts now & from time to time owing.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental cahrge
    Creato il 02 ago 1983
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book & other debts now & from time to time owing.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 02 ago 1983
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing form time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book & other debts now & from time to time owing.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 02 ago 1983
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book & other debts now & from time to time owing.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 02 ago 1983
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book & other debts now & from time to time owing.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 02 ago 1983
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book & other debts now & from time to time owing.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 02 ago 1983
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed cahrge over all book and other debts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 feb 1981
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/a and l/h properties floating charge over the (see doc M34). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 feb 1981
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M34). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 feb 1981
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties flaoting charge over the (see doc M34). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 feb 1981
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h and l/a properties floating charge over the (see doc M28). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 feb 1981
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M28). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Confirmatory charge
    Creato il 10 feb 1981
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M22). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 ago 1979
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M34). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 11 feb 1977
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M22). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 feb 1974
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M22). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 mar 1972
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M28). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 dic 1970
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M28). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General charge
    Creato il 25 giu 1969
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M22). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General charge
    Creato il 19 dic 1966
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M22). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General charge
    Creato il 31 dic 1965
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the undertaking (see doc M22). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General charge
    Creato il 10 gen 1964
    Acquisito il 31 gen 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies owing from time to time
    Brevi particolari
    Fixed charge over present and future f/h and l/h properties floating charge over the (see doc M22). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    J & N WADE LIMITED. ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 giu 2023Data prevista di scioglimento
    24 feb 2022Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stacey Brown
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Matthew James Chadwick
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex
    Praticante
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0