TOMORROWS LEISURE LIMITED

TOMORROWS LEISURE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTOMORROWS LEISURE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01960179
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TOMORROWS LEISURE LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova TOMORROWS LEISURE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Grant Thorton Uk Llp
    Grant Thorton House
    NW1 2EP Melton Street Euston Square
    London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TOMORROWS LEISURE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GAMEHOST LIMITED15 nov 198515 nov 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di TOMORROWS LEISURE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2004

    Quali sono le ultime deposizioni per TOMORROWS LEISURE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ott 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 apr 2011

    5 pagine4.68

    Cessazione della carica di Richard Bingham come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Martin May come amministratore

    2 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ott 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 apr 2010

    5 pagine4.68

    Cessazione della carica di Jeremy Gorman come segretario

    2 pagineTM02

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ott 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 apr 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ott 2008

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ott 2008

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    legacy

    1 pagine287

    Dichiarazione delle attività

    6 pagine4.20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di TOMORROWS LEISURE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRUCE, Andrew David
    57 Aragon Road
    KT2 5QB Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    57 Aragon Road
    KT2 5QB Kingston Upon Thames
    Surrey
    British55572430002
    GEMMILL, Thomas Cochran
    North View North Road
    Ponteland
    NE20 0AA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    North View North Road
    Ponteland
    NE20 0AA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British14010350001
    GORMAN, Jeremy Philip
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    Segretario
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    British3290440003
    INWOOD, Leslie George
    Poplar Cottage Rye Common
    RG29 1HT Odiham
    Hampshire
    Segretario
    Poplar Cottage Rye Common
    RG29 1HT Odiham
    Hampshire
    British1569310001
    JONES, Michael Robert
    18 Meadowfield
    Red House Farm Estate
    NE25 9YD Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Segretario
    18 Meadowfield
    Red House Farm Estate
    NE25 9YD Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British34824970001
    ANYSZ, Barry Aubrey
    10 Wigton Chase
    Wigton Lane
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    10 Wigton Chase
    Wigton Lane
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish18679440001
    BINGHAM, Richard Keith
    34 Lyndhurst Drive
    TN13 2HQ Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    34 Lyndhurst Drive
    TN13 2HQ Sevenoaks
    Kent
    British76681420001
    BLAXALL, Christopher Stanley
    The Old School House
    Church Lane
    NE44 6AP Riding Mill
    Northumberland
    Amministratore
    The Old School House
    Church Lane
    NE44 6AP Riding Mill
    Northumberland
    British23769920002
    BRUCE, Andrew David
    22 Penrith Road
    KT3 3QS New Malden
    Surrey
    Amministratore
    22 Penrith Road
    KT3 3QS New Malden
    Surrey
    British55572430001
    DAWSON, Peter
    Hill Bank Batt House Road
    NE43 7RA Stocksfield
    Northumberland
    Amministratore
    Hill Bank Batt House Road
    NE43 7RA Stocksfield
    Northumberland
    British38651710001
    EDWARDS, David James
    Greencroft 38 Dunbar Road
    EH41 3PJ Haddington
    East Lothian
    Amministratore
    Greencroft 38 Dunbar Road
    EH41 3PJ Haddington
    East Lothian
    British9489100001
    FOSTER, Christopher Kenneth
    Springwood House The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Springwood House The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish36477980002
    GEMMILL, Thomas Cochran
    North View North Road
    Ponteland
    NE20 0AA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    North View North Road
    Ponteland
    NE20 0AA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British14010350001
    GODFREY, Nicholas Joseph
    Flat 3
    48 Red Lion Street
    WC1R 4PF London
    Amministratore
    Flat 3
    48 Red Lion Street
    WC1R 4PF London
    United KingdomBritish89433450001
    INY, Oliver Oliver
    38 Upper Brook Street
    Mayfair
    W1Y 1PE London
    Amministratore
    38 Upper Brook Street
    Mayfair
    W1Y 1PE London
    United KingdomBritish8210140002
    LANSBURY, Geoffrey
    St Ivers Corner
    Doggett Wood Lane
    HP8 4TD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    St Ivers Corner
    Doggett Wood Lane
    HP8 4TD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British55614860001
    MAY, Martin Keith
    3 Caribou Close
    Off Butts Hill Road Woodley
    RG5 4RA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    3 Caribou Close
    Off Butts Hill Road Woodley
    RG5 4RA Reading
    Berkshire
    British90818620001
    POWELL, Malcolm
    23 Woodlands
    High Rickleton
    NE38 9HD Washington
    Tyne & Wear
    Amministratore
    23 Woodlands
    High Rickleton
    NE38 9HD Washington
    Tyne & Wear
    British48781890001
    REBEIRO, Paul Edward
    15 Barn Close
    AL8 6ST Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    15 Barn Close
    AL8 6ST Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British102840510001
    ROBERTS, Thomas John Blackburn
    Southwick Court
    Southwick
    BA14 9QB Trowbridge
    Wiltshire
    Amministratore
    Southwick Court
    Southwick
    BA14 9QB Trowbridge
    Wiltshire
    British35567350001
    SANDERSON, John Taylor
    30 The Oval
    Forest Hall
    NE12 9PP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    30 The Oval
    Forest Hall
    NE12 9PP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish14010330001
    WILSON, Vincent
    94 John F Kennedy Estate
    NE38 7AL Washington
    Tyne & Wear
    Amministratore
    94 John F Kennedy Estate
    NE38 7AL Washington
    Tyne & Wear
    British30966780001

    TOMORROWS LEISURE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 29 ago 2002
    Consegnato il 12 set 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from wiggins management services limited ("the principal debtor") and/or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and premises situate and k/a land and buildings lying to the south of cranwick avenue and land and buildings lying on the east side of london road, bracebridge heath t/no. LL114848 and all buildings fixtures fittings plant machinery apparatus goods and materials thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Compania Financiera La Granja Sa
    Transazioni
    • 12 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 29 ago 2002
    Consegnato il 11 set 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or wiggins group PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings lying to the south of canwick avenue and land and buildings lyig on the east side of london road bracebridge heath t/n LL114848 all fixtures fittings plant and machinery all rental or licence fees and any insurance.
    Persone aventi diritto
    • Siem Oceanic LTD
    Transazioni
    • 11 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 29 ago 2002
    Consegnato il 11 set 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies and liabilities on any account whatsoever due or to become due from the principal debtor and/or the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/Hold land and premises known as land and buildings lying to the south of canwick avenue and land and buildings lying on the east side of london road,bracebridge heath; t/no ll 114848; all rights,powers,easements and liberties attached thereto and all buildings,fixtures,fittings,plant,machinery,apparatus,goods and materials thereon; all right title and interest in and to all the rental or licence fee income received thereunder and all payments in respect of services and insurance contributions receivable whatsoever; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldbridge Ventures Limited,Columbus Asset Management Limited and Jeffrey Vernon Wilkinson
    Transazioni
    • 11 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 01 apr 1998
    Consegnato il 09 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings lying to the south of canwick avenue and land and buildings lying on the east side of london road bracebridge heath north keverston county of lincolnshire t/n LL114848 all fixtures fittings plant machinery apparatus goods and materials by way of assignment the benefit of the landlord to and in the lease,all insurances in respect of the property,and agreements for sale,all existing and future easements,all shares rights benefits and advantages any copyrights of any plans in connection with the property,the benefit of bonds and licences the benefit of any guarantees by way of floating charge all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 ott 1997
    Consegnato il 04 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,100,000.00 plus interest due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Premises and buildings at st johns park bracebridge heath lincoln on the south side of canwick avenue t/n ll 114848.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 04 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 03 apr 1997
    Consegnato il 09 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (being a principal sum of £3,000,000) to the chargee under the terms of a facility agreement of even date ("the facility agreement")
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Onroerdend Goed Maatschappij Kasteellei N.V.
    Transazioni
    • 09 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 03 apr 1997
    Consegnato il 09 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a fee agreement of even date ("the fee agreement")
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Compania Naviera El Sarten S.A.
    Transazioni
    • 09 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 mag 1995
    Consegnato il 16 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a hellaby hall hellaby lane hellaby rotherham south yorkshire t/no's SYK102910 SYK296454 and SYK285611. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 mag 1995
    Consegnato il 10 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,200,000 due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a sale agreement
    Brevi particolari
    All that f/h proerty k/a hellaby hall hellaby lane hellaby rotherham south yorkshire t/no's SYK102910 syk 296454 and SYK285611 with all fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Family Assurance Friendly Society Limited
    Transazioni
    • 10 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Convertible debenture
    Creato il 17 feb 1994
    Consegnato il 23 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • John Taylor Sanderson
    Transazioni
    • 23 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Convertible debenture
    Creato il 30 lug 1993
    Consegnato il 16 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company to the chargees under the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • David Goldman and Graham Wylie
    Transazioni
    • 16 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 18 dic 1992
    Consegnato il 08 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property at appledore building northumbria way, killingworth, newcastle upon tyne and a floating charge over. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock Building Society
    Transazioni
    • 08 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge and assignment
    Creato il 08 set 1992
    Consegnato il 23 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or norstead leisure limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All details of an agreement dated 10TH october 1991 re garden festival site,liverpool,merseyside and an assignment over all moneys under the agreement (see doc ref M589C for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 set 1991
    Consegnato il 17 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the east of swinley rd., Ascot, berks. T/no. Bk 201675.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 25 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 29 gen 1990
    Consegnato il 13 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of funds totalling sterling pounds 6,100,000 invested now or in the future with barclays de zoete wedd limited.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 19 giu 1989
    Consegnato il 28 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Scottish & Newcastle Breweries PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable charge
    Creato il 16 dic 1988
    Consegnato il 20 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 133,846 and all other moneys due or to become due from the company and/or selltime limited or any subsidiary to the chargee or any associated trading or subsidiary company
    Brevi particolari
    L/H units 100, 101, 1/79 and 1/80 metro centre gateshead tyne and wear.
    Persone aventi diritto
    • Scottish & Newcastle Breweris PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable charge
    Creato il 16 nov 1988
    Consegnato il 19 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 216,154 and all other moneys due or to become due (including moneys due for goods supplied) from the company and/or selltime limited or any subsidiary to scottish & newcastle breweries PLC or any associated at trading subsidiary as defined in the deed
    Brevi particolari
    L/H units 100, 101, 1/79 and 1/80 metro centre gateshead tyne and wear.
    Persone aventi diritto
    • Scottish & Newcastle Breweries PLC
    Transazioni
    • 19 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 07 nov 1988
    Consegnato il 14 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 29 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 giu 1988
    Consegnato il 28 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 354,000 and all other monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and/or the trading companies' (as defined) under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Scottish & Newcastle Breweries PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 22 dic 1986
    Consegnato il 07 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 29 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TOMORROWS LEISURE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 mar 2012Data di scioglimento
    21 ott 2005Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew David Conquest
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praticante
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Joseph Peter Francis Mclean
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praticante
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0