BELMONT OPTICAL LIMITED

BELMONT OPTICAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBELMONT OPTICAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01961218
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BELMONT OPTICAL LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova BELMONT OPTICAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    47 Joel Lane
    SK14 5JZ Hyde
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BELMONT OPTICAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PENNINE OPTICAL GROUP LIMITED27 feb 199527 feb 1995
    PENNINE OPTICAL LIMITED15 gen 199015 gen 1990
    SOVEREIGN OPTICAL LIMITED19 nov 198519 nov 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di BELMONT OPTICAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per BELMONT OPTICAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da 21 Brackley Street Farnworth Bolton BL4 9DS England a 47 Joel Lane Hyde SK14 5JZ in data 23 ott 2020

    1 pagineAD01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    9 pagineMA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Simon Clyde Haydn Williams come segretario in data 03 apr 2020

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Peter Lawrence Cowan come amministratore in data 03 apr 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Clyde Haydn Williams come amministratore in data 03 apr 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Philip Anthony Newton come amministratore in data 03 apr 2020

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019

    11 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Manchester Road Heaton Norris Stockport SK4 1TX a 21 Brackley Street Farnworth Bolton BL4 9DS in data 22 nov 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Simon Clyde Haydn Williams come amministratore in data 13 mar 2019

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name09 ago 2018

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 01 ago 2018

    RES15

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Lawrence Cowan il 10 feb 2017

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 ago 2015

    Stato del capitale al 27 ago 2015

    • Capitale: GBP 108,233
    • Capitale: USD 1,462.03
    SH01

    Chi sono gli amministratori di BELMONT OPTICAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NEWTON, Philip Anthony
    Joel Lane
    SK14 5JZ Hyde
    47
    England
    Amministratore
    Joel Lane
    SK14 5JZ Hyde
    47
    England
    United KingdomBritish250974400001
    HIGHAM, Maria Gabrielle
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    Segretario
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    British56630460001
    HORNBY, Alan
    58 Garners Lane
    Davenport
    SK3 8QT Stockport
    Cheshire
    Segretario
    58 Garners Lane
    Davenport
    SK3 8QT Stockport
    Cheshire
    British96367080001
    O'SULLIVAN, John
    1 Manchester Road
    Heaton Norris
    SK4 1TX Stockport
    Segretario
    1 Manchester Road
    Heaton Norris
    SK4 1TX Stockport
    155663970001
    VICARY, Gary Kevin
    Desborough Manorial Road
    Parkgate
    CH64 6QN Neston
    Wirral
    Segretario
    Desborough Manorial Road
    Parkgate
    CH64 6QN Neston
    Wirral
    British18943850005
    WILLIAMS, Simon Clyde Haydn
    Brackley Street
    Farnworth
    BL4 9DS Bolton
    21
    England
    Segretario
    Brackley Street
    Farnworth
    BL4 9DS Bolton
    21
    England
    176154070001
    COWAN, Peter Lawrence
    Brackley Street
    Farnworth
    BL4 9DS Bolton
    21
    England
    Amministratore
    Brackley Street
    Farnworth
    BL4 9DS Bolton
    21
    England
    EnglandBritish141897770003
    ELDRIDGE, Malcolm James Eldridge
    Stanton 6 Lukes Yeat
    St Neot
    PL14 6NG Liskeard
    Cornwall
    Amministratore
    Stanton 6 Lukes Yeat
    St Neot
    PL14 6NG Liskeard
    Cornwall
    British54219730001
    HIGHAM, Maria Gabrielle
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    Amministratore
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    British56630460001
    HILLMAN, Peter John
    62 Micawber Way
    Newlands Spring
    CM1 4UE Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    62 Micawber Way
    Newlands Spring
    CM1 4UE Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish86069010001
    HORNBY, Alan
    58 Garners Lane
    Davenport
    SK3 8QT Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    58 Garners Lane
    Davenport
    SK3 8QT Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish96367080001
    LEHMANN, Frederick Allan
    5 Chartridge Close
    Arkley
    EN5 3LX Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Chartridge Close
    Arkley
    EN5 3LX Barnet
    Hertfordshire
    British75525310001
    NIGHTINGALE, Bernard
    976 Warwick Road
    Copt Heath
    B91 3HN Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    976 Warwick Road
    Copt Heath
    B91 3HN Solihull
    West Midlands
    British2994970001
    NIGHTINGALE, Charles
    34 Carpenter Road
    Edgbaston
    B15 2JH Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    34 Carpenter Road
    Edgbaston
    B15 2JH Birmingham
    West Midlands
    British5183860003
    PERERA, David
    6 The Grange
    36 Edgeley Road
    SK3 9NQ Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    6 The Grange
    36 Edgeley Road
    SK3 9NQ Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish127795280001
    PERERA, Kenneth
    West View
    Peak Forest
    SK17 8EW Buxton
    Derbyshire
    Amministratore
    West View
    Peak Forest
    SK17 8EW Buxton
    Derbyshire
    British30140880001
    PLUMMER, Alan
    3 Hillbrook Road
    Bramhall
    SK7 2BT Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    3 Hillbrook Road
    Bramhall
    SK7 2BT Stockport
    Cheshire
    British3215730001
    TAYLOR, Desmond Francis
    9 Florence Close
    CV9 1HR Atherstone
    Warwickshire
    Amministratore
    9 Florence Close
    CV9 1HR Atherstone
    Warwickshire
    British38196160001
    VICARY, Gary Kevin
    Desborough Manorial Road
    Parkgate
    CH64 6QN Neston
    Wirral
    Amministratore
    Desborough Manorial Road
    Parkgate
    CH64 6QN Neston
    Wirral
    British18943850005
    WILLIAMS, Simon Clyde Haydn
    Brackley Street
    Farnworth
    BL4 9DS Bolton
    21
    England
    Amministratore
    Brackley Street
    Farnworth
    BL4 9DS Bolton
    21
    England
    EnglandEnglish256296590001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BELMONT OPTICAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Peter Lawrence Cowan
    Joel Lane
    SK14 5JZ Hyde
    47
    England
    06 apr 2016
    Joel Lane
    SK14 5JZ Hyde
    47
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    BELMONT OPTICAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 06 apr 2001
    Consegnato il 18 apr 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a navigation mill manchester road heaton norris stockport t/no: GM319249. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 nov 1999
    Consegnato il 15 nov 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 21 dic 1998
    Consegnato il 23 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ago 1995
    Consegnato il 15 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or united optical industries limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H pennine house manchester road stockport t/no.GM319249 and all buildings and other structures and goodwill. Fixed and floating charges over all plant machinery and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 ago 1995
    Consegnato il 12 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See charge particulars form for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 20 lug 1990
    Consegnato il 26 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 gen 1987
    Consegnato il 05 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 133 starkey street heywood lancs.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 04 giu 1986
    Consegnato il 10 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1986Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0