BELMONT OPTICAL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BELMONT OPTICAL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01961218 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BELMONT OPTICAL LIMITED?
- Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova BELMONT OPTICAL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 47 Joel Lane SK14 5JZ Hyde England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BELMONT OPTICAL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PENNINE OPTICAL GROUP LIMITED | 27 feb 1995 | 27 feb 1995 |
| PENNINE OPTICAL LIMITED | 15 gen 1990 | 15 gen 1990 |
| SOVEREIGN OPTICAL LIMITED | 19 nov 1985 | 19 nov 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BELMONT OPTICAL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per BELMONT OPTICAL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 21 Brackley Street Farnworth Bolton BL4 9DS England a 47 Joel Lane Hyde SK14 5JZ in data 23 ott 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorandum e Statuto | 9 pagine | MA | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Clyde Haydn Williams come segretario in data 03 apr 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Lawrence Cowan come amministratore in data 03 apr 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Clyde Haydn Williams come amministratore in data 03 apr 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Philip Anthony Newton come amministratore in data 03 apr 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Manchester Road Heaton Norris Stockport SK4 1TX a 21 Brackley Street Farnworth Bolton BL4 9DS in data 22 nov 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Clyde Haydn Williams come amministratore in data 13 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Lawrence Cowan il 10 feb 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di BELMONT OPTICAL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWTON, Philip Anthony | Amministratore | Joel Lane SK14 5JZ Hyde 47 England | United Kingdom | British | 250974400001 | |||||
| HIGHAM, Maria Gabrielle | Segretario | Eastcote 25 Delahays Road WA15 8DS Hale Cheshire | British | 56630460001 | ||||||
| HORNBY, Alan | Segretario | 58 Garners Lane Davenport SK3 8QT Stockport Cheshire | British | 96367080001 | ||||||
| O'SULLIVAN, John | Segretario | 1 Manchester Road Heaton Norris SK4 1TX Stockport | 155663970001 | |||||||
| VICARY, Gary Kevin | Segretario | Desborough Manorial Road Parkgate CH64 6QN Neston Wirral | British | 18943850005 | ||||||
| WILLIAMS, Simon Clyde Haydn | Segretario | Brackley Street Farnworth BL4 9DS Bolton 21 England | 176154070001 | |||||||
| COWAN, Peter Lawrence | Amministratore | Brackley Street Farnworth BL4 9DS Bolton 21 England | England | British | 141897770003 | |||||
| ELDRIDGE, Malcolm James Eldridge | Amministratore | Stanton 6 Lukes Yeat St Neot PL14 6NG Liskeard Cornwall | British | 54219730001 | ||||||
| HIGHAM, Maria Gabrielle | Amministratore | Eastcote 25 Delahays Road WA15 8DS Hale Cheshire | British | 56630460001 | ||||||
| HILLMAN, Peter John | Amministratore | 62 Micawber Way Newlands Spring CM1 4UE Chelmsford Essex | United Kingdom | British | 86069010001 | |||||
| HORNBY, Alan | Amministratore | 58 Garners Lane Davenport SK3 8QT Stockport Cheshire | England | British | 96367080001 | |||||
| LEHMANN, Frederick Allan | Amministratore | 5 Chartridge Close Arkley EN5 3LX Barnet Hertfordshire | British | 75525310001 | ||||||
| NIGHTINGALE, Bernard | Amministratore | 976 Warwick Road Copt Heath B91 3HN Solihull West Midlands | British | 2994970001 | ||||||
| NIGHTINGALE, Charles | Amministratore | 34 Carpenter Road Edgbaston B15 2JH Birmingham West Midlands | British | 5183860003 | ||||||
| PERERA, David | Amministratore | 6 The Grange 36 Edgeley Road SK3 9NQ Stockport Cheshire | England | British | 127795280001 | |||||
| PERERA, Kenneth | Amministratore | West View Peak Forest SK17 8EW Buxton Derbyshire | British | 30140880001 | ||||||
| PLUMMER, Alan | Amministratore | 3 Hillbrook Road Bramhall SK7 2BT Stockport Cheshire | British | 3215730001 | ||||||
| TAYLOR, Desmond Francis | Amministratore | 9 Florence Close CV9 1HR Atherstone Warwickshire | British | 38196160001 | ||||||
| VICARY, Gary Kevin | Amministratore | Desborough Manorial Road Parkgate CH64 6QN Neston Wirral | British | 18943850005 | ||||||
| WILLIAMS, Simon Clyde Haydn | Amministratore | Brackley Street Farnworth BL4 9DS Bolton 21 England | England | English | 256296590001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BELMONT OPTICAL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Peter Lawrence Cowan | 06 apr 2016 | Joel Lane SK14 5JZ Hyde 47 England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
BELMONT OPTICAL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Creato il 06 apr 2001 Consegnato il 18 apr 2001 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a navigation mill manchester road heaton norris stockport t/no: GM319249. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 04 nov 1999 Consegnato il 15 nov 1999 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 21 dic 1998 Consegnato il 23 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the finance documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 04 ago 1995 Consegnato il 15 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or united optical industries limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H pennine house manchester road stockport t/no.GM319249 and all buildings and other structures and goodwill. Fixed and floating charges over all plant machinery and other chattels. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 ago 1995 Consegnato il 12 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari See charge particulars form for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 20 lug 1990 Consegnato il 26 lug 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 21 gen 1987 Consegnato il 05 feb 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H 133 starkey street heywood lancs. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 giu 1986 Consegnato il 10 giu 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0