KAMNS PAPER MILL LIMITED

KAMNS PAPER MILL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKAMNS PAPER MILL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01961343
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KAMNS PAPER MILL LIMITED?

    • fabbricazione di carta e cartone (17120) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova KAMNS PAPER MILL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KPMG LLP
    15 Canada Square Canary Wharf
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KAMNS PAPER MILL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KAMNS LIMITED07 mar 198607 mar 1986
    PARX LIMITED19 nov 198519 nov 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di KAMNS PAPER MILL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per KAMNS PAPER MILL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per KAMNS PAPER MILL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 lug 2015

    4 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB a 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL in data 12 apr 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 lug 2014

    4 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:court order replacement liquidators
    24 pagineLIQ MISC OC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 lug 2013

    4 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * Waterside Road Hamilton Industrial Park Leicester LE5 1TZ* in data 01 ago 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 15 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 ago 2012

    Stato del capitale al 01 ago 2012

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    23 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 15 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    24 pagineAA

    Nomina di Mrs Angela Nicola Helm-Davies come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Olswang Cosec Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di KAMNS PAPER MILL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HELM-DAVIES, Angela Nicola
    c/o Intertissue Ltd
    Baglan Energy Park
    Briton Ferry
    SA11 2HZ Neath
    Brunel Way
    West Glamorgan
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Intertissue Ltd
    Baglan Energy Park
    Briton Ferry
    SA11 2HZ Neath
    Brunel Way
    West Glamorgan
    United Kingdom
    158834340001
    LAZZARESCHI, Luigi
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    ItalyItalian152916320001
    STEFANI, Emi
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    ItalyItalian152916330001
    TEJANI, Amirali Sharif
    12 Manor Road Extension
    LE2 4FF Oadby
    Leicester
    Segretario
    12 Manor Road Extension
    LE2 4FF Oadby
    Leicester
    British13188380003
    WARING, Ian David
    131 Heath Lane
    Earl Shilton
    LE9 7PF Leicester
    Segretario
    131 Heath Lane
    Earl Shilton
    LE9 7PF Leicester
    British36785940001
    OLSWANG COSEC LIMITED
    High Holborn
    WC1V 6XX London
    90
    Segretario
    High Holborn
    WC1V 6XX London
    90
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4051235
    83864780002
    DHARAMSHI, Shirazali Sharif
    83 Gartree Road
    Oadby
    LE2 2FD Leicester
    Amministratore
    83 Gartree Road
    Oadby
    LE2 2FD Leicester
    EnglandBritish13188390003
    DHARAMSHI TEJANI, Sultanali Sharif
    32 Forest House Lane Kingswood
    Leicester Forest East
    LE3 3NU Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    32 Forest House Lane Kingswood
    Leicester Forest East
    LE3 3NU Leicester
    Leicestershire
    Ugandan-British13386960004
    SHARIF DHARAMJMI TEJANT, Nazirali
    18 Eden Road
    Oadby
    LE2 4JP Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    18 Eden Road
    Oadby
    LE2 4JP Leicester
    Leicestershire
    Ugandan-British13386950001
    TEJANI, Amirali Sharif
    12 Manor Road Extension
    LE2 4FF Oadby
    Leicester
    Amministratore
    12 Manor Road Extension
    LE2 4FF Oadby
    Leicester
    United KingdomBritish13188380003
    TEJANI, Karim Sharif Dharamshi
    6 Beechwood Close
    Evington
    LE5 6SY Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    6 Beechwood Close
    Evington
    LE5 6SY Leicester
    Leicestershire
    British13188400002
    TEJANI, Salim Sharif Dharamshi
    Ashwood House Tompions End
    SG18 9EN Biggleswade
    Bedfordshire
    Amministratore
    Ashwood House Tompions End
    SG18 9EN Biggleswade
    Bedfordshire
    EnglandBritish13188410003
    TEJANI, Salim Sharif Dharamshi
    Manor Cottage Ampthill Road
    Beadlow
    SG17 5PJ Shefford
    Bedfordshire
    Amministratore
    Manor Cottage Ampthill Road
    Beadlow
    SG17 5PJ Shefford
    Bedfordshire
    British13188410001

    KAMNS PAPER MILL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deposit agreement
    Creato il 27 feb 2009
    Consegnato il 03 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re - kamns paper mills limited and numbered 01464033 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattels mortgage
    Creato il 08 feb 2008
    Consegnato il 19 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Plant no PM1 beloit 3.2M paper mill, two incoming pump conveyors two pulpers five various blend chests for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transazioni
    • 19 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 15 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 08 feb 2008
    Consegnato il 19 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transazioni
    • 19 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 15 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off
    Creato il 24 ott 2005
    Consegnato il 04 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 24 ott 2005
    Consegnato il 01 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 01 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An omnibus letter of set-off
    Creato il 22 apr 2004
    Consegnato il 28 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 apr 2003
    Consegnato il 16 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 16 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 25 feb 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Of the company whatsoever and wheresoever present and future). Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 feb 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H interest in premises being part of the paper mill building hilltop road hamilton industrial park leicester.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 22 feb 2002
    Consegnato il 22 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 beloit walmsley paper mill as described in schedule to chattels mortgage or any part thereof.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 22 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 06 nov 2001
    Consegnato il 09 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sum of £10,000,000 and all other sums due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One new complete kamns PM2 paper tissue production line manufactured by andritz ag in accordance with contract/order no 32-46461/0 to be located at the borrower's premises at waterside road, hamilton industrial park, leicester. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 26 mag 1994
    Consegnato il 26 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One new nuova red horizontal stacker serial no. Hs 810 93986/sx. One new nuova red leg gatherer serial no. Lg 810 93979/sx. One new nuova red drum forming system serial no. Df 810 93981/sx.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 26 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 06 nov 1989
    Consegnato il 07 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One new nuova red italiana machine model number ar/el 85 s-st to produce disposable babydiapers serial no. X89045/5 (please see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 07 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 09 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 26 giu 1989
    Consegnato il 29 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    A first fixed charge over machine model nr/AN86 s/no 88221/5 meltex hot melt applicator for silicon paper s/no CO3580588.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 29 lug 1989Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 19 ott 1988
    Consegnato il 21 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 new three folding section (for full details see form 395).
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 21 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 09 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 19 ott 1988
    Consegnato il 21 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 new two gun flexi spray system with twin drum unloaders serial no: AA87K03231 model no: pc-10601307.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 21 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 09 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 19 ott 1988
    Consegnato il 21 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 new gr 42-1 hotmelt unit serial no:C05670788 together with ancillary equipment and 1 new ka 400 chiller unit. 1 new special barrier coating frame.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 21 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 09 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 29 dic 1987
    Consegnato il 06 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 new md-e fully contoured and elasticated diaper machine serial no 20302025 together with ancillary equipment.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 06 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 09 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 mag 1986
    Consegnato il 23 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stocks, shares & other securities. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 19 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    KAMNS PAPER MILL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 nov 2015Data di scioglimento
    17 lug 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0