MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED

MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMILTON KEYNES CITY BUS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01963446
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Daw Bank
    Stockport
    SK3 0DU Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MILTON KEYNES CITYBUS LIMITED22 nov 198522 nov 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mag 2012

    Stato del capitale al 03 mag 2012

    • Capitale: GBP 1,992,947
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2011

    4 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    7 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Michael John Vaux il 10 ott 2009

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2009

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Leslie Brian Warneford il 01 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Colin Brown il 15 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Michael John Vaux il 07 ott 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 apr 2008

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 apr 2007

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Segretario
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant85970020003
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director49771140004
    CLAYTON, Michael Bruce
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    Segretario
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    BritishAccountant27890500005
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Segretario
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    BritishAccountant70283550001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Segretario
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    BritishAccountant70283550001
    HOUSTON, Guy Alan
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    BritishAccountant54321810002
    SANKEY, John Frederick
    124 Clarence Avenue
    NN2 6PA Northampton
    Segretario
    124 Clarence Avenue
    NN2 6PA Northampton
    British7542050001
    SMITH, Richard George
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    Segretario
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    BritishFinancial Director1817090001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Segretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Segretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    BritishManager54184420002
    ATKINSON, Gary
    36 Plumstead Avenue
    Bradwell Common
    MK13 8AF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    36 Plumstead Avenue
    Bradwell Common
    MK13 8AF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director15789380001
    CLAYTON, Michael Bruce
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    BritishAccountant27890500005
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Amministratore
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    BritishCompany Director47574960002
    CONROY, Michael James
    65 Lowlands Close
    NN3 5EX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    65 Lowlands Close
    NN3 5EX Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director26775900001
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Amministratore
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritishExecutive Director1436830002
    EDEN, Philip Brookes, Mr.
    27 Williams Close
    CB7 4FQ Ely
    Cambridgeshire
    Amministratore
    27 Williams Close
    CB7 4FQ Ely
    Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector63838120003
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Amministratore
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant70283550001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Amministratore
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant70283550001
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Amministratore
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritishFinance Director61722690002
    GUNDEL, Jeffrey
    72 Lowick Court
    Moulton
    NN3 7TY Northampton
    Amministratore
    72 Lowick Court
    Moulton
    NN3 7TY Northampton
    BritishCompany Director37176070001
    HARGREAVES, John Banks
    2 Capel Close
    Summertown
    OX2 7LA Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    2 Capel Close
    Summertown
    OX2 7LA Oxford
    Oxfordshire
    BritishCompany Director4955990001
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Amministratore
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    EnglandBritishCompany Director2268190002
    HOUSTON, Guy Alan
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    BritishAccountant54321810002
    MERRYWEATHER, Paul Anthony
    42 Great Lane
    Reach
    CB5 0JF Cambridge
    Cambs
    Amministratore
    42 Great Lane
    Reach
    CB5 0JF Cambridge
    Cambs
    BritishChairman/Director10329770001
    MOORS, Michael Eric
    5 Ridge House
    Ridge House Drive, Festival Park
    ST1 5SJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    5 Ridge House
    Ridge House Drive, Festival Park
    ST1 5SJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director26926420002
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    Amministratore
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant73518280001
    SANKEY, John Frederick
    124 Clarence Avenue
    NN2 6PA Northampton
    Amministratore
    124 Clarence Avenue
    NN2 6PA Northampton
    BritishCompany Director7542050001
    SMITH, Richard George
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    Amministratore
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    BritishFinancial Director1817090001
    WARNER, Barry Alfred
    20 East Butterfield Court
    Goldenash
    NN3 8JG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    20 East Butterfield Court
    Goldenash
    NN3 8JG Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector37224390001
    WILLIAMS, Stephen James
    28 Barnstaple Close
    NN3 3BH Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    28 Barnstaple Close
    NN3 3BH Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director84510700001
    WINTER, John Michael
    7 London Road
    Great Shelford
    CB2 5DB Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    7 London Road
    Great Shelford
    CB2 5DB Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director19625590001

    MILTON KEYNES CITY BUS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Single debenture
    Creato il 29 apr 1993
    Consegnato il 04 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 08 mag 1992
    Consegnato il 27 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 ref M720C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 08 ago 1989
    Consegnato il 10 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £702224.21 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    782 aseol marcedes benz minibuses. (See doc. For full details).
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 10 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 17 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 set 1988
    Consegnato il 14 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 17 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security amendment
    Creato il 04 mag 1988
    Consegnato il 06 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Amending the terms of a debenture dated 7.8.87.
    Brevi particolari
    The rights & interests conferred on and granted by mckb to spel by clause 3 of the debenture. (See doc. For full details).
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific Euro Finance (U.K.) Limited.
    Transazioni
    • 06 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 17 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Convertible debenture
    Creato il 26 apr 1988
    Consegnato il 29 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £300,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or generalouter limited to the chargee under or in respect "the indebtedness" (as that term is defined in the charge)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capitalbuildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Pmt Limited
    Transazioni
    • 29 apr 1988Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 ago 1987
    Consegnato il 20 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sale agreement a title purchase agreement, a guarantee and debenture cash dated 7 8 87 (as defined) and this charge a any account whatsoever
    Brevi particolari
    1/. all the company's right, title and interest in and to the account with security pacific national bank, N.A. or such other account or accounts as may be established by the company pursuant to the provisions of the hire purchase agreement or the debenture and in and to all the moneys that has from time to time accured or is accruing therein which form time to time constitute, the balance standing to the credit of the charged account and 2/. floating charge the whole of the company's undertaking and all property and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific Euro Finance (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 20 ago 1987Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0