NESTOR PRIMECARE SERVICES LIMITED

NESTOR PRIMECARE SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNESTOR PRIMECARE SERVICES LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01963820
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di NESTOR PRIMECARE SERVICES LIMITED?

    • Attività di medicina generale (86210) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova NESTOR PRIMECARE SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Central Sqaure
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NESTOR PRIMECARE SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HEALTHCALL SERVICES LIMITED09 mag 199009 mag 1990
    AIR CALL MEDICAL SERVICES LIMITED23 dic 198523 dic 1985
    SUREFINE LIMITED22 nov 198522 nov 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di NESTOR PRIMECARE SERVICES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2017
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2018
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per NESTOR PRIMECARE SERVICES LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al28 ago 2019
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma11 set 2019
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al28 ago 2018
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per NESTOR PRIMECARE SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 apr 2025

    26 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 apr 2024

    26 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 apr 2023

    27 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 apr 2022

    29 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 apr 2021

    28 pagineLIQ03

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineNDISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    27 pagineAM22

    Dichiarazione della proposta rivista dell'amministratore

    30 pagineAM09

    Revisione delle proposte dell'amministratore

    28 pagineAM08

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    33 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    18 pagineAM16

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    19 pagineCVA4

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    19 pagineAM02

    Cessazione della carica di David Collison come segretario in data 22 feb 2019

    1 pagineTM02

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    55 pagineAM03

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Cavendish House Lakhpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX England a Central Sqaure 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 11 dic 2018

    2 pagineAD01

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    2 pagineSH10

    Risoluzioni

    Resolutions
    45 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di NESTOR PRIMECARE SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWN, Carl Michael
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Sqaure
    West Yorkshire
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Sqaure
    West Yorkshire
    EnglandBritishAccountant232841280001
    SINGH, Narinder
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Sqaure
    West Yorkshire
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Sqaure
    West Yorkshire
    EnglandBritishChief Executive193406470001
    TRAUTWEIN, Caspaar Friedrich, Dr
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Sqaure
    West Yorkshire
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Sqaure
    West Yorkshire
    GermanyGermanMerchant249111890001
    COLLISON, David
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Sqaure
    West Yorkshire
    Segretario
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Sqaure
    West Yorkshire
    204253920001
    COLLISON, David
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    Segretario
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    British34835160001
    DAVIES, John
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    158562450001
    ETHERINGTON, Robin John
    28 Sworder Close
    LU3 4BJ Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    28 Sworder Close
    LU3 4BJ Luton
    Bedfordshire
    British17841000001
    HAYNES, Victoria
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    British182412280001
    ROBERTS THOMAS, Caroline Emma
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    Segretario
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    BritishCompany Secretary76032450005
    SPINK, David
    2 Monkswood
    West End Silverstone
    NN12 8TG Towcester
    Northamptonshire
    Segretario
    2 Monkswood
    West End Silverstone
    NN12 8TG Towcester
    Northamptonshire
    BritishFinance Director34518140003
    STRINGER, Andrew Paul
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    171546390001
    BATCHELOR, Lance Henry Lowe
    Sandgate
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Sandgate
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Chief Executive194139680001
    BOOTY, Stephen Martin
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    Amministratore
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    EnglandBritishDirector147928010001
    BURNS, Robert Ian
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector36584260002
    DIXON, Patrick John Vibart
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director50086040003
    DUMMER, Marilyn Pauline
    9 Little Meadow
    Loughton
    MK5 8EH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    9 Little Meadow
    Loughton
    MK5 8EH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishDirector44601830001
    DUN, Andrew Fredrick, Doctor
    33 Green End
    MK18 3NT Granborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    33 Green End
    MK18 3NT Granborough
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director85855780001
    EBERT, Daniel, Dr
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    Amministratore
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    GermanyGermanCompany Director204964720001
    ELLIS, Martyn Anthony
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Finance Director95749550002
    GIBSON, Darryn Stanley
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomNew ZealanderCompany Director177930490001
    GOODSELL, John Andrew
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director51490510002
    HENCHEY, Maurice David
    Hamels Mead
    Braughing
    SG9 9ND Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Hamels Mead
    Braughing
    SG9 9ND Buntingford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director17815290002
    HOWARD, Nigel Peter
    86 Rewley Road
    OX1 2RQ Oxford
    Amministratore
    86 Rewley Road
    OX1 2RQ Oxford
    BritishCompany Director124147420001
    HOWARD, Stuart Michael
    Enbrook Park
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Enbrook Park
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director160271430001
    IVERS, John Joseph
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    Amministratore
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director77692980002
    JACKSON, Mark Bentley
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director61300600003
    JEWITT, Justin Allan Spaven, Professor
    The Stables
    89 Aston End Road Aston
    SG2 7EY Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Stables
    89 Aston End Road Aston
    SG2 7EY Stevenage
    Hertfordshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive39701670001
    KAIPER-HOLMES, Cornelius, Dr
    Arc-En-Ciel Hazel Old Lane
    Hensall
    DN14 0QA Goole
    North Humberside
    Amministratore
    Arc-En-Ciel Hazel Old Lane
    Hensall
    DN14 0QA Goole
    North Humberside
    BritishCompany Director28474050001
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishGroup Finance Director51084280003
    LYSAGHT MASON, Wayne Vernon
    Fairview 21 Green End
    Braughing
    SG11 2PG Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    Fairview 21 Green End
    Braughing
    SG11 2PG Ware
    Hertfordshire
    BritishDirector45878860002
    MACHIN, Joanne
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    Amministratore
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    EnglandBritishSales And Marketing Director236304960001
    MASON, Catherine Lois
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    Amministratore
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    EnglandBritishCompany Director224233880001
    PAGE, Stephen Robert
    Oak Tree House
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Oak Tree House
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director257896700001
    PARROTT, Timothy Malcolm
    The Old Bake House
    NN12 7QD Potterspury
    Northants
    Amministratore
    The Old Bake House
    NN12 7QD Potterspury
    Northants
    BritishCompany Director67800510001
    PETHICK, Timothy Mark
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director172197670001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NESTOR PRIMECARE SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Helenus Limited
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    06 apr 2016
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House England And Wales
    Numero di registrazione5305856
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per NESTOR PRIMECARE SERVICES LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    28 ago 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    NESTOR PRIMECARE SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 nov 2015
    Consegnato il 04 dic 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 04 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Rent deposit deed
    Creato il 12 mar 2010
    Consegnato il 17 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,750.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The sum of £1,750.00 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robert Bygrave Grimmond and Richard Keith Grimmond
    Transazioni
    • 17 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 16 nov 2009
    Consegnato il 23 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 23 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 08 mar 2006
    Consegnato il 22 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The present and future shares being all shares in nestor primecare services limited and its interest in all shares stocks debentures bonds or other securities and investments and all fixed plant machinery goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 22 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed
    Creato il 29 lug 1998
    Consegnato il 06 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined) under or pursuant to the secured documents (as defined) or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 30 mar 1998
    Consegnato il 17 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and obligations and liabilities due or to become due from the company and each group company (as defined) to hcms limited ("the parent") under or pursuant to the secured documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hcms Limited
    Transazioni
    • 17 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 30 mar 1998
    Consegnato il 15 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined) under or pursuant to the secured documents (as defined) or on account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mag 1994
    Consegnato il 15 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 giu 1992
    Consegnato il 25 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    7 the hide market,west street,bristol.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Camposite guarantee & debenture
    Creato il 02 mar 1990
    Consegnato il 08 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from healfhcall group PLC to the chargee, under the terms of the facility agreement dated 20/12/89 and this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandand/or the Banks as Defined
    Transazioni
    • 08 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 23 feb 1990
    Consegnato il 07 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from healfhcall group PLC. To the chargee, under terms of the mezzanire loan agreement and the security documents' as defined
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Mezzanire Lenders
    • Intermediate Capital Group Limited
    Transazioni
    • 07 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 31 ott 1986
    Consegnato il 05 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future book debts including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 31 ott 1986
    Consegnato il 05 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as 16 watson place, st. Judes. Plymouth.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 31 ott 1986
    Consegnato il 05 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as 59, walter road, swansea.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 31 ott 1986
    Consegnato il 05 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property knwon as 85, jesmand road, newcastle.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 31 ott 1986
    Consegnato il 05 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as 72, queens road, crayden.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1986Registrazione di un'ipoteca

    NESTOR PRIMECARE SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 mag 2018Data della riunione per approvare il CVA
    30 nov 2018Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Martin Charles Armstrong
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Praticante
    Allen House 1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    James E Patchett
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Praticante
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    2
    DataTipo
    30 nov 2018Inizio dell'amministrazione
    14 apr 2020Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Anthony Steven Barrell
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    3
    DataTipo
    14 apr 2020Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    David Matthew Hammond
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0