ASHBOURNE LEASING LIMITED

ASHBOURNE LEASING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASHBOURNE LEASING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01964687
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASHBOURNE LEASING LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ASHBOURNE LEASING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASHBOURNE LEASING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MANOR NURSING HOMES LIMITED25 nov 198525 nov 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASHBOURNE LEASING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ASHBOURNE LEASING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 24 lug 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 gen 2012

    Stato del capitale al 18 gen 2012

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    18 pagineAA

    Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di William Mcleish come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 27 set 2009

    15 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per William James Buchan il 27 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Neil Midmer il 27 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Kamma Foulkes il 27 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per William David Mcleish il 27 ott 2009

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di ASHBOURNE LEASING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    COPELAND, Robert Nigel
    Cherry Tree Cottage Hearns Lane
    Gallows Tree Common
    RG4 9DE Reading
    Berkshire
    Segretario
    Cherry Tree Cottage Hearns Lane
    Gallows Tree Common
    RG4 9DE Reading
    Berkshire
    British5690880001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Segretario
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Segretario
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Segretario
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Segretario
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304800001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Segretario
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    MURRAY, Karen Mary
    Willerton Trumpsgreen Road
    GU25 4HH Virginia Water
    Surrey
    Segretario
    Willerton Trumpsgreen Road
    GU25 4HH Virginia Water
    Surrey
    British27248850001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Amministratore
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish66559170001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BRADEEN, Chester Howard
    Barberry Cottage Cheapside Road
    SL5 7QR Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Barberry Cottage Cheapside Road
    SL5 7QR Ascot
    Berkshire
    Us Citizen44958580001
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    COPELAND, Robert Nigel
    Cherry Tree Cottage Hearns Lane
    Gallows Tree Common
    RG4 9DE Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Cherry Tree Cottage Hearns Lane
    Gallows Tree Common
    RG4 9DE Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish5690880001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    British14241020001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Amministratore
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Amministratore
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Amministratore
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Amministratore
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Amministratore
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    LAWRENCE, Stephen John
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    Amministratore
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    EnglandBritish5579020001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Amministratore
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New Zealander5076900001
    MCINTEER, Warren Hill
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100131200001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New Zealander80392940001
    MOSS, John Rhys
    Bryn Y Gwynt
    Graigfechan
    LL15 2EY Ruthin
    Clwyd
    Amministratore
    Bryn Y Gwynt
    Graigfechan
    LL15 2EY Ruthin
    Clwyd
    British36148600001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Amministratore
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004

    ASHBOURNE LEASING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 13 mar 1995
    Consegnato il 16 mar 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land adjoining new hall farm chester high road gayton t/n ms 273427 together with all buildings and fixtures .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Single debenture
    Creato il 02 nov 1992
    Consegnato il 13 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 dic 1990
    Consegnato il 13 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from exceler health care limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that f/hold property k/as new hall manor chester high road neston cheshire. Title no. Ms 233145 together with all buildings and fixtures thereon assignment of the goodwill of the business carried on at the property the full benefit of all present and future licences in connection with the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • U C B Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 dic 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 dic 1985
    Consegnato il 02 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    New hall grayton wirral merseyside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 30 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0