MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED

MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01970801
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tower Bridge House
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TAY HOMES (YORKSHIRE) LIMITED28 ago 199228 ago 1992
    TAY HOMES (NORTHERN) LIMITED30 set 198630 set 1986
    TAY HOMES (YORKSHIRE) LIMITED07 mar 198607 mar 1986
    ALVERHILL LIMITED13 dic 198513 dic 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dettagli del direttore cambiati per Gavin Russell il 01 dic 2015

    3 pagineCH01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 dic 2015

    4 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 dic 2014

    5 pagine4.68

    Cessazione della carica di Mark David Peters come amministratore in data 14 set 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Gavin Russell come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stuart Leadill come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Fourth Floor 130 Wilton Road London SW1V 1LQ* in data 18 dic 2013

    4 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    Nomina di Stuart Kenneth Leadill come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul Goldsmith come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 giu 2013

    Stato del capitale al 05 giu 2013

    • Capitale: GBP 372,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    32 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2010

    15 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Paul William Goldsmith il 01 apr 2010

    3 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BNOMS LIMITED
    Fourth Floor
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    Segretario
    Fourth Floor
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    67896020002
    PRYCE, Colin Michael
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Amministratore
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    EnglandBritish,Jamaican67971010001
    RUSSELL, Gavin
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Amministratore
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United KingdomBritish188396180003
    BARTLETT, Paul Eugene
    Flat 3 Stable Mews
    Hillside Road
    AL1 3QR St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    Flat 3 Stable Mews
    Hillside Road
    AL1 3QR St Albans
    Hertfordshire
    British54206450002
    EVANS, Stephen Geoffrey
    The Orchard
    58 Huddersfield Road Skelmanthorpe
    HD8 9AS Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    The Orchard
    58 Huddersfield Road Skelmanthorpe
    HD8 9AS Huddersfield
    West Yorkshire
    British3621900001
    MCDONALD, Ross Edward
    5b Vermont Road
    Upper Norwood
    SE19 3SR London
    Segretario
    5b Vermont Road
    Upper Norwood
    SE19 3SR London
    British44092870001
    BANCROFT, Paul Andrew
    40 Cleveland Road
    Southwoodford
    E18 2AL London
    Amministratore
    40 Cleveland Road
    Southwoodford
    E18 2AL London
    EnglandBritish99625640001
    BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Amministratore
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British983300008
    COLES, John Howard
    7 Victoria Terrace
    Headingley
    LS6 4BE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    7 Victoria Terrace
    Headingley
    LS6 4BE Leeds
    West Yorkshire
    British4462250001
    DOUGLASS, Peter William
    Bleak House 1 School Lane
    Upper Poppleton
    YO2 6JS York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Bleak House 1 School Lane
    Upper Poppleton
    YO2 6JS York
    North Yorkshire
    British4462240001
    EVANS, Stephen Geoffrey
    The Orchard
    58 Huddersfield Road Skelmanthorpe
    HD8 9AS Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Orchard
    58 Huddersfield Road Skelmanthorpe
    HD8 9AS Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish3621900001
    GALL, Terence
    232 Bradford Road
    WF1 2BA Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    232 Bradford Road
    WF1 2BA Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish37553160002
    GOLDSMITH, Paul William
    Fourth Floor
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    Amministratore
    Fourth Floor
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    EnglandBritish28639100003
    HENDERSON, Ronald Andrew
    Frankleigh
    Cedar Road
    GU22 0JH Woking
    Surrey
    Amministratore
    Frankleigh
    Cedar Road
    GU22 0JH Woking
    Surrey
    United KingdomBritish2980400001
    HOWARD, Claire Lucie Mary
    Norsebury Cottage Winchester Road
    Micheldever
    SO21 3DG Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Norsebury Cottage Winchester Road
    Micheldever
    SO21 3DG Winchester
    Hampshire
    British54519060001
    KNIGHT, Dawn Elizabeth
    2 Temperance Street
    AL3 4QA St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Temperance Street
    AL3 4QA St Albans
    Hertfordshire
    British19935890001
    LEADILL, Stuart Kenneth
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Amministratore
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United KingdomBritish36282500001
    MARKHAM, Neal
    BD18
    Amministratore
    BD18
    British29216140001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Cob Cottage
    Shore Road
    PO18 8HZ Bosham
    West Sussex
    Amministratore
    Cob Cottage
    Shore Road
    PO18 8HZ Bosham
    West Sussex
    EnglandBritish34131020003
    MCDONALD, Ross Edward
    5b Vermont Road
    Upper Norwood
    SE19 3SR London
    Amministratore
    5b Vermont Road
    Upper Norwood
    SE19 3SR London
    British44092870001
    MCGLONE, Roy Vickers
    11 Pearces Orchard
    Fairmile
    RG9 2LF Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    11 Pearces Orchard
    Fairmile
    RG9 2LF Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    British45248290001
    MURRAY, Stuart Fraser
    29 Binden Road
    W12 9RJ London
    Amministratore
    29 Binden Road
    W12 9RJ London
    British675720001
    PARLOUR, John Leslie
    Red Roof Tithe Barn Lane
    Bardsey
    LS17 9DX Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Red Roof Tithe Barn Lane
    Bardsey
    LS17 9DX Leeds
    West Yorkshire
    British2494160001
    PEARSON, Christopher Rait O'Neill
    Shirley House, 5 West Walks
    DT1 1RE Dorchester
    Dorset
    Amministratore
    Shirley House, 5 West Walks
    DT1 1RE Dorchester
    Dorset
    British60365730001
    PETERS, Mark David
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Amministratore
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United KingdomBritish192348430001
    STUBBS, Norman Alan
    East Chevin Road
    LS21 3DD Otley
    The Stables
    West Yorkshire
    Amministratore
    East Chevin Road
    LS21 3DD Otley
    The Stables
    West Yorkshire
    EnglandBritish1692650001
    TYSON, Christopher Roberto
    Pemberley Gregorys Meadow
    Stourscombe
    PL15 9QZ Launceston
    Cornwall
    Amministratore
    Pemberley Gregorys Meadow
    Stourscombe
    PL15 9QZ Launceston
    Cornwall
    British4093740001

    MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 24 ago 1992
    Consegnato il 27 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and premises k/a 20 middlecroft road stourton grange middleton leeds west yorkshire t/n WYK254776. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 ago 1992
    Consegnato il 22 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 14 ruffa lane pickering ryedale north yorkshire t/NNYK65314.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 ago 1992
    Consegnato il 22 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 6 beck hill buttershaw north bierley bradford west yorkshire t/n WYK113069. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ago 1992
    Consegnato il 21 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 24 rayner avenue bradford west yorkshire and registered under t/n WYK287817. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 ago 1992
    Consegnato il 20 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 28 teall court ossett wakefield west yorkshire t/n WYK89112. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 ago 1992
    Consegnato il 20 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 1 cedar close scawby glanford humberside. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 lug 1992
    Consegnato il 21 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fr/h land and blds--8 ringley meadows bempton,east yorkshire.t/no.hs 144650 fixed charge--all covenants and rights the plant,machinery,fixtures,fittings furniture....etc. See form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 lug 1992
    Consegnato il 09 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 10 victoria avenue filey scarborough north yorkshire. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 lug 1992
    Consegnato il 14 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a sunnybank road mirfield west yorkshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 lug 1992
    Consegnato il 07 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 178 wortley road high green sheffield south yorkshire t/n SYK430. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 lug 1992
    Consegnato il 07 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 9 highfield road north thorseby east lindsey lincolnshire. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 lug 1992
    Consegnato il 04 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 10 fern road walkley sheffield south yorkshire t/n YWE22948. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 lug 1992
    Consegnato il 04 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 20 kingsdale avenue drighlington leeds west yorkshire. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1992
    Consegnato il 02 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold land and blds--91 carr rd, calverley,leeds,west yorkshire. T/no.wyk 417667. fixed charge--the benefit of all covenants and rights......the plant, machinery,fixtures,fittings,furniture, equipment,implements and utensils now and in the future.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 giu 1992
    Consegnato il 30 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land and blds--8 haigh side driverothwell,leeds,west yorkshire.t/no.wyk 114469 fixed charge--the benefit of all covenants and rights,the plant,machinery fixtures,fittings,furniture,equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ago 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 giu 1992
    Consegnato il 30 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land and blds--29 nab wood terrace,shipley,bradford,west yorkshire t/no.wyk 42418 fixed charge--the benefit of all covenants and rights,the plant,machineryfixtures,fittings,furniture,equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 giu 1992
    Consegnato il 20 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h land and premises k/a 20 southwold scarborough N. yorks. Inc: fixtures and fittings (see form 395).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 giu 1992
    Consegnato il 20 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h land and buildings k/a 34 siver royd road wortley leeds W.yorks title no: WYK413215 inc: fixtures and fittings (see form 395).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 giu 1992
    Consegnato il 19 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and blds--5 mere view gardens scarborough,north yorkshire fixed charge--all covenants and rights...,..the plant,machinery,fixtures,fittings,furniture...etc.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 mag 1992
    Consegnato il 22 mag 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 5 manor close long street topcliffe hambleton north yorkshire t/n NYK54632. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 06 mag 1992
    Consegnato il 08 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 50 lidget lane skelmanthorpe kirklees west yorkshire t/n WYK75281. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 mag 1992
    Consegnato il 08 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 140 quaker lane cleckheaton kirklees west yorkshire t/n wyk 335778. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 mag 1992
    Consegnato il 07 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 21 ackroyd street morley leeds west yorkshire t/n wyk 84243. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 apr 1992
    Consegnato il 29 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    3 pumping station cottages,dunswell lanebeverley,humberside.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 apr 1992Registrazione di un'ipoteca
    • 19 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 1992
    Consegnato il 08 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings k/a 6 carr lane tankersley barnsley south yorkshire t/n SYK41703. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 dic 2013Inizio della liquidazione
    05 gen 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Roderick John Weston
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0