MARK TWO DISTRIBUTORS LIMITED

MARK TWO DISTRIBUTORS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARK TWO DISTRIBUTORS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01971017
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARK TWO DISTRIBUTORS LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova MARK TWO DISTRIBUTORS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MARK TWO DISTRIBUTORS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HOPKINSON MARK TWO LIMITED09 giu 198809 giu 1988
    MARK TWO LIMITED10 feb 198610 feb 1986
    TENDHOUSE LIMITED13 dic 198513 dic 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARK TWO DISTRIBUTORS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per MARK TWO DISTRIBUTORS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    20 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 nov 2018

    21 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 nov 2017

    17 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Stephen Heys come amministratore in data 11 gen 2017

    2 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 nov 2016

    18 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 nov 2015

    41 pagine2.24B

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 mag 2015

    42 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    13 pagine2.16B

    Risultato della riunione dei creditori

    2 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    59 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Bury Road Industrial Estate Bury Road Breightmet Bolton Greater Manchester BL2 6AZ United Kingdom a The Chancery 58 Spring Gardens Manchester M2 1EW in data 05 dic 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    20 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Stanmore House 64-68 Blackburn Street Radcliffe Manchester M26 2JS* in data 25 mar 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 22 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 feb 2014

    Stato del capitale al 20 feb 2014

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    17 pagineAA

    Nomina di Mr Antony Wood come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Stephen Heys come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Michael Duggleby come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Philip Holmstrom come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Nicholas Hopkinson come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di MARK TWO DISTRIBUTORS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DUGGLEBY, Michael
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    Amministratore
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    EnglandBritishCompany Director116697060002
    HOLMSTROM, Philip David
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    Amministratore
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    United KingdomBritishFinance Director79768640003
    JENKINSON, Paul
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    Amministratore
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    EnglandBritishSales Director107462090003
    WOOD, Antony
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    Amministratore
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    EnglandBritishCompany Director179731420001
    CROWTHER, David
    2 Brookbank Close
    Middleton
    M24 1FH Manchester
    Lancashire
    Segretario
    2 Brookbank Close
    Middleton
    M24 1FH Manchester
    Lancashire
    BritishCompany Secretary107533770001
    HOLMSTROM, Philip David
    Stanmore House
    64-68 Blackburn Street
    M26 2JS Radcliffe
    Manchester
    Segretario
    Stanmore House
    64-68 Blackburn Street
    M26 2JS Radcliffe
    Manchester
    BritishFinance Director79768640003
    HOPKINSON, Christopher John
    10 Crown Gardens
    Edgworth
    BL7 0QZ Bolton
    Lancashire
    Segretario
    10 Crown Gardens
    Edgworth
    BL7 0QZ Bolton
    Lancashire
    British23139780001
    SMID, John Anthony
    30 Greenhill Road
    BL8 2LL Bury
    Lancashire
    Segretario
    30 Greenhill Road
    BL8 2LL Bury
    Lancashire
    British23139770001
    ASKEW, Gary Michael
    18 Danesway
    Heath Charnock
    PR7 4EY Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    18 Danesway
    Heath Charnock
    PR7 4EY Chorley
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director65282160002
    BAILEY, Mark Richard
    5 Springside Cottages
    Belmont Road Bromley Cross
    BL7 9QU Bolton
    Amministratore
    5 Springside Cottages
    Belmont Road Bromley Cross
    BL7 9QU Bolton
    BritishDirector46377750001
    DONNELLY, Philip Joseph
    56 Crimple Meadows
    Pannal
    HG3 1EN Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    56 Crimple Meadows
    Pannal
    HG3 1EN Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector1970700001
    DWYER, Paul
    12 The Paddock
    BB5 3AB Oswaldtwistle
    Lancashire
    Amministratore
    12 The Paddock
    BB5 3AB Oswaldtwistle
    Lancashire
    EnglandBritishPurchasing Director115375690001
    HEYS, Stephen
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    Amministratore
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    United KingdomBritishCompany Director69215330001
    HOLT, Peter James Robert
    8 Lansdowne Drive
    Worsley
    M28 7HG Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    8 Lansdowne Drive
    Worsley
    M28 7HG Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritishSales Director63980700002
    HOPKINSON, Christopher John
    Stanmore House
    64-68 Blackburn Street
    M26 2JS Radcliffe
    Manchester
    Amministratore
    Stanmore House
    64-68 Blackburn Street
    M26 2JS Radcliffe
    Manchester
    EnglandBritishDirector23139780002
    HOPKINSON, Nicholas Peter
    Stanmore House
    64-68 Blackburn Street
    M26 2JS Radcliffe
    Manchester
    Amministratore
    Stanmore House
    64-68 Blackburn Street
    M26 2JS Radcliffe
    Manchester
    United KingdomBritishDirector5700730007
    HOPKINSON, Peter John
    The Barns Tower Drive
    Chapeltown Road
    BL7 0HG Turton
    Bolton
    Amministratore
    The Barns Tower Drive
    Chapeltown Road
    BL7 0HG Turton
    Bolton
    BritishDirector6102860001
    HOWE, Alan Richard
    Stanmore House
    64-68 Blackburn Street
    M26 2JS Radcliffe
    Manchester
    Amministratore
    Stanmore House
    64-68 Blackburn Street
    M26 2JS Radcliffe
    Manchester
    BritishCommercial Director62970980001
    LEAMAN, Peter Harry
    Snug House
    1 Snug Lane Hepworth
    HD9 1RP Huddersfield
    Amministratore
    Snug House
    1 Snug Lane Hepworth
    HD9 1RP Huddersfield
    United KingdomBritishDirector76423940001
    MCGARVEY, Julian Edward
    Inglenook
    Jagger Green Lane
    HX4 9DE Halifax
    Yorkshire
    Amministratore
    Inglenook
    Jagger Green Lane
    HX4 9DE Halifax
    Yorkshire
    EnglandBritishDirector127717900001
    SMID, John Anthony
    30 Greenhill Road
    BL8 2LL Bury
    Lancashire
    Amministratore
    30 Greenhill Road
    BL8 2LL Bury
    Lancashire
    BritishDirector23139770001
    YASKIN, Anthony Stephen
    53 Bury Road
    Tottington
    BL8 3EU Bury
    Lancashire
    Amministratore
    53 Bury Road
    Tottington
    BL8 3EU Bury
    Lancashire
    AmericanDirector42200040002

    MARK TWO DISTRIBUTORS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 mag 2007
    Consegnato il 31 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited (Security Holder)
    Transazioni
    • 31 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 09 mag 2007
    Consegnato il 15 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 28 apr 2000
    Consegnato il 29 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 29 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge (all assets)
    Creato il 28 apr 2000
    Consegnato il 29 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 29 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 19 gen 2000
    Consegnato il 21 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 15 nov 1995
    Consegnato il 18 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 20 feb 1991
    Consegnato il 22 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings in ripley drive normanton industrial estate normanton west yorkshire t/no wyk 77288.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 20 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 17 mar 1986
    Consegnato il 03 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including book debts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 20 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    MARK TWO DISTRIBUTORS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 nov 2014Inizio dell'amministrazione
    10 nov 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Muncaster
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EQ Manchester
    Praticante
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EQ Manchester
    Phillip Francis Duffy
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praticante
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    2
    DataTipo
    12 dic 2019Data di scioglimento
    10 nov 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Liquidatore proposto
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Phillip Francis Duffy
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Liquidatore proposto
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praticante
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Phillip Francis Duffy
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praticante
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0