WYEVALE GARDEN CENTRES HOLDINGS LIMITED

WYEVALE GARDEN CENTRES HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWYEVALE GARDEN CENTRES HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01972554
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WYEVALE GARDEN CENTRES HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova WYEVALE GARDEN CENTRES HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Teneo Financial Advisory Limited The Colmore Building
    20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WYEVALE GARDEN CENTRES HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE GARDEN CENTRE GROUP HOLDINGS LIMITED17 lug 200917 lug 2009
    WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED20 giu 200620 giu 2006
    WYEVALE GARDEN CENTRES PLC09 feb 198709 feb 1987
    WGC LIMITED29 set 198629 set 1986
    CHARCO SIXTY LIMITED18 dic 198518 dic 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di WYEVALE GARDEN CENTRES HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per WYEVALE GARDEN CENTRES HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    16 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Financial Advisory Limited the Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT in data 20 mag 2023

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mag 2022

    14 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 22 feb 2022

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 07 set 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mag 2021

    16 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mag 2021

    16 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 30 giu 2021

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1), Second Floor, Room 2-3, Great West House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9DF England a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 14 lug 2020

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 mag 2020

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Cessazione di Garden Centre Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 mag 2020

    1 paginePSC07

    Notifica di Trellis Holdco Limited come persona con controllo significativo il 06 mag 2020

    2 paginePSC02

    Cessazione della carica di Laura Harradine-Greene come segretario in data 07 mag 2020

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 apr 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 dic 2018

    41 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 23 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1) Second Floor, Room 2-3, Great West House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9DF England a Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1), Second Floor, Room 2-3, Great West House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9DF in data 07 gen 2020

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF England a Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1) Second Floor, Room 2-3, Great West House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9DF in data 06 gen 2020

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Anthony Gerald Jones come amministratore in data 06 dic 2019

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 06 nov 2019

    • Capitale: GBP 1.00
    5 pagineSH19

    Chi sono gli amministratori di WYEVALE GARDEN CENTRES HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MACLACHLAN, Richard John
    The Colmore Building
    20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    Amministratore
    The Colmore Building
    20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    EnglandBritish255019700001
    BOURLET, Mary Elizabeth
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    213000000002
    HARRADINE-GREENE, Laura
    Second Floor, Room 2-3, Great West House
    Great West Road
    TW8 9DF Brentford
    Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1),
    Middlesex
    England
    Segretario
    Second Floor, Room 2-3, Great West House
    Great West Road
    TW8 9DF Brentford
    Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1),
    Middlesex
    England
    242722790001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    British72128340003
    JONES, Anthony David
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    Segretario
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    British73622510001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Segretario
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    British8690590001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Segretario
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    British76162020001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    173093900001
    WARD, Elizabeth Ann
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    205422630001
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish124019940001
    BRIGDEN, Peter
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish195802400001
    CRAMPHORN, Anthony Michael St John
    10 Bradford Street
    CM7 6AS Braintree
    Essex
    Amministratore
    10 Bradford Street
    CM7 6AS Braintree
    Essex
    British41770720001
    DOWLEY, Laurence Justin
    8 Norland Square
    W11 4PX London
    Amministratore
    8 Norland Square
    W11 4PX London
    EnglandBritish10456080002
    EVANS, Brian Arnold
    The Vern
    Marden
    HR1 3EX Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    The Vern
    Marden
    HR1 3EX Hereford
    Herefordshire
    British8690600001
    FAVELL, Gary Alan
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    Amministratore
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    United KingdomBritish107699240001
    HEWITT, Robert John
    9 Sycamore Croft
    Madley
    HR2 9LR Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    9 Sycamore Croft
    Madley
    HR2 9LR Hereford
    Herefordshire
    British15486070001
    HEWITT, Robert John
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    Amministratore
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    United KingdomBritish15486070002
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Amministratore
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritish606430001
    JAMES, George Geoffrey
    Brombil House Brombil
    Margam
    SA13 2SR Port Talbot
    West Glam
    Amministratore
    Brombil House Brombil
    Margam
    SA13 2SR Port Talbot
    West Glam
    British4455790001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish72128340003
    JONES, Anthony Gerald
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish212265950002
    KING, Justin Matthew
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish213157990001
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish124967710001
    LEWIS PRATT, Andrew
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordhire
    Amministratore
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordhire
    British60050050003
    LIVINGSTON, William Andrew
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish111439220001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    WalesBritish1470180001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish206428840001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    British8690590001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish162853840001
    OSBORN, Adrian Humphrey Austen
    The Castle
    Munsley
    HR8 2SF Ledbury
    Herefordshire
    Amministratore
    The Castle
    Munsley
    HR8 2SF Ledbury
    Herefordshire
    United KingdomBritish34440210001
    PIERPOINT, David Julian
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    Amministratore
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    EnglandBritish138653690001
    PITCHER, Stephen John
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish138172490001
    POWELL, Christopher Charles
    Woodside Court
    Cranham
    GL4 8HB Gloucester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Woodside Court
    Cranham
    GL4 8HB Gloucester
    Gloucestershire
    EnglandBritish34697350001
    PRICE, Glyn John
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    Amministratore
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    United KingdomBritish73470720001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Amministratore
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    EnglandBritish76162020001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WYEVALE GARDEN CENTRES HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Second Floor, Room 2-3, Great West House
    Great West Road
    TW8 9DF Brentford
    Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1)
    Middlesex
    England
    06 mag 2020
    Second Floor, Room 2-3, Great West House
    Great West Road
    TW8 9DF Brentford
    Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1)
    Middlesex
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07942904
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Garden Centre Holdings Limited
    Syon Park, London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    England
    06 apr 2016
    Syon Park, London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Scotland
    Numero di registrazioneSc292695
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WYEVALE GARDEN CENTRES HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 set 2017
    Consegnato il 28 set 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All current and future material property and material intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the debenture registered by this form MR01 (the "debenture") and including, amongst others, property at newport pagnell road, northampton, NN4 6HP with title number NN347760 and salisbury road, andover, hampshire, SP11 7DN with title number HP633933. For more details please refer to the debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 28 set 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 ago 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 27 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 mar 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 30 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 set 2017
    Consegnato il 26 set 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Material property - registered land:. Woodlands garden centre, ashby road, stapleton, leicestershire, LE9 8JE - title no.: LT477088;. For more details please refer to the charging instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 26 set 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 ago 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 27 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 mar 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 30 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 apr 2016
    Consegnato il 26 apr 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Lechlade garden centre, warrens cross, lechlade, GL7 3DP - title no.: GR376604.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 26 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 dic 2015
    Consegnato il 11 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land on the east side of great lime road, high gosforth park, gosforth, newcastle upon tyne - title no.: TY86589; land adjoining peter barratt's garden centre, great lime road, newcastle upon tyne - title no.: TY389531; land and buildings on the north side of huntingdon road, wyton - title no.: CB230727.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 11 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental legal charge
    Creato il 24 apr 2012
    Consegnato il 04 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The mortgaged properties inclusive of woodlands nurseries ashby road stapleton leicestershire LT101511, LT234032, LT304484, LT349041, LT94078, LT167170 and LT234033. Worlds end aylesbury road wendover aylesbury BM101941. Bridgemere (trading), bridgemere, nr. Nantwich, cheshire CH451498, SL65805, CH326461, CH106092, CH498502 and CH450380 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 dic 2015Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 17 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security accession deed
    Creato il 24 apr 2012
    Consegnato il 03 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Woodlands nurseries ashby road, stapleton, leicestershire t/nos LT101511, LT234032, LT304484, LT349041, LT94078, LT167170 and LT234033. Bridgemere (trading) bridgemere, nr nantwich, cheshire t/nos CH451498, SL65805, CH326461, CH106092, CH498502 and CH450380. World's end aylesbury road, wendover, aylesbury t/no BM101941. (For details of further properties charged, please refer to the form MG01); fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties ("the Security Agent")
    Transazioni
    • 03 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 dic 2015Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 17 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 24 apr 2012
    Consegnato il 27 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £587.50 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sums from time to time standing to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • Express Hand Car Wash Limited
    Transazioni
    • 27 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 feb 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental deed
    Creato il 11 apr 2012
    Consegnato il 27 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The subjects at unit 4 and forecourt, the gate centre, great west road, brentford, middlesex; the gross rental income, all plant and machinery; by way of floating charge all unattached plant, machinery, chattels and goods in connection with the mortgaged property.. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 31 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed
    Creato il 30 mar 2012
    Consegnato il 03 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Plant centre and retain shop within westonbirt arboretum westonbirt gloucestershire all rights and interest in and to the gross rental income all plant and machinery floating charge all unattached plant machinery chattels and goods see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed to an original security agreement dated 24 february 2009 and
    Creato il 07 mar 2012
    Consegnato il 09 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The garden centre at blue bloar lane, sprowston, norfolk; the gross rental income, plant and machinery; by way of floating charge all unattached plant, machinery, chattels and goods at the mortgaged property. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed
    Creato il 02 dic 2011
    Consegnato il 05 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H thames hall yard at syon park garden centre see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 24 nov 2011
    Consegnato il 01 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Premises at queenswood garden centre wellington hereford t/no HE21629 and all rights to any gross rental income in respect of the property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 01 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 19 ago 2011
    Consegnato il 05 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Flowerland garden centre netherhampton road netherhampton t/no WT233792,upminster garden centre nags head lane upminster t/no EGL374942,hillview nursery seven hills road walton on thames t/no's SY476486 and SY476487 (for further details of property charged please refer to form MG01). First fixed charge all plant and machinery,gross rental income see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland as Security Agent
    Transazioni
    • 05 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed
    Creato il 24 feb 2011
    Consegnato il 02 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H wimborne road west stapehill wimborne dorset all its rights under the lease,all its rights and interest in and to the gross rental income see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 02 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 01 mar 2010
    Consegnato il 10 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H bicester garden centre oxford road bicester t/no:ON278791. F/h blooms garden centre low road bressingham diss t/no:NK230284. L/h st mellons garden centre cardiff t/no:CYM370489 please see image for further charges plant and machinery gross rental income see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 10 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 01 mar 2010
    Consegnato il 10 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its rights in respect of its intercompany loan receivables see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 10 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 22 dic 2009
    Consegnato il 12 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights in respect of the intercompany loan receivables see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 12 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 22 dic 2009
    Consegnato il 07 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property at southport road, ulnes, walton, leyland, preston t/no LAN41441. F/h property at bridgemere garden world, bridgemere, nr nantwich, cheshire t/no CH326461. F/h property at bridgemere garden world, bridgemere, nr nantwich, cheshire t/no SL65805. (For further deails of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 07 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Shares mortgage
    Creato il 19 nov 2009
    Consegnato il 27 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All investments see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The “Security Trustee”)
    Transazioni
    • 27 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 24 feb 2009
    Consegnato il 04 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H newport road albrighton wolverhamton west midlands t/no SL102624,f/h horsham road alfold cranleigh surrey t/no SY369348,f/h green lane timerpley altrincham cheshire t/no GM734670 ( for further details of property charged please refer to form 395) investments,plant and machinery,credit balances see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The “Security Agent”)
    Transazioni
    • 04 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 20 lug 2006
    Consegnato il 26 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re wyevale garden centres limited current account, account number 60713538. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession to a debenture
    Creato il 23 giu 2006
    Consegnato il 07 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from a chargor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property being woodlands ashby road stapleton leicestershire, wyevale garden centre newport pagnell road northampton, land on the north east side of wendover road worlds end weston turville for details of further properties charged, please refer to form 395,. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent for the Finance Parties(Security Agent)
    Transazioni
    • 07 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 13 ott 2003
    Consegnato il 14 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £25,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The monies held in a rent deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wrotham Park Settled Estates
    Transazioni
    • 14 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 08 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Homelands retail park springfield chelmsford essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1993
    Consegnato il 09 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leander nursery cattlegate road crews hill enfield l/b of enfield t/n MX386890.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WYEVALE GARDEN CENTRES HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 mag 2020Inizio della liquidazione
    12 set 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Roland Browne
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praticante
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Clare Boardman
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0