MCHAWK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMCHAWK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01976036
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MCHAWK LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MCHAWK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MCHAWK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MCHAWK LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MCHAWK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Gate House Turnpike Road High Wycombe Buckinghamshire HP12 3NR a Bdo Llp 125 Colmore Row Birmingham B3 3SD in data 04 feb 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 21 gen 2015

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 gen 2015

    Stato del capitale al 23 gen 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 gen 2014

    Stato del capitale al 21 gen 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr. Michael Andrew Lonnon come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Carr come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Peter Anthony Carr il 31 mar 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Colin Richard Clapham il 28 mar 2011

    2 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da * 80 New Bond Street London W1S 1SB United Kingdom* in data 30 mar 2011

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Christopher Carney come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 2 Piries Place Horsham West Sussex RH12 1EH England

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Carney il 09 apr 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Peter Anthony Carr il 01 apr 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di MCHAWK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Other135438270002
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish113503830003
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish34521340004
    BASSETT, Brian John
    The Pipings
    Dorsington Lane
    Pebworth
    Worcestershire
    Segretario
    The Pipings
    Dorsington Lane
    Pebworth
    Worcestershire
    British34075530001
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    Segretario
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    British130306120001
    HASTIE, Nicola Amanda Eleanor
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    Segretario
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    British76844970003
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Segretario
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British120602100002
    PHILLIPS, James
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    British8364990001
    WHITE, Ian Michael
    4 Garden Close
    Knowle
    B93 9QF Solihull
    West Midlands
    Segretario
    4 Garden Close
    Knowle
    B93 9QF Solihull
    West Midlands
    British10543120002
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish125216670001
    CARR, Peter Anthony
    551 Avebury Boulevard
    MK9 3DR Milton Keynes
    Beech House
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    551 Avebury Boulevard
    MK9 3DR Milton Keynes
    Beech House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish130306120001
    GROVE, Eric William
    The Rye House
    Catesby Lane Lapworth
    B94 5QY Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    The Rye House
    Catesby Lane Lapworth
    B94 5QY Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish632880001
    HASTIE, Nicola Amanda Eleanor
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    Amministratore
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    British76844970003
    JENKINS, Stephen Adrian
    Kingsview
    Manor Road
    HP10 8JA Penn
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Kingsview
    Manor Road
    HP10 8JA Penn
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish49738660003
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Amministratore
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritish120602100002
    MCCALLUM, Graeme Reid
    The Poplars
    Whinfield Road Dodford
    B61 9BG Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    The Poplars
    Whinfield Road Dodford
    B61 9BG Bromsgrove
    Worcestershire
    United KingdomBritish152856250001
    MILLS, Stanley
    Whitegates
    Wixford
    B49 6DA North Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    Whitegates
    Wixford
    B49 6DA North Alcester
    Warwickshire
    British573140004
    MURRIN, Jonathan Charles
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    British115863170001
    OSBORNE, Trevor
    Pinewood House
    Nine Mile Ride
    RG11 3EA Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Pinewood House
    Nine Mile Ride
    RG11 3EA Wokingham
    Berkshire
    British35561510001
    PEACOCK, Raymond Anthony
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    Amministratore
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    United KingdomBritish75750250002
    PHILLIPS, James
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    British8364990001
    REDFERN, Peter Timothy
    5 Broadfield Road
    OX5 1UL Yarnton
    Oxfordshire
    Amministratore
    5 Broadfield Road
    OX5 1UL Yarnton
    Oxfordshire
    British74208670003
    SUTCLIFFE, Ian Calvert
    Windlesham Lodge
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Windlesham Lodge
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritish112534590002
    WHITE, Ian Michael
    4 Garden Close
    Knowle
    B93 9QF Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    4 Garden Close
    Knowle
    B93 9QF Solihull
    West Midlands
    British10543120002
    WHITEHORN, John Andrew
    6 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    6 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish6750840001

    MCHAWK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 23 nov 1989
    Consegnato il 13 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildings lying to the north east side of westminster bridge road lambeth greater london. Fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures/fittings.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 14 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 ott 1988
    Consegnato il 26 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a building contract dated 11-1-88 and a letter dated 15-10-87
    Brevi particolari
    L/Hold - 234 and 258-272 (even) old ford road, 1-13 royal victor place and land at rear of 236-256 (even) and 274-290 (even) old ford road, london E3 fixed charge over fixed machinery, buildings, erections and other fixtures & fittings.
    Persone aventi diritto
    • Cavendish Constructors PLC
    Transazioni
    • 26 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 14 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 mag 1988
    Consegnato il 05 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 106-120 even baylis road lambeth greater manchester title no sgl 24672 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 05 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 14 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 feb 1988
    Consegnato il 25 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H, 197 cottenham park road wimbledon merton greater london title no sy 82525 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures and fittings.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 25 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 14 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 13 gen 1988
    Consegnato il 20 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land known as 234 and 258/272 (even numbers only) old ford road and 1-13 royal victor place and land at the rear of 236-256 (even) and 274-290 (even) old ford road, london E3. Floating charge over all fixed and movable plant machinery implements utensils furniture and equipment building erections and other fixtures and fittings.
    Persone aventi diritto
    • Cavendish Constructions PLC
    Transazioni
    • 20 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1987
    Consegnato il 14 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at rear of atlantic house upper richmond road wardsworth greater london fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 14 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1987
    Consegnato il 14 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at rear of 59 upper richmond road wandsworth greater london fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 14 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1987
    Consegnato il 14 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 49 upper richmond road, wandsworth, greater london. Title no 406944 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1987
    Consegnato il 14 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at rear of 134 coombe lane west kingston upon thames greater london. Title no sgl 496376 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 14 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1987
    Consegnato il 14 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 31 & 33 gwendolen avenue putney, london borough of wandsworth title nos sgl 109483 & sgl 101913 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1987
    Consegnato il 14 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 51/57 upper richmond road wandsworth greater london, title no 176453 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and quipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 14 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1987
    Consegnato il 14 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a guildford works charlwood road, putney wandsworth greater london. Title no LN153344 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 14 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1987
    Consegnato il 14 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 191 & 195 cotterham park road, wimbledon merton greater london title no sgl 473850 and sy 322838 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 14 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 set 1987
    Consegnato il 06 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 06 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 14 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 mar 1987
    Consegnato il 19 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/Hold - land known as site e, church street old isleworth hounslow london title no mx 448429 and part title no's mx 428303, mx 387323 and mx 244465.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 19 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 08 lug 1986
    Consegnato il 15 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any associated company to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Legal mortgage over freehold land north street and church street old isleworth middlesex title no ngl 553109 fixed and floating charges over all plant, machinery, fixtures fittings the floating charge being A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 15 lug 1986Registrazione di un'ipoteca

    MCHAWK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 gen 2016Data di scioglimento
    21 gen 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praticante
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0