WATES CONSTRUCTION LIMITED

WATES CONSTRUCTION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWATES CONSTRUCTION LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01977948
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di WATES CONSTRUCTION LIMITED?

    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni

    Dove si trova WATES CONSTRUCTION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Wates House
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WATES CONSTRUCTION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ZOOMVIEW LIMITED15 gen 198615 gen 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di WATES CONSTRUCTION LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per WATES CONSTRUCTION LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al09 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma23 giu 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al09 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per WATES CONSTRUCTION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di David Keir Ewart Morgan come amministratore in data 03 feb 2025

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Christopher John Symeonides come amministratore in data 03 feb 2025

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul Chandler come amministratore in data 31 dic 2024

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Christopher Griffin il 01 ago 2024

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Steffan Battle come amministratore in data 01 mag 2024

    2 pagineAP01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2023

    70 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Paul Christopher Griffin come amministratore in data 24 mag 2023

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Emily Tate come amministratore in data 24 mag 2023

    2 pagineAP01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2022

    70 pagineAA

    Cessazione della carica di David Owen Allen come amministratore in data 16 ago 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2021

    60 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2020

    56 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Chandler il 06 gen 2021

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    10 pagineMA

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2019

    54 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2018

    41 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Chandler il 17 gen 2019

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Philip Michael Wainwright come amministratore in data 03 dic 2018

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di WATES CONSTRUCTION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WAINWRIGHT, Philip Michael
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    Segretario
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    253306080001
    BATTLE, Steffan
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director322699390001
    BEECHEY, Stephen James
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    EnglandBritishGroup Strategy Director217470550001
    BUNCH, Helen Patricia
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Strategic Director128426840001
    GRIFFIN, Paul Christopher
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    EnglandIrishCommercial Director269689390002
    POTTER, Simon James
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    EnglandBritishGroup Commercial Director150179180001
    ROWAN, Paul Campbell
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    EnglandBritishGroup Hr Director201421830001
    SYMEONIDES, Christopher John
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    EnglandBritishCommercial Director77108470001
    TATE, Emily
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director309779030001
    WAINWRIGHT, Philip Michael
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United KingdomBritishChief Financial Officer203980190001
    ALLEN, David Owen
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    Segretario
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    203991070001
    DAVIES, David Huw
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United Kingdom
    BritishChief Financial Officer147566800001
    DAVIES, David Huw
    Little Croft
    Blackmoor
    BS40 5HJ Lower Langford
    North Somerset
    Segretario
    Little Croft
    Blackmoor
    BS40 5HJ Lower Langford
    North Somerset
    BritishCompany Director147566800001
    GAME, Ashley
    118 Hydethorpe Road
    SW12 0JD London
    Segretario
    118 Hydethorpe Road
    SW12 0JD London
    British67502580002
    HOULTON, Jonathan Charles Bennett
    2 Corney Reach Way
    Chiswick
    W4 2TU London
    Segretario
    2 Corney Reach Way
    Chiswick
    W4 2TU London
    British70905760002
    HOULTON, Jonathan Charles Bennett
    2 Corney Reach Way
    Chiswick
    W4 2TU London
    Segretario
    2 Corney Reach Way
    Chiswick
    W4 2TU London
    British70905760002
    MACKIE, William Graham
    91 Foxley Lane
    CR8 3HP Purley
    Surrey
    Segretario
    91 Foxley Lane
    CR8 3HP Purley
    Surrey
    British4549700001
    SAREEN, Narinder Singh
    Beechcorner
    Hazelwood Lane
    CR5 3QZ Chipstead
    Surrey
    Segretario
    Beechcorner
    Hazelwood Lane
    CR5 3QZ Chipstead
    Surrey
    British38379440001
    STYANT, Terry Ann
    Heath View
    KT24 5EA East Horsley
    Rossett Ghyll
    Surrey
    England
    Segretario
    Heath View
    KT24 5EA East Horsley
    Rossett Ghyll
    Surrey
    England
    BritishGroup General Counsel131686260001
    ALLEN, David Owen
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United KingdomBritishChief Financial Officer113636480001
    BAKER, Kenneth George
    3 Marlhurst
    TN8 6LN Edenbridge
    Kent
    Amministratore
    3 Marlhurst
    TN8 6LN Edenbridge
    Kent
    BritishCompany Director65354550001
    BENNION, Rodney John
    The Old Headmasters House
    Rookery Hill Ashtead Park
    KT21 1HY Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Old Headmasters House
    Rookery Hill Ashtead Park
    KT21 1HY Ashtead
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director13574910002
    BURNETT, Ian George
    c/o Wates Construction Limited
    Gelderd Road
    Wortley
    Westcourt
    LS12 6DB Leeds
    7
    Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Wates Construction Limited
    Gelderd Road
    Wortley
    Westcourt
    LS12 6DB Leeds
    7
    Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director111867910001
    CHANDLER, Paul
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United KingdomBritishConstruction Group Md237234850011
    DAVIES, Andrew Oswell Bede
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive Officer257544070001
    DAVIES, David Huw
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director147566800001
    DRECHSLER, Paul Joseph
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandIrishDirector100957660001
    EDWARDS, John
    Chaceley Smugglers Lane
    Monkswood
    SO24 0HD Ropley
    Hampshire
    Amministratore
    Chaceley Smugglers Lane
    Monkswood
    SO24 0HD Ropley
    Hampshire
    BritishCompany Director44109290001
    GIRDLESTONE, Richard John
    c/o Wates Construction Limited
    Floor
    Basing View
    RG21 4HG Basingstoke
    4th
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Wates Construction Limited
    Floor
    Basing View
    RG21 4HG Basingstoke
    4th
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishBusiness Unit Director68561770003
    HOBART, Andrew Hampden
    Floor
    5 Wilton Road
    SW1V 1AN London
    The Peak 2nd
    England
    Amministratore
    Floor
    5 Wilton Road
    SW1V 1AN London
    The Peak 2nd
    England
    EnglandBritishManaging Director157864050001
    HOULTON, Jonathan Charles Bennett
    2 Corney Reach Way
    Chiswick
    W4 2TU London
    Amministratore
    2 Corney Reach Way
    Chiswick
    W4 2TU London
    United KingdomBritishCompany Director70905760002
    HOWELL, John Peter
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Production Director182146080001
    LAIRD, Andrew
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Commercial Director139764990003
    LEAROYD, Brian
    Hedgerley Maddox Lane
    KT23 3BS Little Bookham
    Surrey
    Amministratore
    Hedgerley Maddox Lane
    KT23 3BS Little Bookham
    Surrey
    BritishCompany Director13373930001
    LEITCH, Robert Michael
    261 Chislehurst Road
    Pettswood
    BR5 1NS Orpington
    Kent
    Amministratore
    261 Chislehurst Road
    Pettswood
    BR5 1NS Orpington
    Kent
    EnglandBritishCompany Director87288520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WATES CONSTRUCTION LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wates Group Limited
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    England
    06 apr 2016
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legale2006 Companies Act
    Luogo di registrazioneUk Registrar Of Companies
    Numero di registrazione1824828
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WATES CONSTRUCTION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 26 mar 2010
    Consegnato il 17 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that land and buildings at liberty park stoke heath coventry t/no WM9021981, WM863639 and WM887774.
    Persone aventi diritto
    • Homes and Communities Agency
    Transazioni
    • 17 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 22 mag 2007
    Consegnato il 02 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the monies standing to the credit of the account including all interest accruing thereto.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Valentine Investments Limited
    Transazioni
    • 02 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of deposit
    Creato il 01 feb 2007
    Consegnato il 03 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £1,000.00.
    Persone aventi diritto
    • Fixcove Limited
    Transazioni
    • 03 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge in respect of the merton schools pfi project
    Creato il 25 nov 2002
    Consegnato il 16 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title benefit and interest in the account and in any certificates of deposit, deposit receipts or other instruments or securities relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Newschools (Merton) Limited (the Contractor)
    Transazioni
    • 16 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 02 set 2002
    Consegnato il 06 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Deposit of £18,750.00 in a deposit account.
    Persone aventi diritto
    • T.H.R. Crawley, N.C.T. Tapp, C.L. Howard-Jones and J.A. Keating
    Transazioni
    • 06 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Subordination deed between the company and others as subordinated creditors and west end quay limited as borrower and the development bank of singpore limited as security trustee
    Creato il 04 mag 2000
    Consegnato il 24 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All liabilities arising under or in connection with the finance documents (as defined) to any finance party (as defined)
    Brevi particolari
    By clause 6 of the deed the company shall (if the company actually receives the amount discharged or purported to be discharged) immediately pay it (up to a maximum of an amount equal to the senior laibilities) to the security trustee for application towards the senior liabilities and pending payment hold it (up to that maximum) on trust for the security trustee.
    Persone aventi diritto
    • The Development Bank of Singapore LTD
    Transazioni
    • 24 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 26 gen 1998
    Consegnato il 27 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or elmore plant services limited to the chargee on any account whatsoever under the provisions of the legal charge
    Brevi particolari
    Elmore plant yard ellis road mitcham. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 mar 1995
    Consegnato il 05 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a elmore plant yard ellis road mitcham with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on book debts
    Creato il 27 mar 1995
    Consegnato il 05 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and other debts.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 ott 1994
    Consegnato il 11 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from wates built homes limited to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility letter dated 22ND september 1994
    Brevi particolari
    Elmore plant yard ellis road mitcham. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 mag 1994
    Consegnato il 10 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Save for 1.freehold and leasehold land. 2.Interests in freehold or leasehold land. 3.Plant and machinery. 4.Motor vehicle.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 lug 1993
    Consegnato il 07 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0