ALBEMARLE & BOND HOLDINGS PLC

ALBEMARLE & BOND HOLDINGS PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALBEMARLE & BOND HOLDINGS PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 01979364
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALBEMARLE & BOND HOLDINGS PLC?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ALBEMARLE & BOND HOLDINGS PLC?

    Indirizzo della sede legale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ALBEMARLE & BOND HOLDINGS PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RICHCROSS PLC17 gen 198617 gen 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALBEMARLE & BOND HOLDINGS PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per ALBEMARLE & BOND HOLDINGS PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    22 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 31 mar 2016

    22 pagine4.68

    Cessazione della carica di Christopher Donald Gillespie come amministratore in data 09 set 2015

    2 pagineTM01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 apr 2015

    18 pagine2.24B

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 24 set 2014

    17 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    20 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    32 pagine2.17B

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 5

    11 pagineMR05

    Indirizzo della sede legale modificato da * 2Nd Floor 2 Burgage Square Merchant Gate Wakefield WF1 2TS* in data 29 apr 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Paula Watts come segretario

    1 pagineTM02

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09

    Bilancio consolidato redatto al 30 giu 2013

    69 pagineAA

    Cessazione della carica di Geoff Brady come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Thomas Roberts come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robin Ashton come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sterling Brinkley come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Tracey Graham come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 nov 2013, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    13 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 nov 2013

    Stato del capitale al 15 nov 2013

    • Capitale: GBP 2,221,315.64
    SH01

    Cessazione della carica di John Farrell come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Colin Peter Whipp come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di ALBEMARLE & BOND HOLDINGS PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MORAN, Liam Kevin
    County House
    17 Friar Street
    RG1 1DB Reading
    2nd Floor
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    County House
    17 Friar Street
    RG1 1DB Reading
    2nd Floor
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish149505190001
    NICHOLLS, Greville Vincent
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Amministratore
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    United KingdomBritish51899820004
    WHIPP, Colin Peter
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    EnglandBritish48787380003
    ARMOUR, Douglas William
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    170354640001
    FLANAGAN, Michael Anthony
    7a Hamilton Road
    Ealing
    W5 2EE London
    Segretario
    7a Hamilton Road
    Ealing
    W5 2EE London
    Irish34791200003
    WALLACE, Susan Margaret
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    British95024880001
    WATTS, Paula Mary
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    174702440001
    ALLKINS, John Stephen
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    EnglandBritish94637290001
    ASHTON, Robin James
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish174355970001
    BRADY, Geoff
    2nd Floor
    17 Friar Street
    RG1 1JX Reading
    County House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    2nd Floor
    17 Friar Street
    RG1 1JX Reading
    County House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish134379480001
    BRINKLEY, Sterling Brownlee
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    UsaAmerican59384140003
    COHEN, Phillip Ean
    30 East 71st Street Apt 1 A
    New York
    10021
    Usa
    Amministratore
    30 East 71st Street Apt 1 A
    New York
    10021
    Usa
    Australian86057230001
    DOWLING, John Eric
    Jedsome House Coldmoorholme Lane
    SL8 5PS Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Jedsome House Coldmoorholme Lane
    SL8 5PS Bourne End
    Buckinghamshire
    British54278270002
    DURO, Charles
    35 Rue Des Aubepines
    Bertrange
    FOREIGN Luxembourg
    Amministratore
    35 Rue Des Aubepines
    Bertrange
    FOREIGN Luxembourg
    Luxembourgoise32168860002
    EDWARDS, Allan
    Fountain Street
    02903 Providence
    100
    Rhode Island
    United States
    Amministratore
    Fountain Street
    02903 Providence
    100
    Rhode Island
    United States
    Rhode IslandAmerican84512920004
    FARRELL, John Francis Patrick
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    United KingdomBritish152775230001
    GILLESPIE, Christopher Donald
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    EnglandBritish85258710001
    GRAHAM, Tracey
    County House
    17 Friar Street
    RG1 1DB Reading
    2nd Floor
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    County House
    17 Friar Street
    RG1 1DB Reading
    2nd Floor
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish133523370001
    LAMBIASE, Vincent Albert
    4301 Churchill Downs
    Austin 78746
    Travis/Texas United States
    Amministratore
    4301 Churchill Downs
    Austin 78746
    Travis/Texas United States
    American59384080001
    MARDON TAYLOR, Nicholas John
    6 Millers Court Chiswick Mall
    W4 2PF London
    Amministratore
    6 Millers Court Chiswick Mall
    W4 2PF London
    EnglandBritish105294260003
    MURPHY, Philip Patrick
    53 Pooles Wharf Court
    Hotwells
    BS8 4PB Bristol
    Avon
    Amministratore
    53 Pooles Wharf Court
    Hotwells
    BS8 4PB Bristol
    Avon
    British21524180003
    NICOLSON, Charles Lancaster
    9 The Square
    The Millfields Stonehouse
    PL1 3JX Plymouth
    Devon
    Amministratore
    9 The Square
    The Millfields Stonehouse
    PL1 3JX Plymouth
    Devon
    British41431540003
    PAGE, David Alistair Louden
    19 Harwell Road
    Sutton Courtenay
    OX14 4BN Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    19 Harwell Road
    Sutton Courtenay
    OX14 4BN Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish173283710001
    PATTINSON, David Phillip
    23 Blewbury Road
    OX11 9LE East Hagbourne
    Oxfordshire
    Amministratore
    23 Blewbury Road
    OX11 9LE East Hagbourne
    Oxfordshire
    United KingdomNew Zealand76785870001
    ROBERTS, Thomas Craig
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    UsaUnited States139848130002
    ROTUNDA, Joseph Louis
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Portwall Place
    Amministratore
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Portwall Place
    UsaAmerican139847960002
    ROTUNDA, Joseph Louis
    Aztec Fall Cv
    TX 78746 Austin
    3208
    Texas
    Usa
    Amministratore
    Aztec Fall Cv
    TX 78746 Austin
    3208
    Texas
    Usa
    UsaAmerican139847960002
    SEREBRIAKOFF, Andre
    33 Am Duerf
    Kehlen
    FOREIGN Luxembourg
    Amministratore
    33 Am Duerf
    Kehlen
    FOREIGN Luxembourg
    Luxembourgoise32168890002
    STEVENSON, Barry John
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    EnglandBritish102595670001

    ALBEMARLE & BOND HOLDINGS PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 17 nov 2011
    Consegnato il 25 nov 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights,all plant machinery vehicles computers,office and other equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 25 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 apr 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set off agreement dated 3RD november 2000 and
    Creato il 17 lug 2007
    Consegnato il 25 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture deed
    Creato il 21 set 2000
    Consegnato il 28 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 07 ott 1996
    Consegnato il 12 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any agreement under the debenture and under the credit agreement
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Brown Shipley & Co Limited
    Transazioni
    • 12 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 lug 1987
    Consegnato il 22 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See doc for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co. Limited
    Transazioni
    • 22 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ALBEMARLE & BOND HOLDINGS PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 apr 2015Fine dell'amministrazione
    25 mar 2014Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Toby Scott Underwood
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Praticante
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Stuart David Maddison
    One Reading Central
    23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Praticante
    One Reading Central
    23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter David Dickens
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    2
    DataTipo
    01 apr 2015Inizio della liquidazione
    15 set 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Liquidatore proposto
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter David Dickens
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Liquidatore proposto
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter David Dickens
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0