EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED

EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01979747
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Handover Centre Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EMBASSY DEVELOPMENTS LIMITED10 lug 198610 lug 1986
    EMBASSY DEVELOPMENTS (EDGBASTON) LIMITED13 giu 198613 giu 1986
    TASKPLACE LIMITED20 gen 198620 gen 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Consolidamento delle azioni al 03 set 2021

    4 pagineSH02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Stato del capitale al 06 set 2021

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Consolidation 03/09/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 02 set 2021

    • Capitale: GBP 50,002
    3 pagineSH01

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    1 pagineDS02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Paul Clement Scott come amministratore in data 07 giu 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Clement Scott come segretario in data 07 giu 2021

    1 pagineTM02

    Soddisfazione dell'onere 45 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Alexandria Varley il 15 nov 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Clement Scott il 15 nov 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Paul Clement Scott il 15 nov 2019

    1 pagineCH03

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 2 Langley Park Waterside Drive Langley Slough SL3 6AD a The Handover Centre Appletree Trading Estate Chipping Warden Banbury OX17 1LL in data 22 ott 2019

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    9 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VARLEY, Alexandria
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Amministratore
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    EnglandBritish114926980004
    PRIEST, Malcolm John
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Segretario
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British106610560001
    SCOTT, Paul Clement
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Segretario
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    British22634560001
    WOODSIDE SECRETARIES LIMITED
    61 Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    Surrey
    Segretario
    61 Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    Surrey
    8879140001
    BENDER, Stephen David
    56 Casewick Lane
    Uffington
    PE9 4SX Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    56 Casewick Lane
    Uffington
    PE9 4SX Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritish80314720001
    BRIDGES, Stuart John
    Jasmine Cottage
    Nuptown
    RG42 6HS Warfield
    Berkshire
    Amministratore
    Jasmine Cottage
    Nuptown
    RG42 6HS Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritish42176090002
    CLEVELEY, Michael Richard
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Great BritainBritish116430680001
    HOLBECHE, Roger Malcolm
    Barnmoor House
    Kington Lane
    CV35 8PP Claverdon
    Warwickshire
    Amministratore
    Barnmoor House
    Kington Lane
    CV35 8PP Claverdon
    Warwickshire
    United KingdomBritish16353130007
    KINGSHOTT, Michael James
    Church Farm House
    Brick Kiln Lane
    TN12 8EN Horsmonden
    Kent
    Amministratore
    Church Farm House
    Brick Kiln Lane
    TN12 8EN Horsmonden
    Kent
    United KingdomBritish83713020001
    NUTTALL, Peter Donald
    41 Nags Head
    Avening
    GL8 8NZ Tetbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    41 Nags Head
    Avening
    GL8 8NZ Tetbury
    Gloucestershire
    British29476820001
    PASCAN, Paul Michael
    38 Hillcroft
    LU6 1TU Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    38 Hillcroft
    LU6 1TU Dunstable
    Bedfordshire
    British52572380001
    PRIEST, Malcolm John
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish106610560001
    RUSSELL, Barry Charles
    21 The Albany
    67 Woodcote Road
    SM6 0PS Wallington
    Surrey
    Amministratore
    21 The Albany
    67 Woodcote Road
    SM6 0PS Wallington
    Surrey
    British38094780002
    SCOTT, Paul Clement
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Amministratore
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    EnglandBritish22634560001
    TICEHURST, Jonathon Mark
    The Old House
    64 High Street
    SN14 8LP Marshfield
    Wiltshire
    Amministratore
    The Old House
    64 High Street
    SN14 8LP Marshfield
    Wiltshire
    British87622850001
    TORLAGE, Kevin Edgar
    130 Westway
    Raynes Park
    SW20 9LS London
    Amministratore
    130 Westway
    Raynes Park
    SW20 9LS London
    United KingdomSouth African88938440001
    TRUEMAN, Peter Roy
    52 Dodford Road
    Bournheath
    B61 9JR Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    52 Dodford Road
    Bournheath
    B61 9JR Bromsgrove
    Worcestershire
    EnglandBritish31798580001
    WINDER, Simon Paul
    Flat 2 9 Westbury Road
    N12 7NY London
    Amministratore
    Flat 2 9 Westbury Road
    N12 7NY London
    British75937140001
    WINDUSS, David Alexander
    Glebe House
    Buckland Dinham
    BA11 2QW Frome
    Somerset
    Amministratore
    Glebe House
    Buckland Dinham
    BA11 2QW Frome
    Somerset
    EnglandBritish64556700001
    YERBURY, John William Richard
    10 Bannerdown Close
    Batheaston
    BA1 7NJ Bath
    Amministratore
    10 Bannerdown Close
    Batheaston
    BA1 7NJ Bath
    British50339880001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bidvest Outsourced Services Limited
    Waterside Drive
    Langley
    SL3 6AD Slough
    Unit 2
    England
    01 lug 2016
    Waterside Drive
    Langley
    SL3 6AD Slough
    Unit 2
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUk Companies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House Cardiff
    Numero di registrazione1997606
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Third party legal charge
    Creato il 29 set 2003
    Consegnato il 11 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from astindale properties limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land k/a the timber yard, cranbrook road, gills green, cranbrook t/no K422631. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 22 ott 2001
    Consegnato il 25 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a the timber yard cranbrook road gills green cranbrook kent t/n K422631. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 mar 2001
    Consegnato il 11 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings lying to the north of station road goudhurst kent K703321. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 13 mar 1997
    Consegnato il 20 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 15 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Agreements for lease in respect of phase iii, kingsway retails park, rowditch derby. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of further charge
    Creato il 23 nov 1993
    Consegnato il 25 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee supplemental to the principal deeds as defined in the further charge
    Brevi particolari
    L/H property situate on the south-east side of harbourne road and on the north west side of calthorpe road birmingham west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 25 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 01 set 1993
    Consegnato il 15 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Site of former electricity sub-station at kingsway retail park derby.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 14 set 1992
    Consegnato il 17 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal charge dated 08/07/91
    Brevi particolari
    The monies from time to time standing to the credit of account number 9837 with hill samuel bank limited opened by embassy developments limited.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 17 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of further charge
    Creato il 11 set 1992
    Consegnato il 16 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee supplemental to the principal deeds as defined
    Brevi particolari
    Leasehold property situate on the south east side of harborne road and the northwest side of calthorpe road birmingham west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 16 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 20 ago 1992
    Consegnato il 04 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All rental income due to the company in respect of the provision of car parking spaces or advertising hoarding spaces at any of the following property:- 23 great prescot street, stepney t/no. 165026 and 62/63 royal mint street and 4-10 dock street t/no. EGL221445.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 04 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 mar 1992
    Consegnato il 08 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 08 lug 1991
    Consegnato il 11 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal charge dated 23/03/89
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to two agreements dated 8TH july 1991 relating to the sale of two parts of land charged to the mortgagee and an agreement for lease dated 26/07/90. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 18 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creato il 08 lug 1991
    Consegnato il 09 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Phase 1 kingsway retail park rowditch derby with all buildings and fixtures from time to time thereon.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 09 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 apr 1991
    Consegnato il 17 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property k/as land on the south-east side of harborne road and on the north-west side of calthorpe road birmingham title no WM406016.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of further charge and variation
    Creato il 11 apr 1991
    Consegnato il 15 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold situate on the south east side of harborne road and the north west side of calthorpe road, birmingham, west midlands title no WM406016 agreements dated 13/1/8M and 31/3/8. and all profit and rents of the above property.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Freidlander Limited
    Transazioni
    • 15 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 02 nov 1990
    Consegnato il 06 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a or being helena house ormskirk st., St helens merseyside, with all buildings & fixtures assignment of the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 02 nov 1990
    Consegnato il 06 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a or being 13/15 warwick new road leamington spa, warwickshire t/no. Wk 324538 assignment of the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 ott 1990
    Consegnato il 11 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold land at buildwin street st helens merseyside t/no. Ms 289876.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 17 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 set 1990
    Consegnato il 27 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    23 prescot street london t/no. Ln 165026.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 set 1990
    Consegnato il 27 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    62/63 royal mint st., London E1 t/no. LN144343.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 set 1990
    Consegnato il 27 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    10 dock street london E1 t/no. Ln 101125.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 set 1990
    Consegnato il 27 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    8 dock street london E1 t/no. Ln 93398.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 set 1990
    Consegnato il 27 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    4-6 dock street london E1 t/no. Ln 101926.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 1990
    Consegnato il 19 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold land & buildings k/a prospect ii phoenix way swansea enterprise zone swansea, west glam with all buildings & fixtures the goodwill of the business and the full benefit of all present & future licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 1990
    Consegnato il 19 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold land & buildings k/a castle lodge castle square ludlow, shrops with all buildings & fixtures the goodwill of the business and the full benefit of all present & future licences.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0