R.T. MASTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàR.T. MASTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01981078
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di R.T. MASTS LIMITED?

    • (3220) /

    Dove si trova R.T. MASTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kpmg Llp
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Merseyside
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di R.T. MASTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CASTLECO (105) LIMITED22 gen 198622 gen 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di R.T. MASTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per R.T. MASTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 mar 2010

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 dic 2009

    5 pagine4.68

    legacy

    1 pagine403a

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 dic 2008

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    5 pagine395

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    21 pagineAA

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    5 pagine288a

    legacy

    5 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di R.T. MASTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOLLIDAY, Peter John
    Woodlands
    86 Hollin Lane Styal
    SK9 4JJ Wilmslow
    Cheshire
    Segretario
    Woodlands
    86 Hollin Lane Styal
    SK9 4JJ Wilmslow
    Cheshire
    British73600480004
    CLARKE, James Stuart
    3 Burlington Road
    Birkdale
    PR8 4RX Southport
    Amministratore
    3 Burlington Road
    Birkdale
    PR8 4RX Southport
    British79483030004
    CLARKE, James
    Silvertrees 98 Victoria Road
    Formby
    L37 1LP Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    Silvertrees 98 Victoria Road
    Formby
    L37 1LP Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish122650860001
    HOLLIDAY, Peter John
    Woodlands
    86 Hollin Lane Styal
    SK9 4JJ Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Woodlands
    86 Hollin Lane Styal
    SK9 4JJ Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish73600480004
    BYRNES, Anthony James
    73 Edge Lane
    Stretford
    M32 8PA Manchester
    Segretario
    73 Edge Lane
    Stretford
    M32 8PA Manchester
    British68917030002
    CHEANEY, Bryan
    9 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    Segretario
    9 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    British3450590001
    DENNEHY, Angela Mary
    Holmwood Leamington Road
    WR12 7EB Broadway
    Worcestershire
    Segretario
    Holmwood Leamington Road
    WR12 7EB Broadway
    Worcestershire
    British53952890001
    ELLISON, John Beaumont
    25a High Street
    GU19 5AF Bagshot
    Surrey
    Segretario
    25a High Street
    GU19 5AF Bagshot
    Surrey
    British93434850001
    GREEN, Natalie Ursula
    8 Birkdale Close
    NN2 7PD Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    8 Birkdale Close
    NN2 7PD Northampton
    Northamptonshire
    British55480450001
    GREW, Christopher Adam
    15 Noel Road
    Islington
    N1 8HQ London
    Segretario
    15 Noel Road
    Islington
    N1 8HQ London
    British40188850002
    HALL, Graeme Andrew
    4 Roman Close
    Weldon
    NN17 3JA Corby
    Northamptonshire
    Segretario
    4 Roman Close
    Weldon
    NN17 3JA Corby
    Northamptonshire
    British66755120001
    LADHA, Alnoor
    59 Williamson Way
    WD3 8GL Rickmansworth
    Hertfordshire
    Segretario
    59 Williamson Way
    WD3 8GL Rickmansworth
    Hertfordshire
    British89311330001
    PERKINS, William Robert
    3 Weavers End
    Hanslope
    MK19 7PA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    3 Weavers End
    Hanslope
    MK19 7PA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British3450600001
    WONG, Thomas Chow Woei
    22 Hatchgate Gardens
    Burnham
    SL1 8DD Slough
    Berkshire
    Segretario
    22 Hatchgate Gardens
    Burnham
    SL1 8DD Slough
    Berkshire
    Malaysian75111230001
    ANTONIUCCI, Pier Giorgio
    17474 Pleasant View Avenue
    Monte Sereno
    95030 California
    Usa
    Amministratore
    17474 Pleasant View Avenue
    Monte Sereno
    95030 California
    Usa
    American56303650001
    BYRNES, Anthony James
    73 Edge Lane
    Stretford
    M32 8PA Manchester
    Amministratore
    73 Edge Lane
    Stretford
    M32 8PA Manchester
    United KingdomBritish68917030002
    CHEANEY, Bryan
    9 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    9 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    British3450590001
    COLLINS, Robert
    1473 Los Rios Drive
    San Jose, California, 95120
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    1473 Los Rios Drive
    San Jose, California, 95120
    FOREIGN Usa
    American67233600001
    COPLEY, Stephen Gerald
    The Croft Banbury Road
    Ladbroke
    CV47 2BY Southam
    Warwickshire
    Amministratore
    The Croft Banbury Road
    Ladbroke
    CV47 2BY Southam
    Warwickshire
    EnglandBritish99105730001
    CROFTS, Paul Nicholas
    1 College Gardens
    PE15 8LF March
    Cambridgeshire
    Amministratore
    1 College Gardens
    PE15 8LF March
    Cambridgeshire
    British105233500001
    DORAN, Michael John
    Hope Cottage
    Ashorne
    CV35 9DR Warwick
    Amministratore
    Hope Cottage
    Ashorne
    CV35 9DR Warwick
    EnglandBritish81077000001
    GEORGE, Alan Stanley
    4 Woodbine Street
    CV32 5BG Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    4 Woodbine Street
    CV32 5BG Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish53459730002
    HARRIS, Stephen Vincent
    Barn House North Street
    Rothersthorpe
    NN7 3JB Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Barn House North Street
    Rothersthorpe
    NN7 3JB Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish109731100001
    LYONS, Peter
    43 Whitefields Road
    B91 3NX Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    43 Whitefields Road
    B91 3NX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish54930900001
    MACDONALD, Bruce
    43 Kingsway Gardens
    SO53 1FF Chandlers Ford
    Hampshire
    Amministratore
    43 Kingsway Gardens
    SO53 1FF Chandlers Ford
    Hampshire
    United KingdomBritish182949740001
    MACLEAN, Ian Charles
    Duart House
    Broad Hinton
    SN4 9PQ Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    Duart House
    Broad Hinton
    SN4 9PQ Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish79096180001
    MANNIX, Daniel
    4 Canterbury Close
    Aintree
    L10 8LA Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    4 Canterbury Close
    Aintree
    L10 8LA Liverpool
    Merseyside
    British89797230001
    MARSHALL, Steven Christopher
    Latimer Lodge
    Burtons Lane
    HP8 4BS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Latimer Lodge
    Burtons Lane
    HP8 4BS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish122373680001
    NEWTON, Nigel Ernest
    Brantwood House
    Thorp, Royton
    OL2 5TH Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    Brantwood House
    Thorp, Royton
    OL2 5TH Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritish96221070002
    PERKINS, Andrew William
    45 Swinford Hollow
    Little Billing
    NN3 9HP Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    45 Swinford Hollow
    Little Billing
    NN3 9HP Northampton
    Northamptonshire
    British55838180001
    PERKINS, Mark Robert
    22 Turnberry Lane
    Collingtree Park
    NN4 0PA Northampton
    Northants
    Amministratore
    22 Turnberry Lane
    Collingtree Park
    NN4 0PA Northampton
    Northants
    United KingdomBritish99080730001
    PERKINS, William Robert
    3 Weavers End
    Hanslope
    MK19 7PA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    3 Weavers End
    Hanslope
    MK19 7PA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British3450600001
    RANSLEY, Brandon William
    15 Hardingstone Lane
    Hardingstone
    NN4 6DF Northampton
    Amministratore
    15 Hardingstone Lane
    Hardingstone
    NN4 6DF Northampton
    British61675530001
    ROBERTS, George Powers
    15163 Alondra Lane
    Saratoga
    California
    95070
    Usa
    Amministratore
    15163 Alondra Lane
    Saratoga
    California
    95070
    Usa
    American56335490002
    SHONE, Christopher John
    27 Dale Avenue
    NN8 3QT Wellingborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    27 Dale Avenue
    NN8 3QT Wellingborough
    Northamptonshire
    British3633520001

    R.T. MASTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 24 gen 2008
    Consegnato il 06 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 3 morris close, park farm, north wellingborough t/no. NN142728. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 mag 2007
    Consegnato il 18 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 dic 2005
    Consegnato il 08 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 2, 3 morris close park farm industrial estate wellingborough t/n NN142728. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 nov 2005
    Consegnato il 03 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 mag 2005
    Consegnato il 19 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited 'Security Holder'
    Transazioni
    • 19 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 apr 1997
    Consegnato il 07 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 apr 1997
    Consegnato il 07 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 3 (formerly unit 2) morris close park farm north wellingborough northamptonshire t/no.NN142728 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 apr 1997
    Consegnato il 07 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 4 (formerly unit 3) morris close park farm north wellingborough northamptonshire and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 09 set 1994
    Consegnato il 21 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 2, chieftain business park, park farm industrial estate, wellingborough, northants and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1992
    Consegnato il 25 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal charge over the bookdebts and the benefit of all rights thereto now and from time to time due or owing to the company.
    Persone aventi diritto
    • Maddox Factoring (UK) LTD
    Transazioni
    • 25 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 20 apr 1988
    Consegnato il 22 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 23 mag 1986
    Consegnato il 02 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1986Registrazione di un'ipoteca

    R.T. MASTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 dic 2008Inizio della liquidazione
    16 giu 2010Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Dixon Fleming
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praticante
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Brian Green
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praticante
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0