BIRSE CONSTRUCTION LIMITED

BIRSE CONSTRUCTION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBIRSE CONSTRUCTION LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01981677
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di BIRSE CONSTRUCTION LIMITED?

    • Costruzione di strade e autostrade (42110) / Costruzioni
    • Costruzione di ponti e gallerie (42130) / Costruzioni
    • Costruzione di opere idrauliche (42910) / Costruzioni
    • Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a. (42990) / Costruzioni

    Dove si trova BIRSE CONSTRUCTION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Mazars Llp
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BIRSE CONSTRUCTION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PETER BIRSE CONSTRUCTION LIMITED01 nov 198801 nov 1988
    PETER BIRSE LIMITED08 lug 198608 lug 1986
    BULASTAGE LIMITED23 gen 198623 gen 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di BIRSE CONSTRUCTION LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2016
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2017
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BIRSE CONSTRUCTION LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al17 ott 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma31 ott 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per BIRSE CONSTRUCTION LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per BIRSE CONSTRUCTION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 set 2025

    13 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 set 2020

    9 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 set 2024

    13 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Mazars Llp 30 Old Bailey London EC4M 7AU a C/O Mazars Llp 30 Old Bailey London EC4M 7AU in data 09 nov 2023

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Mazars Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London Greater London E1W 1DD a C/O Mazars Llp 30 Old Bailey London EC4M 7AU in data 09 nov 2023

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 set 2023

    13 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 set 2022

    13 pagineLIQ03

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 06 set 2016

    LRESSP
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 06 set 2016

    LRESSP

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 set 2020

    9 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 set 2019

    9 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 set 2018

    9 pagineLIQ03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 5 Churchill Place Carary Wharf London E14 5HU a 5 Churchill Place Canary Wharf London England E14 5HU

    1 pagineAD02

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 set 2017

    9 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Andrew Robert Astin come amministratore in data 28 mar 2017

    2 pagineTM01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Kingsgate High Street Redhill RH1 1SG England a 5 Churchill Place Carary Wharf London E14 5HU

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Churchill Place Canary Wharf London England E14 5HU England a C/O Mazars Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London Greater London E1W 1DD in data 01 ott 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Nomina di David Andrew Bruce come amministratore in data 01 giu 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stuart Edward Curl come amministratore in data 31 mag 2016

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul David England il 09 dic 2015

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Stuart Edward Curl come amministratore in data 01 feb 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Andrew Robert Astin come amministratore in data 01 feb 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Emma Campbell come amministratore in data 31 dic 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di BIRSE CONSTRUCTION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BNOMS LIMITED
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    Segretario
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione624621
    174017860001
    BRUCE, David Andrew
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp
    Amministratore
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp
    EnglandBritish208824540001
    ENGLAND, Paul David
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp
    Amministratore
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp
    EnglandBritish153205540001
    CAMPBELL, Emma
    Humber Road
    Barton On Humber
    DN18 5BW North Lincolnshire
    Segretario
    Humber Road
    Barton On Humber
    DN18 5BW North Lincolnshire
    154947970001
    CHURCH, Andrew Stuart Cunningham
    Gateways Stoney Wood
    Endon
    ST9 9BX Stoke On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    Gateways Stoney Wood
    Endon
    ST9 9BX Stoke On Trent
    Staffordshire
    British38865770003
    ELLIS, Wendy Caroline
    23 Appleyard Drive
    DN18 5TD Barton Upon Humber
    North Lincolnshire
    Segretario
    23 Appleyard Drive
    DN18 5TD Barton Upon Humber
    North Lincolnshire
    British87323730001
    MORRIS, Philip Hugh
    Station Road
    RH1 1PQ Redhill
    86
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    RH1 1PQ Redhill
    86
    United Kingdom
    British9233330003
    MUTCH, Gregory William
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    Segretario
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    173316360001
    SWALES, David John
    7 The Dales
    HU16 5JN Cottingham
    North Humberside
    Segretario
    7 The Dales
    HU16 5JN Cottingham
    North Humberside
    British16622180001
    ASKEW, Graham
    Burgate House
    Burgate
    DN18 Barton On Humber
    South Humberside
    Amministratore
    Burgate House
    Burgate
    DN18 Barton On Humber
    South Humberside
    British16742530001
    ASTIN, Andrew Robert
    c/o Mazars Llp
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Greater London
    Amministratore
    c/o Mazars Llp
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Greater London
    EnglandBritish200138200001
    BENNIE, Douglas James
    13 Saint Peters Road
    Oundle
    PE8 4PH Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    13 Saint Peters Road
    Oundle
    PE8 4PH Peterborough
    Cambridgeshire
    British66360810001
    BIRSE, Peter Malcolm
    Langscott Lower Street
    Dittisham
    TQ6 0HY Dartmouth
    Devon
    Amministratore
    Langscott Lower Street
    Dittisham
    TQ6 0HY Dartmouth
    Devon
    British16622200002
    BLACKBURN, David Alun
    3 New House Park
    AL1 1UA St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 New House Park
    AL1 1UA St Albans
    Hertfordshire
    British44875400002
    BUDDEN, Martin, M
    Newlands
    8 Thorner Lane
    LS14 3AR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Newlands
    8 Thorner Lane
    LS14 3AR Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127509870001
    BURBIDGE, John Patrick
    14 Thorngrove Road
    SK9 1DD Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    14 Thorngrove Road
    SK9 1DD Wilmslow
    Cheshire
    British42713820001
    CAMPBELL, Emma
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    ScotlandBritish187263100001
    CRAVEN, Heather Ann
    6 Norwood
    Carleton
    WF8 3SD Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    6 Norwood
    Carleton
    WF8 3SD Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish110004900001
    CURL, Stuart Edward
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    Canary Wharf
    E14 5HU London
    5
    England
    England
    EnglandBritish95957100001
    CUTLER, Mark Lloyd
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    Amministratore
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    EnglandBritish185822570001
    DEW, Beverley Edward John
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    Amministratore
    Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    130
    England
    EnglandBritish133103950001
    EASTON, Murray John
    Humber Road
    Barton On Humber
    DN18 5BW North Lincolnshire
    Amministratore
    Humber Road
    Barton On Humber
    DN18 5BW North Lincolnshire
    EnglandBritish62486170001
    EASTON, Murray John
    Humber Road
    Barton On Humber
    DN18 5BW North Lincolnshire
    Amministratore
    Humber Road
    Barton On Humber
    DN18 5BW North Lincolnshire
    EnglandBritish62486170001
    ELDERS, James
    New Barn House New Barn Road
    DA3 7JF Longfield
    Kent
    Amministratore
    New Barn House New Barn Road
    DA3 7JF Longfield
    Kent
    British41027670001
    ELDERS, John Thomas
    427 Acklam Road
    TS5 7HB Middlesbrough
    Cleveland
    Amministratore
    427 Acklam Road
    TS5 7HB Middlesbrough
    Cleveland
    British40362740002
    FRENCH, Stephen
    4 Statham Place
    DL3 0YF Darlington
    County Durham
    Amministratore
    4 Statham Place
    DL3 0YF Darlington
    County Durham
    British49644540001
    FRENCH, Stephen
    4 Statham Place
    DL3 0YF Darlington
    County Durham
    Amministratore
    4 Statham Place
    DL3 0YF Darlington
    County Durham
    British49644540001
    GOOSE, David George
    Springfield House Brigg Road
    Wrawby
    DN20 8RD Brigg
    Ne Lincolnshire
    Amministratore
    Springfield House Brigg Road
    Wrawby
    DN20 8RD Brigg
    Ne Lincolnshire
    EnglandBritish30725940001
    HALLETT, Stephen John
    Flat 17 Dunbar Wharf
    108-124 Narrow Street
    E14 8BB London
    Amministratore
    Flat 17 Dunbar Wharf
    108-124 Narrow Street
    E14 8BB London
    United KingdomBritish94500430001
    HARGREAVES, Peter
    Loft 108 Emery Warehouse
    Britannia Mills Hulme Hall Road
    M15 4LA Manchester
    Amministratore
    Loft 108 Emery Warehouse
    Britannia Mills Hulme Hall Road
    M15 4LA Manchester
    EnglandBritish110164690002
    HARRIS, Philip John
    1 Linemere Close
    BS48 3PX Bristol
    Avon
    Amministratore
    1 Linemere Close
    BS48 3PX Bristol
    Avon
    United KingdomBritish119136000001
    HORNE, Frank Edwin, Dr
    Leggs Field
    Boars Head
    TN6 3HE Crowborough
    East Sussex
    Amministratore
    Leggs Field
    Boars Head
    TN6 3HE Crowborough
    East Sussex
    United KingdomBritish8384130002
    JACKSON, Antony James
    1 Wells Green
    Barton
    DL10 6NH Richmond
    North Yorkshire
    Amministratore
    1 Wells Green
    Barton
    DL10 6NH Richmond
    North Yorkshire
    British58506630001
    JACKSON, Brian George
    East Langton Cottage
    10 Langton Village
    DL2 3HB Darlington
    County Durham
    Amministratore
    East Langton Cottage
    10 Langton Village
    DL2 3HB Darlington
    County Durham
    British82704590001
    JOHNSON, Mark Richard
    Humber Road
    Barton On Humber
    DN18 5BW North Lincolnshire
    Amministratore
    Humber Road
    Barton On Humber
    DN18 5BW North Lincolnshire
    United KingdomBritish61083530002

    BIRSE CONSTRUCTION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 05 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company respectively charged in the manner referred to in clause 3.1 of the debentures and clause 2 of the chattel mortgage all of its assets as more specifically therein referred to upon the terms in all respects therein contained. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 apr 1993
    Consegnato il 27 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal charge dated 22ND april 1993 over the f/h property k/a:land south west side of manby road immingham cleethorpes t/n HS40793 with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creato il 04 feb 1993
    Consegnato il 17 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in its capacity as agent and trustee for itself and each of the secured parties as defined therein under the terms of the composite guarantee and mortgage debenture.
    Brevi particolari
    Please see doc M5L for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcas Agent and Trustee
    Transazioni
    • 17 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 ago 1992
    Consegnato il 02 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/as aultmore kingswood road tunbridge wells kent t/no k 690169 together with fixtures and fittings the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties the goodwill of the mortgagor in relation to the business.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 ago 1992
    Consegnato il 17 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/as land and premises situate to the west of humber road,barton on humber,south humberside including all fixtures and fittings and the mortgagor's beneficial interest in the property or in the proceeds of sale thereof.the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property.the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BIRSE CONSTRUCTION LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 set 2016Inizio della liquidazione
    06 set 2016Data della dichiarazione di solvibilità giurata
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon David Chandler
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0