WINNALL DOWN FARM THREE LTD

WINNALL DOWN FARM THREE LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWINNALL DOWN FARM THREE LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01984079
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WINNALL DOWN FARM THREE LTD?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova WINNALL DOWN FARM THREE LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Manor Farm
    Bighton
    SO24 9RD Alresford
    Hampshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WINNALL DOWN FARM THREE LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BOX-IT IMAGE MANAGEMENT LIMITED03 ott 201103 ott 2011
    F-M IMAGE MANAGEMENT LIMITED29 nov 199629 nov 1996
    FICHEMASTER LIMITED06 ott 198706 ott 1987
    FICHE-MASTER LIMITED30 gen 198630 gen 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di WINNALL DOWN FARM THREE LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per WINNALL DOWN FARM THREE LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A7Z2LR6G

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 dic 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X7WMAVZE

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA
    X7CUKR1Q

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04
    X7CJFK8A

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04
    X7CJFRVS

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04
    X7CJFO8Q

    Soddisfazione dell'onere 019840790012 in pieno

    1 pagineMR04
    X7CJFWBT

    Indirizzo della sede legale modificato da Box-It Winnall Down Farm Alresford Road Winchester Hampshire SO21 1FP a Manor Farm Bighton Alresford Hampshire SO24 9rd in data 18 giu 2018

    1 pagineAD01
    X78DOLZU

    Notifica di John Simon Bruce Mccowen come persona con controllo significativo il 28 feb 2018

    2 paginePSC01
    X78DOHUX

    Cessazione di Box-It Outsourcing Limited come persona con controllo significativo il 28 feb 2018

    1 paginePSC07
    X78DOFRE

    Cessazione della carica di David Anthony Mccormick come amministratore in data 06 mar 2018

    1 pagineTM01
    X715LL4B

    Cessazione della carica di Simon Patrick Ellis come amministratore in data 06 mar 2018

    1 pagineTM01
    X715LK96

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name07 feb 2018

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 06 feb 2018

    RES15
    X6Z6MEQG

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Patrick Ellis il 28 dic 2017

    2 pagineCH01
    X6M9DY63

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 dic 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01
    X6M9EA57

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA
    A6G0DZLC

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X5XY6KG1

    Nomina di Mr David Anthony Mccormick come amministratore in data 11 gen 2017

    2 pagineAP01
    X5XY69Q6

    Cessazione della carica di Steven Mark Penfound come amministratore in data 30 set 2016

    1 pagineTM01
    X5HJX3EH

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA
    L5GN0XGX

    Bilancio annuale redatto al 23 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 gen 2016

    Stato del capitale al 12 gen 2016

    • Capitale: GBP 1,334,517.5
    SH01
    X4YCIHJN

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    11 pagineAA
    A4GKUD6A

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04
    X4BTTA9K

    Chi sono gli amministratori di WINNALL DOWN FARM THREE LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCCOWEN, John Simon Bruce
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    Amministratore
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector43693610001
    ELLIS, Kathleen Mary
    Pentyre 11 Winchester Road
    SP10 2EG Andover
    Hampshire
    Segretario
    Pentyre 11 Winchester Road
    SP10 2EG Andover
    Hampshire
    British62527740001
    MH SECRETARIES LIMITED
    Staples Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Segretario
    Staples Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    39754020001
    ROXBURGHE HOUSE REGISTRARS LIMITED
    2nd Floor Roxburghe House
    273-287 Regent Street
    W1B 2AD London
    Segretario
    2nd Floor Roxburghe House
    273-287 Regent Street
    W1B 2AD London
    49253240002
    SOUTHERN CORPORATE SERVICES LIMITED
    Fleming Court
    Leigh Road
    SO50 9PD Eastleigh
    Southampton
    Segretario
    Fleming Court
    Leigh Road
    SO50 9PD Eastleigh
    Southampton
    89479840001
    BRANDON, John Robert
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    Amministratore
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    United KingdomBritishBusinessman99584240001
    CUMBERLAND, John Peter
    1 Warlingdean
    33 New Road
    KT10 9PG Esher
    Surrey
    Amministratore
    1 Warlingdean
    33 New Road
    KT10 9PG Esher
    Surrey
    United KingdomBritishChairman45642470003
    ELLIS, Simon Patrick
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    Amministratore
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    EnglandBritishDirector116198200003
    ELLIS, Simon Patrick
    47 Winchester Street
    Overton
    GR25 3HT Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    47 Winchester Street
    Overton
    GR25 3HT Basingstoke
    Hampshire
    BritishComputer Consultant8370890007
    HOLMES, Marcus Forbes Hamilton
    103 Genoa Court
    SP10 5JD Andover
    Hampshire
    Amministratore
    103 Genoa Court
    SP10 5JD Andover
    Hampshire
    BritishDirector69819850003
    HUSSAIN, Shahid
    1 Knight Orchard
    83 Verulam Road
    AL3 4DJ St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Knight Orchard
    83 Verulam Road
    AL3 4DJ St Albans
    Hertfordshire
    BritishComputer Consultant56263930002
    IND, Charles Thomas Messiter
    Dovehouse Street
    SW3 6JZ London
    79
    Amministratore
    Dovehouse Street
    SW3 6JZ London
    79
    EnglandBritishInvestment Manager38539540002
    KEELER, Simon Nicholas
    32 Dickens Drive
    Old Stratford
    MK19 6NN Milton Keynes
    Amministratore
    32 Dickens Drive
    Old Stratford
    MK19 6NN Milton Keynes
    EnglandBritishCompany Director79093730001
    MARSHALL, Andrew
    Haddon
    Pans Lane
    SN10 5AP Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    Haddon
    Pans Lane
    SN10 5AP Devizes
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector69819890003
    MCCORMICK, David Anthony, Mr.
    Winnall Down Farm
    Alresford Road
    SO21 1FP Winchester
    Box-It
    Hampshire
    Amministratore
    Winnall Down Farm
    Alresford Road
    SO21 1FP Winchester
    Box-It
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant191004740002
    PENFOUND, Steven Mark
    22 Stinchar Drive
    Chandlers Ford
    SO50 4QH Southampton
    Hedgerows
    Hants
    England
    Amministratore
    22 Stinchar Drive
    Chandlers Ford
    SO50 4QH Southampton
    Hedgerows
    Hants
    England
    EnglandBritishDirector199014560001
    SCOTT, Graeme John
    56 Fountainhall Road
    EH9 2LP Edinburgh
    Amministratore
    56 Fountainhall Road
    EH9 2LP Edinburgh
    ScotlandBritishDirector101636440002
    STORER, Vivian Jane
    Moseley Cottage
    Goodworth Clatford
    SP11 7RE Andover
    Hants
    Amministratore
    Moseley Cottage
    Goodworth Clatford
    SP11 7RE Andover
    Hants
    BritishCompany Director23288660001
    VERSLUYS, Helen Louise
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    Amministratore
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    UkBritishDirector149486770001
    WALKER, Michael James
    12 Johnsons Drive
    TW12 2EQ Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    12 Johnsons Drive
    TW12 2EQ Hampton
    Middlesex
    EnglandBritishInvestment Banker40754350001
    WILLIAMS, John Sinclair
    62 Greenacres
    Woolton Hill
    RG20 9TA Newbury
    Hants
    Amministratore
    62 Greenacres
    Woolton Hill
    RG20 9TA Newbury
    Hants
    EnglandBritishAccountant81423620003

    Chi sono le persone con controllo significativo di WINNALL DOWN FARM THREE LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr John Simon Bruce Mccowen
    Bighton
    SO24 9RD Alresford
    Manor Farm
    Hampshire
    United Kingdom
    28 feb 2018
    Bighton
    SO24 9RD Alresford
    Manor Farm
    Hampshire
    United Kingdom
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Winnall Down Farm
    Alresford Road
    SO21 1FP Winchester
    Box-It
    Hampshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Winnall Down Farm
    Alresford Road
    SO21 1FP Winchester
    Box-It
    Hampshire
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05334086
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WINNALL DOWN FARM THREE LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 06 nov 2014
    Consegnato il 14 nov 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Alexander Yew
    Transazioni
    • 14 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 16 mag 2012
    Consegnato il 22 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Centric Spv 1 Limited
    Transazioni
    • 22 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 dic 2011
    Consegnato il 07 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Simon Mccowen
    Transazioni
    • 07 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 feb 2010
    Consegnato il 03 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to the noteholder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Capital for Enterprise Fund L.P
    Transazioni
    • 03 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 25 feb 2010
    Consegnato il 03 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 20 ott 2008
    Consegnato il 21 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Centric Spv 1 Limited
    Transazioni
    • 21 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All assets debenture deed
    Creato il 03 gen 2003
    Consegnato il 15 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 15 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 26 apr 2000
    Consegnato il 09 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 15 apr 1992
    Consegnato il 29 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 22 nov 1988
    Consegnato il 28 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & flaoting charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 02 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 09 feb 1988
    Consegnato il 26 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • T.S.B. England & Wales PLC
    Transazioni
    • 26 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 09 feb 1987
    Consegnato il 10 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • T.S.B. England & Wales PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 20 nov 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0