HEG (NUMBER 1) LIMITED

HEG (NUMBER 1) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHEG (NUMBER 1) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01984677
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    • (5146) /

    Dove si trova HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    822 Fountain Court
    Birchwood Boulevard Birchwood
    WA3 7QZ Warrington
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FIRST AID UK LTD10 mar 199310 mar 1993
    STAFFORDSHIRE FIRST AID SUPPLIES LIMITED02 apr 198602 apr 1986
    DATECOVER LIMITED31 gen 198631 gen 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 17 Chesford Grange Woolston Warrington Cheshire WA1 4RQ in data 27 mag 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 26 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mag 2010

    Stato del capitale al 26 mag 2010

    • Capitale: GBP 500
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Lyndon James Gaborit il 26 mag 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2009

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed first aid uk LTD\certificate issued on 25/04/08
    3 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagine225

    Bilancio redatto al 28 feb 2007

    11 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 28 feb 2006

    9 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 28 feb 2005

    13 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HEG (NUMBER 1) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    Segretario
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    British79348050002
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish79348050002
    GABORIT, Lyndon James
    Lower Addison Gardens
    W14 8BG London
    25
    United Kingdom
    Amministratore
    Lower Addison Gardens
    W14 8BG London
    25
    United Kingdom
    United KingdomAustralian133660360001
    BRADSHAW, John
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    Segretario
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    British54189670005
    DENOS, Kenneth
    12694 South Rosburg Dr
    Riverton
    Utah 84065
    Usa
    Segretario
    12694 South Rosburg Dr
    Riverton
    Utah 84065
    Usa
    American93963450001
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Segretario
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Australian65921870004
    PEAR, Andrew Mark
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    Segretario
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    British114397290001
    BRADSHAW, John
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish54189670005
    BRUCK, Stuart
    2116 31st Street
    90266 Manhattan Beach
    California
    Amministratore
    2116 31st Street
    90266 Manhattan Beach
    California
    American57236400002
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Amministratore
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Australian65921870004
    PEAR, Andrew Mark
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish114397290001
    PEAR, Graham
    9 Fenton Close
    CW12 3TH Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    9 Fenton Close
    CW12 3TH Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish13275040003
    PEAR, Graham
    77 Avon Drive
    CW12 3RG Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    77 Avon Drive
    CW12 3RG Congleton
    Cheshire
    British13275040001
    PEAR, Susan Dawn
    Bramble End The Mount
    CW12 4FD Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    Bramble End The Mount
    CW12 4FD Congleton
    Cheshire
    British100025290001
    TOMPKINS, Henry John Mark
    18 Thurloe Square
    SW7 2TE London
    Amministratore
    18 Thurloe Square
    SW7 2TE London
    EnglandBritish109723760001
    WOOD, Gordon Alexander
    19th Street
    Manhattan Beach
    404
    Ca 90266
    Usa
    Amministratore
    19th Street
    Manhattan Beach
    404
    Ca 90266
    Usa
    British136141810001

    HEG (NUMBER 1) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession and charge
    Creato il 28 giu 2004
    Consegnato il 01 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 06 set 2002
    Consegnato il 21 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north east side of back lane radnor park industrial estate congleton cheshire CW12 t/n CH442637. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 29 ott 2001
    Consegnato il 02 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under the financing agreement (as defined in the fixed and floating charge)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 02 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 giu 1999
    Consegnato il 06 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 14 silk street congleton cheshire t/no: CH360920. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mag 1997
    Consegnato il 24 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge all book and other debts of the company põresent and future save for book and other debts sold by the company and purchased by the security holder under an invoice discounting agreement and not repurchased pursuant to the provisions thereof.
    Persone aventi diritto
    • New Court Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 24 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 gen 1997
    Consegnato il 19 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as 12 silk st,congleton cheshire and the proceeds of sale thereof; t/no ch 331506. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 gen 1991
    Consegnato il 28 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 for details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 11 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0