SPHINX 110 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPHINX 110 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01984865
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPHINX 110 LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova SPHINX 110 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    16 Shenley Pavilions, Chalkdell Drive
    Shenley Wood
    MK5 6LB Milton Keynes
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SPHINX 110 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SPHINX GROUP LIMITED23 apr 200223 apr 2002
    VISTEC GROUP LIMITED06 dic 198806 dic 1988
    F & H GROUP PLC02 lug 198602 lug 1986
    STOWHILL PUBLIC LIMITED COMPANY 31 gen 198631 gen 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPHINX 110 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per SPHINX 110 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    4 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed sphinx group LIMITED\certificate issued on 07/05/08
    2 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2006

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2005

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine403a

    Bilancio redatto al 30 set 2004

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine363s

    Bilancio redatto al 30 set 2003

    13 pagineAA

    Bilancio modificato redatto al 30 set 2002

    14 pagineAAMD

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 30 set 2002

    13 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di SPHINX 110 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SINNETT, Paul Martin
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    Segretario
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    British71468530002
    LAST, Richard
    The Leys Farm
    Banbury Road Great Tew
    OX7 4DL Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Leys Farm
    Banbury Road Great Tew
    OX7 4DL Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector80537570001
    SINNETT, Paul Martin
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    Amministratore
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    EnglandBritishDirector71468530002
    FAIRCLOUGH, Ian Peter
    17 Claremont Road
    CV31 3EH Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    17 Claremont Road
    CV31 3EH Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishSolicitor55444950001
    HOPWOOD, Arthur
    33 Gaulby Lane
    Stoughton
    LE2 2FL Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    33 Gaulby Lane
    Stoughton
    LE2 2FL Leicester
    Leicestershire
    British3140650001
    SHAW, Lindsey Jane
    2 Mayfair Court
    Milford Road
    DE56 4EL Duffield
    Derbyshire
    Segretario
    2 Mayfair Court
    Milford Road
    DE56 4EL Duffield
    Derbyshire
    BritishCompany Secretary55023490001
    SINNETT, Paul Martin
    11 The Woodlands
    Chesterton
    OX6 8TN Bicester
    Oxfordshire
    Segretario
    11 The Woodlands
    Chesterton
    OX6 8TN Bicester
    Oxfordshire
    BritishDirector71468530001
    BAILEY, Ian David
    12 Hardwick Close
    Amber Heights
    DE5 3SR Ripley
    Derbyshire
    Amministratore
    12 Hardwick Close
    Amber Heights
    DE5 3SR Ripley
    Derbyshire
    United KingdomBritishFinance Director37352730001
    BEACH, Stephen
    Judy Cottage Judy Hill
    Hackney
    DE4 2QB Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    Judy Cottage Judy Hill
    Hackney
    DE4 2QB Derby
    Derbyshire
    BritishDirector50267060001
    FORSYTH, John
    Rudstone House
    26a Kirkgate, Sherburn In Elmet
    LS25 6BL Leeds
    North Yorkshire
    Amministratore
    Rudstone House
    26a Kirkgate, Sherburn In Elmet
    LS25 6BL Leeds
    North Yorkshire
    BritishMarketing Director74348320002
    HOPWOOD, Arthur
    33 Gaulby Lane
    Stoughton
    LE2 2FL Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    33 Gaulby Lane
    Stoughton
    LE2 2FL Leicester
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant3140650001
    MORTON, Arthur Leonard Robert
    Wappenbury Hall
    Wappenbury
    CV33 9DW Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    Wappenbury Hall
    Wappenbury
    CV33 9DW Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant1827570001
    NOBLE, Patrick Joseph
    8 Tennyson Drive
    Attenborough Beeston
    NG9 6BD Nottingham
    Amministratore
    8 Tennyson Drive
    Attenborough Beeston
    NG9 6BD Nottingham
    United KingdomBritishDirector37743780001
    SCHNEIDER, Howard Dennis
    74 Uphill Road
    NW7 4QE London
    Amministratore
    74 Uphill Road
    NW7 4QE London
    BritishSolicitor53525620001
    WALLIS, Adrian David
    3 Moorway
    Breadsall
    DE21 5LR Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    3 Moorway
    Breadsall
    DE21 5LR Derby
    Derbyshire
    BritishDirector3140690001

    SPHINX 110 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Accession deed
    Creato il 20 giu 2002
    Consegnato il 03 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to the dnb finance parties and/or the suk finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Skandia UK Limited (As "Security Agent")
    Transazioni
    • 03 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 gen 1990
    Consegnato il 06 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 18 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 03 mag 1988
    Consegnato il 06 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 24 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 ott 1987
    Consegnato il 29 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 29 ott 1987Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0