01987358 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società01987358 LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01987358
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 01987358 LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova 01987358 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Regent House
    Clinton Avenue
    NG5 1AZ Nottingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 01987358 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JORDANS 333 PUBLIC LIMITED COMPANY07 feb 198607 feb 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di 01987358 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al05 apr 2005
    Scadenza dei prossimi bilanci il05 feb 2006
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2004

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per 01987358 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al08 ago 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma22 ago 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per 01987358 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per 01987358 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei creditori

    4 pagineREST-CVL

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed anglo united\certificate issued on 08/10/18
    pagineCERTNM

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    25 pagineLIQ14

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:notice of release of former liquidator by secretary of state in mvl or cvl
    4 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    18 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 ago 2017

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 feb 2017

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 ago 2016

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 feb 2016

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 ago 2015

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 feb 2015

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 ago 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 feb 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 ago 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 feb 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 ago 2012

    5 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    34 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 feb 2012

    5 pagine4.68

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    28 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 ago 2011

    5 pagine4.68

    Chi sono gli amministratori di 01987358 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VEERMAN, Robert Arnold
    Pentaren
    Mansfield Road Heath
    S44 5SE Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    Pentaren
    Mansfield Road Heath
    S44 5SE Chesterfield
    Derbyshire
    Dutch144829040001
    PHOENIX, Christopher John
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    EnglandBritish16220320001
    MUIRHEAD, Hugh Spencer
    Hill Top Farm Heathcote
    SK17 0AY Hartington
    Derbyshire
    Segretario
    Hill Top Farm Heathcote
    SK17 0AY Hartington
    Derbyshire
    British49836570001
    VEASEY, John Robert
    57 Busheywood Road
    Dore
    S17 3QA Sheffield
    Segretario
    57 Busheywood Road
    Dore
    S17 3QA Sheffield
    British1134670001
    WALLACE, George Roger
    Ballochmyle
    Welbeck Road Bolsover
    S44 6DH Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    Ballochmyle
    Welbeck Road Bolsover
    S44 6DH Chesterfield
    Derbyshire
    British139570001
    BELL, Denis
    1 St Georges Close
    Allestree
    DE22 1JH Derby
    Amministratore
    1 St Georges Close
    Allestree
    DE22 1JH Derby
    British3885760003
    BROOKS, Alan
    The Chantry
    Little Casterton
    PE9 4BE Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Chantry
    Little Casterton
    PE9 4BE Stamford
    Lincolnshire
    British13032530001
    COTTAM, Harold, Managing Director
    Pentwyn Farm
    Dorstone
    HR3 6AD Hereford
    Amministratore
    Pentwyn Farm
    Dorstone
    HR3 6AD Hereford
    United KingdomBritish32116700002
    GAINHAM, John Henry
    32 Drayton Gardens
    SW10 9SA London
    Amministratore
    32 Drayton Gardens
    SW10 9SA London
    British565790004
    MCERLAIN, David Patrick
    Longstone Hall
    Great Longstone
    DE45 1TZ Bakewell
    Derbyshire
    Amministratore
    Longstone Hall
    Great Longstone
    DE45 1TZ Bakewell
    Derbyshire
    British780940004
    NASH, John Alfred Stoddard
    The Old Rectory
    Ewelme
    OX10 6HP Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Ewelme
    OX10 6HP Wallingford
    Oxfordshire
    EnglandBritish3930780001
    STANTON, Howard Terence
    96 Manor Road
    IG7 5PQ Chigwell
    Essex
    Amministratore
    96 Manor Road
    IG7 5PQ Chigwell
    Essex
    United KingdomBritish52013920003
    WALLACE, George Roger
    Ballochmyle
    Welbeck Road Bolsover
    S44 6DH Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Ballochmyle
    Welbeck Road Bolsover
    S44 6DH Chesterfield
    Derbyshire
    British139570001

    01987358 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignment of benefit of a deposit agreement
    Creato il 16 set 2004
    Consegnato il 21 set 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the benefit of the company's interest in any sums payable to the company under a deposit agreement including the payment to the company of any part of the deposit at the expiry of the deposit agreement (the "reversion") together with all rights and interests of the company present and future arising out of or in connection with or relating to the reversion.
    Persone aventi diritto
    • Ever 1813 Limited
    Transazioni
    • 21 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    All assets debenture
    Creato il 22 ago 2003
    Consegnato il 10 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited Trading as Alex. Lawrie Factors
    Transazioni
    • 10 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 20 nov 2002
    Consegnato il 26 nov 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited Trading as Alex Lawrie Factors
    Transazioni
    • 26 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 30 ott 2002
    Consegnato il 02 nov 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated business investment account and numbered 07498193 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division on the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental charge
    Creato il 15 feb 1993
    Consegnato il 02 mar 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the trustee, the agent or the lenders (each as defined therein) under various documents referred to therein
    Brevi particolari
    The supplemental charge is supplemental to the charge and, on and with effect from 12TH march 1993 provided the conditions referred to in clause 3 of the supplemental charge have then been satisfied or waived, amends various definitions in the charge and amends, supplements and deletes various other provisions of the charge.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. LTD
    Transazioni
    • 02 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental debenture
    Creato il 15 feb 1993
    Consegnato il 26 feb 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the trustee, the agent or the lenders (each as defined therein) under each of the loan documents (as defined therein) to which the company is party, the debenture and any guarantee (each as defined therein)
    Brevi particolari
    The proceeds of sale of the real property together with all the other property as detailed in the short particulars detailed on form M395 (see form M395 for details).
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Ltdfinedin Its Capacity as Trustee for the Lenders as De
    Transazioni
    • 26 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Deed of debenture (as supplemented by a supplemental deed of debenture dated 4 march 1993)
    Creato il 23 feb 1990
    Acquisito il 26 set 2000
    Consegnato il 03 ott 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or owing by the company to the chargee the agent or the lenders under the guarantee the debenture and any other loan documents
    Brevi particolari
    All stock shares debentures loan capital rights to subscribe for convert other securities into or otherwise acquire any stocks shares debentures and loan capital of any other body corporate now or at any time hereafter belonging to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu and Co Limited as Trustee for the Lenders
    Transazioni
    • 03 ott 2000Registrazione di un'acquisizione (400)
    Deposit charge
    Creato il 05 feb 1990
    Consegnato il 21 feb 1990
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a rate agreement dated 22/11/89
    Brevi particolari
    All the company's interest in and all sums standing to the credit of such account wherein the sum of £980,000 has been deposited or may be deposited for the purpose of this charge.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 21 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 14 ago 1989
    Consegnato il 24 ago 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as trustee for the lenders and the agent) as defined in the deed under the terms of the loan documents to which the company is party and/or this debenture and/or (as the case may be) any guarantee in existance at the time of such demand
    Brevi particolari
    See doc for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 24 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 23 ott 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 gen 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Guarantee facility deposit agreement
    Creato il 06 lug 1989
    Consegnato il 19 lug 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the hongkong and shanghai banking corporation under the terms of the clause 6.1 of the guarantee facility agreement dated 23.5.89 (the hsbc obligations as defined in the deed) and all monies due or to become due from the company to samuel montagu & co. Limited under terms of the clause 6.1 of the guarantee facility agreement dated 23.5.89 (the sm obligations as defined in the deed)
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of the account with samuel montagu & co limited entitled "call deposit account re derby-others "no. 0852308 and all monies standing to the credit of the account with the hongkong and shanghai banking corporation entitled "hsbc re derby PLC" no. 09440 78524.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu and Co Limited
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
    Transazioni
    • 19 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee facility deposit agreement
    Creato il 23 mag 1989
    Consegnato il 05 giu 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to hongkong and shanghai banking corporation under or pursuant to clause 6.1 of the guarantee facility agreement of even date (the hongkong and shanghai banking corporation obligations as defined in the deed) & all moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited under or pursuant to clause 6.1 of the guarantee facility agreement of even date ( the samuel montagu & co limited obligations as defined in the deed) under the terms of the guarantee facility agreement
    Brevi particolari
    All monies deposited during the subsistence of the security constituted by the guarantee facility deposit agreement standing to the credit of the account entitiled "call deposit account re:derby -others " no. 0852308 (for full details see 395).
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    • The Hongkong and Shanghai Banking Coporation
    Transazioni
    • 05 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    Share purchase revolving credit facility letter
    Creato il 23 mag 1989
    Consegnato il 05 giu 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the hongkong and shanghai banking corporation under the terms or the charge
    Brevi particolari
    All the right title & interest of the company standing to the credit of the cash collateral account designated " derby share security account".
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 05 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    Memorandum of deposit
    Creato il 23 mag 1989
    Consegnato il 05 giu 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the lenders (as defined in the deed) and as agent for itself & the hongkong & shanghai banking corporation & any bank which is an acceeding bank from time to time in accordance with the terms of the charge under the terms of the facility agreements this charge or any of the loan documents (all as defined in the deed)
    Brevi particolari
    Any shares in the capital of nsm PLC & all dividends, interest or other monies paid thereon.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 05 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 23 mag 1989
    Consegnato il 05 giu 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the lenders (as defined in the deed) and as agent for itself & the hongkong & shanghai banking corporation & any bank which is an acceeding bank from time to time in accordance with the terms of the charge under the terms of the facility agreements this charge or any of the loan documents (all as defined in the deed)
    Brevi particolari
    Any shares in the capital of coalite group PLC & all dividends, interest or other monies paid thereon.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 05 giu 1989Registrazione di un'ipoteca

    01987358 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 feb 2018Data di scioglimento
    13 feb 2006Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Terence Kerr
    Pkf
    Regent House
    NG5 1AZ Clinton Avenue
    Nottingham
    Praticante
    Pkf
    Regent House
    NG5 1AZ Clinton Avenue
    Nottingham
    Ian James Gould
    Pkf (Uk) Llp
    Regent House
    NG5 1AZ Clinton Avenue
    Nottingham
    Praticante
    Pkf (Uk) Llp
    Regent House
    NG5 1AZ Clinton Avenue
    Nottingham
    Francis Graham Newton
    6th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    6th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Brian James Hamblin
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    Praticante
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    Edward Terence Kerr
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    Praticante
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0