LENDING SOLUTIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LENDING SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01993755 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LENDING SOLUTIONS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova LENDING SOLUTIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | First Floor, Victoria House Hampshire Court, East Newcastle Business Park Scotswood Road NE4 7YJ Newcastle Upon Tyne England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LENDING SOLUTIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LSL PROPERTY SERVICES LIMITED | 11 ago 2006 | 11 ago 2006 |
| BROOMCO (3455) LIMITED | 21 lug 2004 | 21 lug 2004 |
| LENDING SOLUTIONS LIMITED | 24 nov 2003 | 24 nov 2003 |
| GENERAL ACCIDENT FINANCIAL SERVICES LIMITED | 07 lug 1986 | 07 lug 1986 |
| INTERCEDE 354 LIMITED | 28 feb 1986 | 28 feb 1986 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LENDING SOLUTIONS LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per LENDING SOLUTIONS LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 29 ott 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 12 nov 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 29 ott 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per LENDING SOLUTIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2025 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Lending Solutions Holdings Limited come persona con controllo significativo il 30 mag 2025 | 2 pagine | PSC05 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2024 | 5 pagine | AA | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Newcastle House Albany Court Newcastle Business Park Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE4 7YB a First Floor, Victoria House Hampshire Court, East Newcastle Business Park Scotswood Road Newcastle upon Tyne NE4 7YJ in data 12 giu 2025 | 1 pagine | AD01 | ||
Nomina di Miss Deborah Ann Fish come segretario in data 04 giu 2025 | 2 pagine | AP03 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023 | 4 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Sapna Bedi Fitzgerald come segretario in data 15 set 2024 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Mr Richard James Howells come amministratore in data 23 feb 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Jonathan Pearson Round come amministratore in data 23 feb 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 4 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Helen Elizabeth Buck come amministratore in data 31 mar 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 4 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Helen Elizabeth Buck il 17 gen 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Sapna Bedi Fitzgerald il 17 gen 2022 | 1 pagine | CH03 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 2nd Floor, Gateway 2 Holgate Park Drive York YO26 4GB England a Howard House 3 st. Marys Court Blossom Street York YO24 1AH | 1 pagine | AD02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 4 pagine | AA | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di LENDING SOLUTIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISH, Deborah Ann | Segretario | Hampshire Court, East Newcastle Business Park Scotswood Road NE4 7YJ Newcastle Upon Tyne First Floor, Victoria House England | 336760260001 | |||||||
| CASTLETON, Adam Robert | Amministratore | Hampshire Court, East Newcastle Business Park Scotswood Road NE4 7YJ Newcastle Upon Tyne First Floor, Victoria House England | United Kingdom | British | 68631400004 | |||||
| HOWELLS, Richard James | Amministratore | 3 St Mary's Court Blossom Street YO24 1AH York Howard House United Kingdom | England | British | 317374210001 | |||||
| FITZGERALD, Sapna Bedi | Segretario | 3 St. Marys Court Blossom Street YO24 1AH York Howard House England | British | 125121390002 | ||||||
| MOHUN SMITH, Andrew | Segretario | Riversedge Fox Garth Nether Poppleton YO26 6LP York Yorkshire | British | 99204800001 | ||||||
| WHITAKER, Richard Andrew | Segretario | Strathblane Ashgrove Road TN13 1SS Sevenoaks Kent | British | 497250003 | ||||||
| AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | 1278390004 | |||||||
| BALLIN, Jonathan Guy | Amministratore | Woodside House Forest Hill BS49 5AD Congresbury | British | 88765540001 | ||||||
| BOXALL, James Hewlett | Amministratore | The Close West Acres NE66 2QA Alnwick Northumberland | British | 26299150001 | ||||||
| BUCK, Helen Elizabeth | Amministratore | 3 St. Marys Court Blossom Street YO24 1AH York Howard House England | United Kingdom | British | 152893170001 | |||||
| COOKE, Stephen Andrew | Amministratore | George Cayley Drive Clifton Moor YO30 4XE York Buildmark House North Yorkshire United Kingdom | England | British | 246208860001 | |||||
| DIXON, Gavin William | Amministratore | 4 Poets Gate Cheshunt EN7 6SB Waltham Cross Hertfordshire | British | 104548480001 | ||||||
| EMBLEY, Simon David | Amministratore | George Cayley Drive Clifton Moor YO30 4XE York Buildmark House North Yorkshire United Kingdom | England | British | 71406150003 | |||||
| GILL, Adrian Stuart | Amministratore | Newcastle House Albany Court Newcastle Business Park NE4 7YB Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | England | British | 66529100004 | |||||
| GODFREY, Christopher John Woide | Amministratore | Drascombe Barton Drewsteignton EX6 6PF Exeter Devon | British | 10347320001 | ||||||
| HALES, Peter Robert | Amministratore | St Johns Meadows Thirsk Road YO61 3HJ Easingwold 2 North Yorkshire | United Kingdom | British | 133173840001 | |||||
| HESLOP, David Ross Hilton | Amministratore | Hazel Slope Romaldkirk DL12 9EJ Barnard Castle County Durham | British | 60874110001 | ||||||
| HOLDER, Barrie | Amministratore | Greenknowe Corsiehill PH2 7BN Perth | British | 121900002 | ||||||
| JACK, William Henderson | Amministratore | Dalmore Ardchoille Park PH2 7TL Perth Scotland | United Kingdom | British | 45967520001 | |||||
| KIRSCH, Michael Terence | Amministratore | Windrush Flaxton Road Strensall YO32 5XQ York North Yorkshire | Uk | British | 143294720001 | |||||
| LESLIE, David Gay | Amministratore | Tynewood Ovingham NE42 6HJ Prudhoe Northumberland | British | 23149260001 | ||||||
| MOHUN SMITH, Andrew | Amministratore | Riversedge Fox Garth Nether Poppleton YO26 6LP York Yorkshire | British | 99204800001 | ||||||
| NORTH, Robert Neil | Amministratore | 6 Upper John Street Off Golden Square W1F 9HB London Flat 4 | British | 132235830001 | ||||||
| ROSE, David Rowley | Amministratore | 7 Rainsborough Rise Thorpe St Andrew NR7 0TR Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 89567200001 | |||||
| ROUND, Jonathan Pearson | Amministratore | Newcastle House Albany Court Newcastle Business Park NE4 7YB Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | United Kingdom | British | 120454460001 | |||||
| TULLO, Russell Kenneth | Amministratore | 33 Dalkeith Road SE21 8LT London | England | British | 99204610001 | |||||
| AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | 1278390004 | |||||||
| AVIVA DIRECTOR SERVICES LIMITED | Amministratore | St. Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | 60496090003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LENDING SOLUTIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lending Solutions Holdings Limited | 06 apr 2016 | Hampshire Court East Newcastle Business Park, Scotswood Road NE4 7YJ Newcastle Upon Tyne First Floor, Victoria House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0