EVANS HALSHAW (CHESHAM) LIMITED

EVANS HALSHAW (CHESHAM) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEVANS HALSHAW (CHESHAM) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01994408
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EVANS HALSHAW (CHESHAM) LIMITED?

    • Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Vendita al dettaglio di autovetture usate (45112) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Vendita al dettaglio di altri autoveicoli (45190) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova EVANS HALSHAW (CHESHAM) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EVANS HALSHAW (CHESHAM) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COLVER AND HENCHER (CHESHAM) LIMITED16 mag 198616 mag 1986
    COLVER AND HENCHER (HOLDINGS) LIMITED03 mar 198603 mar 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di EVANS HALSHAW (CHESHAM) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per EVANS HALSHAW (CHESHAM) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01
    X97S2QDS

    Stato del capitale al 10 mar 2020

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19
    A909FJ7T

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    1 pagineSH20
    R8YOFSC3

    legacy

    1 pagineCAP-SS
    R8YOFSBV

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A8YMR9I9

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    7 pagineAA
    A8F3RWSP

    Cessazione della carica di Mark Philip Herbert come amministratore in data 30 giu 2019

    1 pagineTM01
    X88RPCKO

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X86XG1IZ

    Nomina di Mr Mark Simon Willis come amministratore in data 08 apr 2019

    2 pagineAP01
    X83EJ9YH

    Nomina di Mr Mark Philip Herbert come amministratore in data 01 apr 2019

    2 pagineAP01
    X82IR5C0

    Cessazione della carica di Timothy Paul Holden come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01
    X82IR49D

    Cessazione della carica di Trevor Garry Finn come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01
    X82IR48P

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA
    A7EHPCHV

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X77MRRUG

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    7 pagineAA
    A6FQ1DCY

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X685N35K

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come amministratore in data 01 gen 2017

    1 pagineTM01
    X5XSZ4E9

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come segretario in data 01 gen 2017

    1 pagineTM02
    X5XSZ4I1

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Trevor Garry Finn il 18 ott 2016

    2 pagineCH01
    X5HUFQIP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA
    A5GC275F

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 giu 2016

    Stato del capitale al 09 giu 2016

    • Capitale: GBP 291,827
    SH01
    X58R7SX6

    Dettagli del direttore cambiati per Timothy Paul Holden il 26 ott 2015

    2 pagineCH01
    X4JI49PT

    Chi sono gli amministratori di EVANS HALSHAW (CHESHAM) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British110894220002
    CASHA, Martin Shaun
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector41114490010
    WILLIS, Mark Simon
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector229010610001
    PENDRAGON MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    Nottinghamshire
    Amministratore
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    Nottinghamshire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2304195
    50880100004
    PITT, Andrew Joseph
    45 Westholme Road
    Bidford On Avon
    B50 4AL Alcester
    Warwickshire
    Segretario
    45 Westholme Road
    Bidford On Avon
    B50 4AL Alcester
    Warwickshire
    British10739800001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Secretary41559790001
    ARCHER, Anthony Bernard
    The Moat Barn
    Glasshouse Lane
    B94 6PU Lapworth
    Warwickshire
    Amministratore
    The Moat Barn
    Glasshouse Lane
    B94 6PU Lapworth
    Warwickshire
    BritishCompany Director46351440001
    CAMERON, Charles Donald Ewen
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritishCompany Director113187140001
    DALE, Arthur Geoffrey
    Kimberley
    Poolhead Lane
    B94 5ED Tanworth In Arden Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Kimberley
    Poolhead Lane
    B94 5ED Tanworth In Arden Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director10739820001
    FINN, Trevor Garry
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director2652610013
    FORSYTH, David Robertson
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    Amministratore
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    United KingdomBritishChartered Accountant55127120002
    HERBERT, Mark Philip
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector123285980005
    HOLDEN, Timothy Paul
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant148034310003
    HOPEWELL, Stephen Neil
    The Grange
    Hackney Lane, Barlow
    S18 7TR Dronfield
    Derbyshire
    Amministratore
    The Grange
    Hackney Lane, Barlow
    S18 7TR Dronfield
    Derbyshire
    BritishCompany Director88691960001
    SMITH, Alan Frank
    Brambledown Grove Farm
    Droitwich Road Feckenham
    B96 6JA Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Brambledown Grove Farm
    Droitwich Road Feckenham
    B96 6JA Redditch
    Worcestershire
    BritishCompany Director46000100003
    SUMNER, Martin Dudley
    33 Kempson Avenue
    Wylde Green
    B72 1HL Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    33 Kempson Avenue
    Wylde Green
    B72 1HL Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director63276080003
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector41559790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EVANS HALSHAW (CHESHAM) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Alloy Racing Equipment Limited
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06 apr 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione901017
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    EVANS HALSHAW (CHESHAM) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 22 feb 2011
    Consegnato il 24 feb 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    A security agreement
    Creato il 13 mag 2009
    Consegnato il 21 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Override Agent)
    Transazioni
    • 21 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 2009
    • 07 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 22 april 1996,
    Creato il 31 ott 2008
    Consegnato il 04 nov 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 22/4/1996
    Creato il 20 dic 2005
    Consegnato il 22 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set off agreement date 22 april 1996 and
    Creato il 25 ago 2005
    Consegnato il 09 set 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    An omnibus guarantee and set off agreement dated 22ND april 1996
    Creato il 23 giu 2005
    Consegnato il 07 lug 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any bank account of the company with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off agreement dated 22ND april 1996
    Creato il 29 nov 2004
    Consegnato il 16 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 29 nov 2004
    Consegnato il 16 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment
    Creato il 24 ago 1999
    Consegnato il 02 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All of its right,title and interest in and to all and any monies which from time to time now or in the future may be or become due and payable by bmw (GB) limited to the company on the refund or repayment of any deposits paid by or at the direction of the company to bmw on the supply by bmw of motor vehicles on a consignment basis to the company.
    Persone aventi diritto
    • Bmw Financial Services (GB) Limited
    Transazioni
    • 02 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 apr 1988
    Consegnato il 20 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All those monies which may from time to time be owing to evans halshaw (chesham) LTD by bmw (GB) LTD in respect of refunds of monies paid by or by the direction of evans halshaw (chesham) LTD to bmw (GB) LTD by way of deposit on the aquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    Persone aventi diritto
    • Bmw Finance (GB) Limited
    Transazioni
    • 20 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 07 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General charge
    Creato il 01 feb 1988
    Consegnato il 11 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the chargor's property of whatsoever nature and wheresoever situate both present and future (including uncalled capital).
    Persone aventi diritto
    • Bmw Finance (GB) Limited
    Transazioni
    • 11 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 04 gen 1988
    Consegnato il 18 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All those monies which may from time to time be owing to the company by bmw (GB) limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bmw Finance (GB) Limited
    Transazioni
    • 18 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 07 apr 1987
    Consegnato il 15 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    31 ft sunseeker porto fino motor cruiser built 1987 fitted with twin diesel volvo engines name- 'sandcracker-a' official no 712289.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 15 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    Single debenture
    Creato il 16 dic 1986
    Consegnato il 19 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures - including trade fixtures fixed plant and machinery stocks shares other securities.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    Bill of sale
    Creato il 12 dic 1986
    Consegnato il 30 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £120,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Chattels and equipment at colver & hencher's premises at ashley green road, chesham bucks. And tring road aylesbury bucks.
    Persone aventi diritto
    • Mobil Oil Company Limited
    Transazioni
    • 30 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 25 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General charge
    Creato il 16 ott 1986
    Consegnato il 23 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or by colver & hencher (aylesbury) LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Undertaking and assets present and future including uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 23 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 26 ago 1986
    Consegnato il 04 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All those monies which may from time to time be owing to colver & hencher (chesham) LTD by bmw (GB) LTD in respect of refunds of monies paid by or by the direction of colver & hencher (chesham) LTD to bmw (GB) LTD. By way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 04 set 1986Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0