RVL AIRTECH LIMITED
Panoramica
Nome della società | RVL AIRTECH LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01994993 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RVL AIRTECH LIMITED?
- lavorazioni meccaniche (25620) / Industrie manifatturiere
- Attività di servizio ausiliarie ai trasporti aerei (52230) / Trasporto e stoccaggio
Dove si trova RVL AIRTECH LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Rvl House Building 21 Anson Road East Midlands Airport, Castle Donington DE74 2SA Derby |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RVL AIRTECH LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ATLANTIC AIRMOTIVE LIMITED | 01 apr 2005 | 01 apr 2005 |
ATLANTIC AEROENGINEERING LIMITED | 14 apr 1989 | 14 apr 1989 |
MAINPLANE LIMITED | 03 feb 1989 | 03 feb 1989 |
AIRWORK (COVENTRY) LIMITED | 28 mag 1986 | 28 mag 1986 |
SWIFT 1926 LIMITED | 04 mar 1986 | 04 mar 1986 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RVL AIRTECH LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 set 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per RVL AIRTECH LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 10 apr 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 24 apr 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 10 apr 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per RVL AIRTECH LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Mark Adamson come amministratore in data 31 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2023 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2024 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 019949930006 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2023 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2022 | 16 pagine | AA | ||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2022 al 30 set 2022 | 1 pagine | AA01 | ||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 5 | 2 pagine | MR05 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2021 | 18 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Adamson il 31 ago 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2020 | 17 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Steven David Smith come amministratore in data 20 ago 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Stephen Guynan come segretario in data 01 giu 2020 | 1 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Stephen Guynan come amministratore in data 01 giu 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2019 al 31 mar 2020 | 1 pagine | AA01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018 | 17 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 apr 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Mark Adamson come amministratore in data 04 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr David John Connor come amministratore in data 04 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 019949930006, creata il 22 feb 2019 | 44 pagine | MR01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017 | 17 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di RVL AIRTECH LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNOR, David John | Amministratore | Building 21 Anson Road East Midlands Airport, Castle Donington DE74 2SA Derby Rvl House | England | British | Director | 257195160001 | ||||
CRABTREE, Richard Anthony King | Segretario | Cypress Cottage Valley Road Finmere MK18 4AL Buckingham Buckinghamshire | British | Manager | 15965170001 | |||||
GUYNAN, Stephen | Segretario | 3 Albury Square The Park NG7 1AB Nottingham Nottinghamshire | British | Company Director | 75324050001 | |||||
JONES, Ruth Alison | Segretario | Link Cottage Baginton Coventry | British | 1029740001 | ||||||
ADAMSON, Mark | Amministratore | Building 21 Anson Road East Midlands Airport, Castle Donington DE74 2SA Derby Rvl House | England | British | Accountant | 85811860002 | ||||
BROADAWAY, Paul Darren | Amministratore | 37 Barkus Close CV47 1GB Southam Warwickshire | England | British | Managing Director | 97774060001 | ||||
DENNIS, Colin Harold | Amministratore | 1 Hightown Princethorpe CV23 9PR Rugby Warwickshire | England | British | Company Director | 111934670003 | ||||
FODEN, William James | Amministratore | Lower Fosse Near Radford Semele CV31 1XJ Leamington Spa Warwickshire | British | Commerical Pilot | 15143090001 | |||||
FODEN, William James | Amministratore | Lower Fosse Near Radford Semele CV31 1XJ Leamington Spa Warwickshire | British | Commercial Pilot | 15143090001 | |||||
GUYNAN, Stephen | Amministratore | 3 Albury Square The Park NG7 1AB Nottingham Nottinghamshire | England | British | Company Director | 75324050001 | ||||
HIORNS, Nigel | Amministratore | 2 Dowley Croft Binley CV3 2UU Coventry | British | Chief Engineer | 56626250001 | |||||
LAW, Philip Edward | Amministratore | 461 Coventry Road LE10 0NF Hinckley Leicestershire | British | Director Of Technical Support | 110486080001 | |||||
NEALE, Clive | Amministratore | 1 Daleway Road Finham CV3 6JF Coventry | United Kingdom | British | Quality Manager | 56626140001 | ||||
OVERTON, William Gordon | Amministratore | The Old Parsonage Kilmington EX13 7RG Axminster Devon | British | Quality Manager | 29690020001 | |||||
SLATER, Martin | Amministratore | 30 Kineton Road CV35 9LQ Wellesbourne Warwickshire | United Kingdom | British | Engineer | 99266130001 | ||||
SLATER, Martin | Amministratore | 30 Kineton Road CV35 9LQ Wellesbourne Warwickshire | United Kingdom | British | Technical Director | 99266130001 | ||||
SMITH, Steven David | Amministratore | Building 21 Anson Road East Midlands Airport, Castle Donington DE74 2SA Derby Rvl House | United Kingdom | British | Director | 65590120002 | ||||
THEOBALD, Frederick Arthur | Amministratore | 12 Towles Pastures Castle Donington DE74 2RX Derby | British | Director Of Planning | 56626010001 | |||||
WRIGHT, Colin Beverley | Amministratore | 4 The Earls Croft CV3 5ES Coventry West Midlands | British | Company Director | 15078230001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di RVL AIRTECH LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rvl Aviation Limited | 06 apr 2016 | Building 21 Anson Road East Midlands Airport, Castle Donington DE74 2SA Derby Rvl House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
RVL AIRTECH LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 22 feb 2019 Consegnato il 12 mar 2019 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 11 apr 2007 Consegnato il 14 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 07 lug 2004 Consegnato il 15 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,400,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Fixed charge all the plant, machinery, fixtures, furniture, equipment, tools and other chattels of the company present and future. All the goodwill and uncalled capital of the company. Floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future not subject to a fixed charge under this deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 ago 2002 Consegnato il 21 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
An agreement | Creato il 02 giu 1998 Consegnato il 05 giu 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito In favour of the chargee all rights and obligations of natwest under the facility agreement dated 30TH may 1997 between natwest (1) and the borrower (2) as transferred to offshore by the agreement | |
Brevi particolari Specific equitable charge over all f/h and l/h property, all plant machinery vehicles computers and office and other equipment, all book and other debts, its goodwill of and the benefit of any licences; floating charge over its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever present and/or future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 12 mar 1991 Consegnato il 19 mar 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0