MARSHALL ESTATES LIMITED

MARSHALL ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARSHALL ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01995655
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARSHALL ESTATES LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova MARSHALL ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    137 Scalby Road
    YO12 6TB Scarborough
    North Yorkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MARSHALL ESTATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MARSHALL DEVELOPMENTS LIMITED25 giu 198625 giu 1986
    SCOPEIDEAL LIMITED05 mar 198605 mar 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARSHALL ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per MARSHALL ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 23 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 91 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 43 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 24 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 163 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 164 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 60 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 118 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 132 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 162 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 125 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 151 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 83 in pieno

    1 pagineMR04

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 07 mar 2018

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2016 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di MARSHALL ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SWIERS, Barry Peter
    Scalby Road
    YO12 6TB Scarborough
    137
    North Yorkshire
    England
    Segretario
    Scalby Road
    YO12 6TB Scarborough
    137
    North Yorkshire
    England
    British36788700002
    GUTHRIE, John
    Scalby Road
    YO12 6TB Scarborough
    137
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Scalby Road
    YO12 6TB Scarborough
    137
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritish946780001
    KIRKHAM, David John
    Ephesus
    Roshven, Glenuig
    PH38 4NB Lochailort
    Inverness-Shire
    Amministratore
    Ephesus
    Roshven, Glenuig
    PH38 4NB Lochailort
    Inverness-Shire
    United KingdomBritish1582960004
    ROBSON, Martin
    Scalby Road
    YO12 6TB Scarborough
    137
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Scalby Road
    YO12 6TB Scarborough
    137
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritish80183630002
    SWIERS, Barry Peter
    Scalby Road
    YO12 6TB Scarborough
    137
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Scalby Road
    YO12 6TB Scarborough
    137
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritish36788700002
    JOHNSON, James Martin
    Farmleigh
    Scalby
    YO13 0RP Scarborough
    Segretario
    Farmleigh
    Scalby
    YO13 0RP Scarborough
    British583090001
    MARSHALL, Patricia
    Spikers Hill Cottage
    West Ayton
    YO13 9LB Scarborough
    North Yorkshire
    Segretario
    Spikers Hill Cottage
    West Ayton
    YO13 9LB Scarborough
    North Yorkshire
    British1598740001
    BALL, Kenneth Francis
    Moor View
    Silpho
    YO13 0JP Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Moor View
    Silpho
    YO13 0JP Scarborough
    North Yorkshire
    British1260370002
    BENTLEY, Nicholas John
    11 Throxewby Lane
    Newby
    YO13 5HN Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    11 Throxewby Lane
    Newby
    YO13 5HN Scarborough
    North Yorkshire
    British63672440001
    JOHNSON, James Martin
    Farmleigh
    Scalby
    YO13 0RP Scarborough
    Amministratore
    Farmleigh
    Scalby
    YO13 0RP Scarborough
    United KingdomBritish583090001
    MARSHALL, Michael Peter Herbert
    Spikers Hill Farm
    West Ayton
    YO13 9LB Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Spikers Hill Farm
    West Ayton
    YO13 9LB Scarborough
    North Yorkshire
    British1598760001
    MARSHALL, Patricia
    Spikers Hill Cottage
    West Ayton
    YO13 9LB Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Spikers Hill Cottage
    West Ayton
    YO13 9LB Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritish1598740001
    MARSHALL, Timothy Stuart
    28 Morley Drive
    West Ayton
    YO13 9LF Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    28 Morley Drive
    West Ayton
    YO13 9LF Scarborough
    North Yorkshire
    British1598770001
    SHEPPARD, Ian
    22 Kingsway
    Newby
    YO12 6SG Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    22 Kingsway
    Newby
    YO12 6SG Scarborough
    North Yorkshire
    British36070480001
    SWIERS, Barry Peter
    17 Gillylees
    Stepney
    YO12 5DR Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    17 Gillylees
    Stepney
    YO12 5DR Scarborough
    North Yorkshire
    British36788700001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MARSHALL ESTATES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Broadland Properties Limited
    Scalby Road
    YO12 6TB Scarborough
    137
    England
    06 apr 2016
    Scalby Road
    YO12 6TB Scarborough
    137
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Acts
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione00483844
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    MARSHALL ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 16 mar 2007
    Consegnato il 17 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £38,400.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    9 shire fold eastfield scarborough north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 17 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 04 ago 2006
    Consegnato il 09 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property k/a 72 harvest way, eastfield, scarborough, north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 09 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 14 lug 2006
    Consegnato il 19 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    6 shire fold eastfield scarborough north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Dudley Building Society
    Transazioni
    • 19 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 05 dic 1997
    Consegnato il 10 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or simon mark walters and kay cowdery to the chargee under the terms of the mortgage conditions
    Brevi particolari
    10 sheldrake close filey north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 10 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 03 ott 1997
    Consegnato il 15 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other parties named therein under the terms of the nationwide mortgage conditions 1991
    Brevi particolari
    9 sheldrake close filey north yorkshire YO14 obl.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 15 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 28 lug 1997
    Consegnato il 29 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or colin robert hinchliffe under the mortgage conditions
    Brevi particolari
    8 mallard close the pastures filey north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 29 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 giu 1997
    Consegnato il 11 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    4 mallard close filey north yorkshire floating charge over all moveable plant machinery implements of all kings utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Scarborough Building Society
    Transazioni
    • 11 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 mag 1997
    Consegnato il 03 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or joseph agustus and sandra agustus to the chargee under the mortgage conditions
    Brevi particolari
    5 mallard close filey north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 03 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 14 mar 1997
    Consegnato il 22 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or john sellers and karen elizabeth eyles under the terms of the deed
    Brevi particolari
    1 mallard close pasture crescent filey north yorkshire YO14 0BN.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 22 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 21 gen 1997
    Consegnato il 31 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or nicholas kintos and deborah eade kontos under the mortgage conditions
    Brevi particolari
    4 shire close eastfield scarborough north yorkshire YO11 3YZ.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 31 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 17 gen 1997
    Consegnato il 31 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due form the company and/or peter philip wallis under the mortgage conditions
    Brevi particolari
    14 pasture cresecent north yorkshire Y014 obp.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 31 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 17 dic 1996
    Consegnato il 03 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or dawn grace sunter to the chargee under the terms of the mortgage
    Brevi particolari
    The land and property situate and k/a 4 shire croft eastfield scarborough north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Scarborough Building Society
    Transazioni
    • 03 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 29 gen 1996
    Consegnato il 02 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or betty radford-davis to the chargee under the mortgage conditions
    Brevi particolari
    8 sheldrake close filey north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National PLC
    Transazioni
    • 02 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 29 set 1995
    Consegnato il 02 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or robert anthony hudson and nichola anne hudson to the chargee under the mortgage conditions
    Brevi particolari
    1 sheldrake close, filey, north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 02 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 25 ago 1995
    Consegnato il 31 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or karl brian wilson and bridget wilson to the chargee under the mortgage conditions
    Brevi particolari
    50 harvest way, eastfield, scarborough.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 31 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 31 lug 1995
    Consegnato il 02 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company and/or wayne lee andrews and gaye suzanne pollard to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    9 shire close eastfield scarborough.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 02 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 giu 1995
    Consegnato il 21 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or james john worrall and melissa jayne worrall under the mortgage conditions
    Brevi particolari
    Number 12 (formerly plot 24) shedldrake close filey north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 21 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 06 mar 1995
    Consegnato il 23 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or steven richard brewster and claire louise brewster under the mortgage conditions
    Brevi particolari
    1 shire fild eastfield scarborough north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 23 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 20 feb 1995
    Consegnato il 24 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company and/or frank wilson and tracy redfearn under the mortgage conditions
    Brevi particolari
    12 shire fold eastfield scarborough north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 24 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 dic 1994
    Consegnato il 12 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or scott saunders to the chargee under the terms of the mortgage conditions
    Brevi particolari
    17 shire croft eastfield scarborough.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National PLC
    Transazioni
    • 12 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 28 nov 1994
    Consegnato il 14 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or jennifer coreen cammish to the chargee under the terms of the mortgage conditions
    Brevi particolari
    8 pasture crescent filey north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • The Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 14 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 31 gen 1994
    Consegnato il 11 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or colin james jenkinson and susan jayne jenkins to the chargee under the terms of the mortgage conditions
    Brevi particolari
    5 mallard close filey north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 11 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 28 gen 1994
    Consegnato il 11 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or david coates and lesley johnson to the chargee under the terms of the mortgage conditions
    Brevi particolari
    16 shire close harvest way scarborough YO11 3YZ.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 11 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 set 1993
    Consegnato il 07 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or lance william james and paula judith james under the terms of the mortgage conditions
    Brevi particolari
    3 ( formerly plot 56 ) cygnet close the pastures filey north yorkshire YO14 0XX.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 07 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 set 1993
    Consegnato il 30 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or david john birkinand catherine lynn birkin under the mortgage conditions
    Brevi particolari
    Number 8, (formerly plot 51) cygnet close, filey, north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 30 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0