BRIGHTSEA EN LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BRIGHTSEA EN LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01996143 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BRIGHTSEA EN LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova BRIGHTSEA EN LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 5 Wigmore Street London W1U 1PB |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BRIGHTSEA EN LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| EVANS NORTHERN LIMITED | 12 apr 1991 | 12 apr 1991 |
| COUNTY PROPERTIES (SUNDERLAND) LIMITED | 17 lug 1986 | 17 lug 1986 |
| MARCHLARK LIMITED | 05 mar 1986 | 05 mar 1986 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BRIGHTSEA EN LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per BRIGHTSEA EN LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 ago 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2012 | 12 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 ago 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2011 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 ago 2011 | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2010 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 ago 2010 | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2009 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Christopher George White il 01 mag 2010 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Maurice Moses Benady il 01 mag 2010 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2008 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 pagine | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 pagine | 288a | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di BRIGHTSEA EN LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Segretario | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 79571870001 | |||||||
| BENADY, Maurice Moses | Amministratore | 57/63 Line Wall Road Gibraltar | Gibraltar | British | 69435160001 | |||||
| WHITE, Christopher George | Amministratore | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | 80132540006 | |||||
| TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Amministratore | 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor | 135316290001 | |||||||
| GIBSON, William Mcaulay | Segretario | Ivy Bank 1 Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 5387660001 | ||||||
| GILBERT, Nicholas Jay | Segretario | Woodville 14 Carlton Park Avenue WF8 3HQ Pontefract West Yorkshire | British | 81344240001 | ||||||
| JOBBINS, Stuart | Segretario | 16 Riverside Avenue LS21 2RT Otley West Yorkshire | British | 108146440001 | ||||||
| MILLINGTON, Paul Terence | Segretario | 2a Gilleyfield Avenue Dore S17 3NS Sheffield | British | 58693930003 | ||||||
| BELL, John Drummond | Amministratore | Gates Garth 49 Rutland Drive HG1 2NX Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 63940900001 | |||||
| BELL, John Drummond | Amministratore | Gates Garth 49 Rutland Drive HG1 2NX Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 63940900001 | |||||
| BEST, George Laidler | Amministratore | Kiddall Hall Farm York Road Barwick In Elmet LS14 3AE Leeds West Yorkshire | British | 2748600001 | ||||||
| CULL, David Geoffrey Maurice | Amministratore | 8 Centennial Court High Street WD3 1AW Rickmansworth Hertfordshire | British | 84076630001 | ||||||
| CURTIS, Ernest Leonard | Amministratore | Cedar Lodge Greenfield Lane Hawksworth Guiseley LS20 8HF Leeds West Yorkshire | British | 19382660001 | ||||||
| EVANS, Andreas Frederick | Amministratore | Leathley Grange LS21 2LA Leathley North Yorkshire | United Kingdom | British | 9485290003 | |||||
| EVANS, Dominic Redvers | Amministratore | Pine Lodge 9 Sandmoor Avenue LS17 7DW Leeds West Yorkshire | British | 7095590001 | ||||||
| EVANS, Roderick Michael | Amministratore | Oakhill House Roundhay Park Lane LS17 8AR Leeds | British | 40175270002 | ||||||
| GIBSON, William Mcaulay | Amministratore | Ivy Bank 1 Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 5387660001 | ||||||
| HELLIWELL, David Alistair | Amministratore | 8 Farndale Close Spofforth Hill LS22 4XE Wetherby West Yorkshire | England | British | 15578740001 | |||||
| HORSBROUGH, Pauline Elizabeth | Amministratore | 30 The Orchard Wrenthorpe WF2 0LL Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 4961270001 | |||||
| MCKENDRICK, Charles | Amministratore | St Anns Main Street LS22 5EB Kirk Deighton North Yorkshire | United Kingdom | British | 173983190001 | |||||
| MILLINGTON, Paul Terence | Amministratore | 2a Gilleyfield Avenue Dore S17 3NS Sheffield | United Kingdom | British | 58693930003 | |||||
| TURNER, Philip Arthur | Amministratore | Red Roofs 2 Mulberry Garth Thorp Arch LS23 7AF Wetherby West Yorkshire | British | 66424440001 | ||||||
| REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Amministratore | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
BRIGHTSEA EN LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 19 set 2007 Consegnato il 26 set 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 14 giu 2005 Consegnato il 18 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land k/a land and buildings on the east side of mill lane, winwick quay, warrington t/nos. CH211305 and CH211306 together with all buildings, fixtures and fittings, fixed plant and machinery from time to time therein or thereon and the proceeds of sale of the same. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and substitution | Creato il 28 gen 2002 Consegnato il 01 feb 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito In favour of the chargee the principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly of leeds PLC) and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20TH spetember 1995 and deeds (all as defined in the deed of release and substitution and defined on the form 395) all of which are supplemental to the trust deed dated 20TH september 1985 | |
Brevi particolari Land at the east side of mill lane warrington cheshire t/nos CH211305 and CH211306 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999) | Creato il 03 ago 1999 Consegnato il 16 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Second supplemental trust deed | Creato il 04 dic 1992 Consegnato il 08 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £87,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all othedr monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Signal house waterloo place sunderland tyne and wear. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 03 mar 1988 Consegnato il 14 mar 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land between waterloop place and holmside sunderland tyne and wear title no TY200642 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental charge | Creato il 23 gen 1987 Consegnato il 29 gen 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All benefit of the building agreement dated 19/9/86.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0