FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED
Panoramica
Nome della società | FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01996341 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Norcliffe House Station Road SK9 1BU Wilmslow |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BETTERCARE NURSING HOME ESTATES LIMITED | 28 mar 2000 | 28 mar 2000 |
NURSING HOME ESTATES LIMITED | 05 mar 1986 | 05 mar 1986 |
Quali sono gli ultimi bilanci di FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 05 ott 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ian Richard Smith il 19 feb 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Robert Taberner il 18 feb 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Dominic Jude Kay come amministratore in data 28 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Dominic Kay come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mrs Abigail Mattison come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Maureen Claire Royston il 22 mag 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Emerson Court, Alderley Road, Wilmslow, Cheshire, SK9 1NX in data 21 feb 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Maureen Claire Royston come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Calveley come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ian Richard Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTISON, Abigail | Segretario | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | 188573310001 | |||||||
ROYSTON, Maureen Claire, Dr | Amministratore | Alderley Road Wilmslow SK9 1NX Cheshire Emerson Court England England | United Kingdom | British | Company Director | 184190020002 | ||||
SMITH, Ian Richard | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | Company Director | 181082310001 | ||||
TABERNER, Benjamin Robert | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 150511890001 | ||||
CROWE, Geoffrey Michael | Segretario | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | Group Commercial Director | 38256680007 | |||||
KAY, Dominic Jude | Segretario | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | British | Solicitor | 145920530001 | |||||
MURPHY, Marc | Segretario | 39 Cranmore Park BT9 6JF Belfast | Irish | 88620540001 | ||||||
PALMER, Martin Trevor Digby | Segretario | Hill House Crook Road Brenchley TN12 7BS Tonbridge Kent | British | 79436600001 | ||||||
PATTERSON, James | Segretario | 19 Knockmore Park BT20 3SL Bangor County Down Northern Ireland | British | Property Developer | 65359270002 | |||||
RIDGWELL, David William | Segretario | 4 Browns Lane Hastoe HP23 6LX Tring Hertfordshire | British | Company Secretary | 1691410001 | |||||
BARLOW, George Edward | Amministratore | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | Healthcare | 66559170001 | ||||
CALDWELL, Charles Anthony | Amministratore | 26 Hampton Manor BT7 3EL Belfast County Antrim | Northern Ireland | British | Managing Director | 65779460001 | ||||
CALKIN, Joy Durfee, Dr | Amministratore | Suite 915, 610 Bullock Drive L3R 0G1 Unionville Ontario Canada | Canadian | President & C.E.O. | 55624300001 | |||||
CALVELEY, Peter, Dr | Amministratore | Canwick Hill Canwick LN4 2RF Lincoln The Old Vicarage Lincolnshire | United Kingdom | British | Ceo | 131468590001 | ||||
CARTER, James Wesley | Amministratore | 28 Teddington Park Avenue Toronto M4N 2C3 Ontario Canada | Canadian | Chartered Accountant | 48953740001 | |||||
GEARY, Michael | Amministratore | 20 Castlehill Road BT4 3GL Belfast | British | Finance Director | 143518040001 | |||||
HARRIS, Douglas James | Amministratore | 14 The Laurels Potten End HP4 2SP Berkhamsted Hertfordshire | Canadian | Managing Director | 39267910003 | |||||
HEYWOOD, Anthony George | Amministratore | Harborough Hall Lane CO5 9UA Messing Harborough Hall Essex | England | British | Group Chief Executive | 131288260001 | ||||
KAY, Dominic Jude | Amministratore | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | United Kingdom | British | Solicitor | 145920530001 | ||||
LAMBERT, Richard Edwards | Amministratore | 31 Hogback Wood Road HP9 1JT Beaconsfield Buckinghamshire | Uk | British | Operations Director | 149807760001 | ||||
MCLAUGHLIN, John Gordon | Amministratore | 38 Linden Crescent FOREIGN Brampton Ontario L6s 3az Canada | Canadian | Company Director | 44356870001 | |||||
MITCHELL, Nicholas John | Amministratore | Lymbrook 53 Dore Road Dore S17 3NA Sheffield South Yorkshire | Great Britain | British | Group Finance Director | 145102120001 | ||||
NEALE, Charles Christopher Anthony | Amministratore | 62 Scarsdale Villas W8 6PP London | British | Chartered Accountant | 24748590001 | |||||
ORESCHNICK, Robert | Amministratore | Bankfield Cold Hill Lane New Mill HD9 7JX Huddersfield West Yorkshire | American | Consultant | 82179080001 | |||||
PATTERSON, Gordon | Amministratore | 6 Cultra Park BT18 0QE Holywood County Down | Northern Ireland | British | Property Developer | 65359330001 | ||||
PATTERSON, Gordon | Amministratore | No 5 Cultra Park BT18 0QE Holywood County Down Northern Ireland | British | Property Developer | 66574310004 | |||||
PATTERSON, James | Amministratore | 19 Knockmore Park BT20 3SL Bangor County Down Northern Ireland | Northern Ireland | British | Property Developer | 65359270002 | ||||
RHINELANDER, Melvin Gilbert | Amministratore | 19 Aylesbury Road Toronto Ontario Canada | Canadian | Company Director | 66168700001 | |||||
SMITH, Michael John | Amministratore | 11 Lower Park Road IG10 4NB Loughton Essex | England | British | Management Consultant | 641150001 | ||||
SPEAR, Richard Gordon | Amministratore | 14 Highclere Drive Longdean Park HP3 8BT Hemel Hempstead Hertfordshire | British | Company Director | 39650920001 |
FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 14 mar 1995 Consegnato il 17 mar 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or extendicare (UK) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land off rotherham road, cundy cross, barnsley, south yorkshire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 21 lug 1994 Consegnato il 23 lug 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or international care services limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a or being land and buildings nr. Cundy cross, barnsley, south yorkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 30 set 1993 Consegnato il 11 ott 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a berwick nursing home and other land at berwick-upon-tweed, northumberland t/no. ND60893. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 24 mar 1993 Consegnato il 26 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or international care services limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Freehold property k/a cherry tree nursing home cherrys road cundy cross barnsley. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 dic 1986 Consegnato il 29 dic 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Incl trade tenants stocks shares other securities fixtures) patents trade marks patent applications brand names copy rights all intellectual property rights (please see doc for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 31 ott 1986 Consegnato il 07 nov 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property known as the elm residental nursing home, le mar .bungalow and elm cottage, elm drive, south lincolnshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 lug 1986 Consegnato il 17 lug 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 1-95 acres aprox nr. Fordcombe road, fordcombe, kent. T/n k 535622. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0