FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED

FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01996341
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Norcliffe House
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BETTERCARE NURSING HOME ESTATES LIMITED28 mar 200028 mar 2000
    NURSING HOME ESTATES LIMITED05 mar 198605 mar 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 ott 2015

    • Capitale: GBP 200.20
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Richard Smith il 19 feb 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Robert Taberner il 18 feb 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 gen 2015

    Stato del capitale al 23 gen 2015

    • Capitale: GBP 202,000
    SH01

    Cessazione della carica di Dominic Jude Kay come amministratore in data 28 ott 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Dominic Kay come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Abigail Mattison come segretario

    2 pagineAP03

    Dettagli del direttore cambiati per Maureen Claire Royston il 22 mag 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da , Emerson Court, Alderley Road, Wilmslow, Cheshire, SK9 1NX in data 21 feb 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 gen 2014

    Stato del capitale al 16 gen 2014

    • Capitale: GBP 202,000
    SH01

    Nomina di Maureen Claire Royston come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Calveley come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Ian Richard Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188573310001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    Amministratore
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    United KingdomBritishCompany Director184190020002
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritishCompany Director181082310001
    TABERNER, Benjamin Robert
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritishChartered Accountant150511890001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    BritishGroup Commercial Director38256680007
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Segretario
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    BritishSolicitor145920530001
    MURPHY, Marc
    39 Cranmore Park
    BT9 6JF Belfast
    Segretario
    39 Cranmore Park
    BT9 6JF Belfast
    Irish88620540001
    PALMER, Martin Trevor Digby
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    Segretario
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    British79436600001
    PATTERSON, James
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Segretario
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    BritishProperty Developer65359270002
    RIDGWELL, David William
    4 Browns Lane
    Hastoe
    HP23 6LX Tring
    Hertfordshire
    Segretario
    4 Browns Lane
    Hastoe
    HP23 6LX Tring
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary1691410001
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishHealthcare66559170001
    CALDWELL, Charles Anthony
    26 Hampton Manor
    BT7 3EL Belfast
    County Antrim
    Amministratore
    26 Hampton Manor
    BT7 3EL Belfast
    County Antrim
    Northern IrelandBritishManaging Director65779460001
    CALKIN, Joy Durfee, Dr
    Suite 915,
    610 Bullock Drive
    L3R 0G1 Unionville
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    Suite 915,
    610 Bullock Drive
    L3R 0G1 Unionville
    Ontario
    Canada
    CanadianPresident & C.E.O.55624300001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Amministratore
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCeo131468590001
    CARTER, James Wesley
    28 Teddington Park Avenue
    Toronto
    M4N 2C3 Ontario
    Canada
    Amministratore
    28 Teddington Park Avenue
    Toronto
    M4N 2C3 Ontario
    Canada
    CanadianChartered Accountant48953740001
    GEARY, Michael
    20 Castlehill Road
    BT4 3GL Belfast
    Amministratore
    20 Castlehill Road
    BT4 3GL Belfast
    BritishFinance Director143518040001
    HARRIS, Douglas James
    14 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    14 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    CanadianManaging Director39267910003
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Amministratore
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritishGroup Chief Executive131288260001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Amministratore
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritishSolicitor145920530001
    LAMBERT, Richard Edwards
    31 Hogback Wood Road
    HP9 1JT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    31 Hogback Wood Road
    HP9 1JT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    UkBritishOperations Director149807760001
    MCLAUGHLIN, John Gordon
    38 Linden Crescent
    FOREIGN Brampton Ontario L6s 3az Canada
    Amministratore
    38 Linden Crescent
    FOREIGN Brampton Ontario L6s 3az Canada
    CanadianCompany Director44356870001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritishGroup Finance Director145102120001
    NEALE, Charles Christopher Anthony
    62 Scarsdale Villas
    W8 6PP London
    Amministratore
    62 Scarsdale Villas
    W8 6PP London
    BritishChartered Accountant24748590001
    ORESCHNICK, Robert
    Bankfield Cold Hill Lane
    New Mill
    HD9 7JX Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Bankfield Cold Hill Lane
    New Mill
    HD9 7JX Huddersfield
    West Yorkshire
    AmericanConsultant82179080001
    PATTERSON, Gordon
    6 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Amministratore
    6 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Northern IrelandBritishProperty Developer65359330001
    PATTERSON, Gordon
    No 5 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    No 5 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Northern Ireland
    BritishProperty Developer66574310004
    PATTERSON, James
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritishProperty Developer65359270002
    RHINELANDER, Melvin Gilbert
    19 Aylesbury Road
    Toronto
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    19 Aylesbury Road
    Toronto
    Ontario
    Canada
    CanadianCompany Director66168700001
    SMITH, Michael John
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    Amministratore
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    EnglandBritishManagement Consultant641150001
    SPEAR, Richard Gordon
    14 Highclere Drive
    Longdean Park
    HP3 8BT Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    14 Highclere Drive
    Longdean Park
    HP3 8BT Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishCompany Director39650920001

    FOUR SEASONS NURSING HOME ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 14 mar 1995
    Consegnato il 17 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or extendicare (UK) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land off rotherham road, cundy cross, barnsley, south yorkshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 lug 1994
    Consegnato il 23 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or international care services limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a or being land and buildings nr. Cundy cross, barnsley, south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 set 1993
    Consegnato il 11 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a berwick nursing home and other land at berwick-upon-tweed, northumberland t/no. ND60893.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 mar 1993
    Consegnato il 26 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or international care services limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a cherry tree nursing home cherrys road cundy cross barnsley.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 dic 1986
    Consegnato il 29 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Incl trade tenants stocks shares other securities fixtures) patents trade marks patent applications brand names copy rights all intellectual property rights (please see doc for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 ott 1986
    Consegnato il 07 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as the elm residental nursing home, le mar .bungalow and elm cottage, elm drive, south lincolnshire.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 lug 1986
    Consegnato il 17 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 1-95 acres aprox nr. Fordcombe road, fordcombe, kent. T/n k 535622.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0