POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED

POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPOLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01996353
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Secure House
    Moorside Road
    S023 7RX Winchester
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRI LIMITED05 giu 199205 giu 1992
    POLYMETERS LIMITED16 giu 198816 giu 1988
    POLY METERS LIMITED03 feb 198703 feb 1987
    CREDIT AND LOAD MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED05 mar 198605 mar 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 gen 2013

    Stato del capitale al 16 gen 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 27 mar 2012

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium cancelled 09/03/2012
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Sanjaya Singhal il 20 set 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Peter Wilman il 16 ago 2010

    2 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kaushik Ghosh il 26 set 2010

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da P.R.I. House Moorside Road Winnall Trading Estate Winchester, Hampshire SO23 7RX in data 29 giu 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILMAN, Peter
    Heath Road
    KT138TS Weybridge
    The Old Post House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Heath Road
    KT138TS Weybridge
    The Old Post House
    Surrey
    United Kingdom
    British6728520001
    GHOSH, Kaushik
    Oakfields
    Allbrook
    SO504RP Eastleigh
    10
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Oakfields
    Allbrook
    SO504RP Eastleigh
    10
    Hampshire
    England
    EnglandIndianDirector138818080002
    SINGHAL, Sanjaya
    Moorside Road
    S0237RX Winchester
    Secure House
    Hampshire
    Amministratore
    Moorside Road
    S0237RX Winchester
    Secure House
    Hampshire
    IndiaIndianEngineer51868310007
    DICK, Michael John
    76 Heath Road
    GU31 4EJ Petersfield
    Heath House
    Hampshire
    Segretario
    76 Heath Road
    GU31 4EJ Petersfield
    Heath House
    Hampshire
    British30542990002
    PIERCE, Philippa Elinor
    5 Monnow Gardens
    West End
    SO3 3QD Southampton
    Segretario
    5 Monnow Gardens
    West End
    SO3 3QD Southampton
    BritishCompany Secretary36862820001
    STREATFIELD, Paul Richard
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    Segretario
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    British49339260001
    TUTTON, Richard John
    8 Withingham Road
    BH13 6BU Poole
    Dorset
    Segretario
    8 Withingham Road
    BH13 6BU Poole
    Dorset
    British50685530004
    DICK, Michael John
    76 Heath Road
    GU31 4EJ Petersfield
    Heath House
    Hampshire
    Amministratore
    76 Heath Road
    GU31 4EJ Petersfield
    Heath House
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector30542990002
    DICKENS, Derek, Dr
    Cartref
    Heathside Park Road
    GU22 7JE Woking
    Surrey
    Amministratore
    Cartref
    Heathside Park Road
    GU22 7JE Woking
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director48466940001
    FIELDEN, John Spensley
    Downalong
    Higher Metcombe
    EX11 1SL Ottery St. Mary
    Amministratore
    Downalong
    Higher Metcombe
    EX11 1SL Ottery St. Mary
    BritishDesign Engineer (Electronics)5159620002
    MULLINS, Francis Howard, Dr
    21 West End Terrace
    SO22 5EN Winchester
    Amministratore
    21 West End Terrace
    SO22 5EN Winchester
    BritishDirector23213650002
    PEDDIE, Robert Alan
    24 Quarry Road
    SO23 0JG Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    24 Quarry Road
    SO23 0JG Winchester
    Hampshire
    BritishExecutive Deputy Chairman36719300002
    ST CLAIR, Richard John
    Millstone
    40 Shortheath Crest
    GU9 8SB Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Millstone
    40 Shortheath Crest
    GU9 8SB Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishSales Dir53455290005
    STREATFIELD, Paul Richard
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    BritishAccountant49339260001
    TUTTON, Richard John
    8 Withingham Road
    BH13 6BU Poole
    Dorset
    Amministratore
    8 Withingham Road
    BH13 6BU Poole
    Dorset
    BritishChartered Accountant50685530004
    WILBY, William Alvin
    Oakleu
    The Drove
    SO50 7NW Horton Heath
    Hampshire
    Amministratore
    Oakleu
    The Drove
    SO50 7NW Horton Heath
    Hampshire
    UkBritishTechnical Director101811240001

    POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 05 dic 2003
    Consegnato il 09 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 27 mag 1997
    Consegnato il 04 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit d winnall industrial estate moorside orad winchester (l/h). With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge
    Creato il 08 apr 1997
    Consegnato il 11 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Griffin Credit Services Limited
    Transazioni
    • 11 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 07 mar 1997
    Consegnato il 25 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 12 set 1994
    Consegnato il 27 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 mar 1988
    Consegnato il 31 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 15 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0