POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED
Panoramica
Nome della società | POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01996353 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Secure House Moorside Road S023 7RX Winchester Hampshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
PRI LIMITED | 05 giu 1992 | 05 giu 1992 |
POLYMETERS LIMITED | 16 giu 1988 | 16 giu 1988 |
POLY METERS LIMITED | 03 feb 1987 | 03 feb 1987 |
CREDIT AND LOAD MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED | 05 mar 1986 | 05 mar 1986 |
Quali sono gli ultimi bilanci di POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 27 mar 2012
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Sanjaya Singhal il 20 set 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Peter Wilman il 16 ago 2010 | 2 pagine | CH03 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Kaushik Ghosh il 26 set 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da P.R.I. House Moorside Road Winnall Trading Estate Winchester, Hampshire SO23 7RX in data 29 giu 2010 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2009 | 10 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILMAN, Peter | Segretario | Heath Road KT138TS Weybridge The Old Post House Surrey United Kingdom | British | 6728520001 | ||||||
GHOSH, Kaushik | Amministratore | Oakfields Allbrook SO504RP Eastleigh 10 Hampshire England | England | Indian | Director | 138818080002 | ||||
SINGHAL, Sanjaya | Amministratore | Moorside Road S0237RX Winchester Secure House Hampshire | India | Indian | Engineer | 51868310007 | ||||
DICK, Michael John | Segretario | 76 Heath Road GU31 4EJ Petersfield Heath House Hampshire | British | 30542990002 | ||||||
PIERCE, Philippa Elinor | Segretario | 5 Monnow Gardens West End SO3 3QD Southampton | British | Company Secretary | 36862820001 | |||||
STREATFIELD, Paul Richard | Segretario | 45 Castle Lane Chandlers Ford SO53 4AH Eastleigh Hampshire | British | 49339260001 | ||||||
TUTTON, Richard John | Segretario | 8 Withingham Road BH13 6BU Poole Dorset | British | 50685530004 | ||||||
DICK, Michael John | Amministratore | 76 Heath Road GU31 4EJ Petersfield Heath House Hampshire | United Kingdom | British | Director | 30542990002 | ||||
DICKENS, Derek, Dr | Amministratore | Cartref Heathside Park Road GU22 7JE Woking Surrey | United Kingdom | British | Managing Director | 48466940001 | ||||
FIELDEN, John Spensley | Amministratore | Downalong Higher Metcombe EX11 1SL Ottery St. Mary | British | Design Engineer (Electronics) | 5159620002 | |||||
MULLINS, Francis Howard, Dr | Amministratore | 21 West End Terrace SO22 5EN Winchester | British | Director | 23213650002 | |||||
PEDDIE, Robert Alan | Amministratore | 24 Quarry Road SO23 0JG Winchester Hampshire | British | Executive Deputy Chairman | 36719300002 | |||||
ST CLAIR, Richard John | Amministratore | Millstone 40 Shortheath Crest GU9 8SB Farnham Surrey | United Kingdom | British | Sales Dir | 53455290005 | ||||
STREATFIELD, Paul Richard | Amministratore | 45 Castle Lane Chandlers Ford SO53 4AH Eastleigh Hampshire | British | Accountant | 49339260001 | |||||
TUTTON, Richard John | Amministratore | 8 Withingham Road BH13 6BU Poole Dorset | British | Chartered Accountant | 50685530004 | |||||
WILBY, William Alvin | Amministratore | Oakleu The Drove SO50 7NW Horton Heath Hampshire | Uk | British | Technical Director | 101811240001 |
POLYMETERS RESPONSE INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 05 dic 2003 Consegnato il 09 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 27 mag 1997 Consegnato il 04 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit d winnall industrial estate moorside orad winchester (l/h). With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed charge | Creato il 08 apr 1997 Consegnato il 11 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 07 mar 1997 Consegnato il 25 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 12 set 1994 Consegnato il 27 set 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 17 mar 1988 Consegnato il 31 mar 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0