INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01999962
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED?

    • Attività di bonifica e altri servizi di gestione dei rifiuti (39000) / Captazione, depurazione e distribuzione di acqua; gestione dei rifiuti; attività di bonifica

    Dove si trova INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    TENEO RESTRUCTURING LIMITED
    156 Great Charles Street Queensway
    B3 3HN Birmingham
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INSITUFORM PERMALINE LIMITED21 apr 198621 apr 1986
    LEWINDELL LIMITED14 mar 198614 mar 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 05 set 2021

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 City Square Leeds LS1 2AL a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 02 lug 2021

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 20 gen 2021

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Roundwood Industrial Estate Ossett WF5 9SQ England a 1 City Square Leeds LS1 2AL in data 22 feb 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Aegion Uk Holdings Limited come persona con controllo significativo il 26 ago 2020

    2 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Paul Gibson il 20 mag 2020

    1 pagineCH03

    Modifica dei dettagli di Insituform Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 20 mag 2020

    2 paginePSC05

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Mark Andrew Neal come amministratore in data 17 set 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Martinus Franciscus Kool come amministratore in data 30 lug 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 4 - 8 Brunel Close Park Farm Industrial Estate Wellingborough Northamptonshire NN8 6QX a 3 Roundwood Industrial Estate Ossett WF5 9SQ in data 18 ott 2018

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Sarah Bennison come segretario in data 17 ott 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Paul Gibson come segretario in data 24 set 2018

    2 pagineAP03

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    10 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Katharina Eikenberg come segretario in data 16 ott 2017

    2 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GIBSON, Paul
    Brunel Close
    Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    12 - 20
    England
    Segretario
    Brunel Close
    Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    12 - 20
    England
    251547270001
    MORRIS, David Francis
    1843 Kennett Place
    FOREIGN St Louis
    Missouri 63104
    United States
    Segretario
    1843 Kennett Place
    FOREIGN St Louis
    Missouri 63104
    United States
    AmericanGeneral Counsel144054050001
    MORRIS, David Francis
    1843 Kennett Place
    FOREIGN St Louis
    Missouri 63104
    United States
    Amministratore
    1843 Kennett Place
    FOREIGN St Louis
    Missouri 63104
    United States
    United StatesAmericanGeneral Counsel144054050001
    BENNISON, Sarah
    Brunel Close
    Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    12-20
    Northamptonshire
    Segretario
    Brunel Close
    Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    12-20
    Northamptonshire
    British151700470001
    CUNLIFFE, Barry Stuart
    83 Mulehouse Road
    S10 1TB Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    83 Mulehouse Road
    S10 1TB Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCs43815150001
    EIKENBERG, Katharina
    91 Rue Pereire
    Saint Germain-En-Laye
    78100
    France
    Segretario
    91 Rue Pereire
    Saint Germain-En-Laye
    78100
    France
    British159387330001
    GREEN, Sarah Louise
    61 Bishops Way
    Meltham
    HD9 4BW Holmfirth
    Segretario
    61 Bishops Way
    Meltham
    HD9 4BW Holmfirth
    British71589540001
    JESSOP, Catherine Jayne
    6 Heather Close
    WF5 0SS Ossett
    West Yorkshire
    Segretario
    6 Heather Close
    WF5 0SS Ossett
    West Yorkshire
    BritishUk Financial Controller99747710002
    KAILES, Howard
    Cunliffe 83 Mulehouse Road
    Crookes
    S10 1TB Sheffield
    Segretario
    Cunliffe 83 Mulehouse Road
    Crookes
    S10 1TB Sheffield
    British33624170002
    NEWTON, Jonathan
    12 Branstone Road
    Sprotbrough
    DN5 7QJ Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    12 Branstone Road
    Sprotbrough
    DN5 7QJ Doncaster
    South Yorkshire
    British34565400001
    REED, Neil
    16a Church Lane
    Cossall
    NG16 2RW Nottingham
    East Midlands
    Segretario
    16a Church Lane
    Cossall
    NG16 2RW Nottingham
    East Midlands
    British85948070001
    ROBERTSON, Richard
    Unit 6
    Roundwood Industrial Estate
    WF5 9SQ Dewsbury Road Ossett
    W Yorks
    Segretario
    Unit 6
    Roundwood Industrial Estate
    WF5 9SQ Dewsbury Road Ossett
    W Yorks
    147445760001
    WILSON, Roger
    2 Quarry Close
    Darton
    S75 5EZ Barnsley
    South Yorkshire
    Segretario
    2 Quarry Close
    Darton
    S75 5EZ Barnsley
    South Yorkshire
    BritishDirector19808040001
    WILSON, Roger
    2 Quarry Close
    Darton
    S75 5EZ Barnsley
    South Yorkshire
    Segretario
    2 Quarry Close
    Darton
    S75 5EZ Barnsley
    South Yorkshire
    BritishDirector19808040001
    BATES, Mark
    Brunel Close
    Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    24-27
    Northants
    Amministratore
    Brunel Close
    Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    24-27
    Northants
    United KingdomBritishNone153481370001
    BATES, Mark
    Brunel Close
    Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    12-20
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Brunel Close
    Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    12-20
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United KingdomUnited KingdomManaging Director147932900001
    BUEHLER, Alexander Jon
    924 Bentley Park Drive
    63366 O'Fallon
    Missorui
    United States
    Amministratore
    924 Bentley Park Drive
    63366 O'Fallon
    Missorui
    United States
    UsaUsaVice President Gen Mgr144054060001
    CHAPMAN, Michael Alan
    Seascape
    Tregurrian
    TR8 4AD Newquay
    Cornwall
    Amministratore
    Seascape
    Tregurrian
    TR8 4AD Newquay
    Cornwall
    BritishChief Executive Officer59585940001
    CIRKET, Edward John
    156a Old Road
    CM17 0HG Harlow
    Essex
    Amministratore
    156a Old Road
    CM17 0HG Harlow
    Essex
    BritishSales Executive53898000001
    FOSTER, Kenneth William
    - 8
    Brunel Close Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    4
    Northamptonshire
    Amministratore
    - 8
    Brunel Close Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    4
    Northamptonshire
    EnglandBritishEuropean Ceo190957050001
    GREEN, Sarah Louise
    61 Bishops Way
    Meltham
    HD9 4BW Holmfirth
    Amministratore
    61 Bishops Way
    Meltham
    HD9 4BW Holmfirth
    BritishFinancial Controller71589540001
    HANCOCK, Ronald John
    5 Shardeloes
    Missenden Road
    HP7 0RL Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    5 Shardeloes
    Missenden Road
    HP7 0RL Amersham
    Buckinghamshire
    BritishConsultant39812500001
    HOOPER, Anthony William
    2274 Dogwood Meadow Cove
    38139 Germantown
    Tennessee
    Usa
    Amministratore
    2274 Dogwood Meadow Cove
    38139 Germantown
    Tennessee
    Usa
    CanadianCeo68526110001
    JONES, Ian David
    The Farmhouse
    Mewith Head, Mewith Lane, Bentham
    LA2 7AP Lancaster
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Farmhouse
    Mewith Head, Mewith Lane, Bentham
    LA2 7AP Lancaster
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector123553890001
    KING, Martin William
    19 Court Road
    CR3 5RG Caterham
    Surrey
    Amministratore
    19 Court Road
    CR3 5RG Caterham
    Surrey
    BritishManaging Director5281530001
    KOOL, Martinus Franciscus
    Roundwood Industrial Estate
    WF5 9SQ Ossett
    3
    England
    Amministratore
    Roundwood Industrial Estate
    WF5 9SQ Ossett
    3
    England
    NetherlandsDutchDirector231980640001
    LEWIS, David Stephen
    Maison De Hauteville Hauteville
    CHANNEL St Peter Port
    Guernsey
    Amministratore
    Maison De Hauteville Hauteville
    CHANNEL St Peter Port
    Guernsey
    AmericanChief Financial Officer19808060001
    MCMANUS, Anthony John
    11 Potters Croft
    Lofthouse
    WF3 3HG Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    11 Potters Croft
    Lofthouse
    WF3 3HG Wakefield
    West Yorkshire
    BritishCivil Engineer45787530001
    MENARD, Antoine
    15 Rue Charles Rhone
    78100 Saint Germain En Laye
    France
    Amministratore
    15 Rue Charles Rhone
    78100 Saint Germain En Laye
    France
    FrenchCompany Director60407570001
    MONK, Clive
    5 Top Of The Bank
    Thurstonland
    HD4 6XZ Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Top Of The Bank
    Thurstonland
    HD4 6XZ Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCivil Engineer19808070001
    NEAL, Mark Andrew
    Roundwood Industrial Estate
    WF5 9SQ Ossett
    3
    England
    Amministratore
    Roundwood Industrial Estate
    WF5 9SQ Ossett
    3
    England
    EnglandBritishDirector93863120001
    NEAL, Mark Andrew
    Brandy Carr House
    45 Jerry Clay Lane, Wrenthorpe
    WF2 0NP Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Brandy Carr House
    45 Jerry Clay Lane, Wrenthorpe
    WF2 0NP Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director93863120001
    NEWTON, Jonathon
    12 Branstone Road
    Sprotbrough
    DN5 7QJ Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    12 Branstone Road
    Sprotbrough
    DN5 7QJ Doncaster
    South Yorkshire
    BritishManaging Director36639880001
    O'DELL, Bobby
    - 8
    Brunel Close Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    4
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    - 8
    Brunel Close Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    4
    Northamptonshire
    England
    AustraliaAmericanVice President - International184690090001
    O'DELL, Bobby Charles, Vice President Europe
    Brunel Close
    Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    24-27
    Northants
    Amministratore
    Brunel Close
    Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    24-27
    Northants
    United States Of AmericaUsNone159998190001

    Chi sono le persone con controllo significativo di INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Aegion Uk Holdings Limited
    Brunel Close
    Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    4-8
    England
    26 ago 2020
    Brunel Close
    Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    4-8
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleLimited Liability Partnerships Act 2000
    Luogo di registrazioneEngland Companies Registry
    Numero di registrazione12292079
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Brunel Close
    Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    12 - 20
    England
    06 apr 2016
    Brunel Close
    Park Farm Industrial Estate
    NN8 6QX Wellingborough
    12 - 20
    England
    No
    Forma giuridicaLtd
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2265481
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposit
    Creato il 22 gen 2007
    Consegnato il 25 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to euro currency account designation 550/02/81505612 nxnfhzgv EURO2 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 dic 1987
    Consegnato il 05 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A charge by way of legal mortgage and the proceeds of sale thereof unit 6 roundwood industrial estate ossett west yorkshire title no wyk 83546. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over credit balances
    Creato il 18 lug 1986
    Consegnato il 29 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys held to the credit of the company by national westminster bank PLC on any account earmarked re the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    Charge over credit balances
    Creato il 30 giu 1986
    Consegnato il 10 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a performance bond dated 23.5.86 in the sum of £8,334 given to lincoln city council in respect of sewer relining and ancillary works
    Brevi particolari
    The sum of £8,334 tog with interest accrued held by the bank on an account in the name of the bank and earmarked re the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 25 apr 1986
    Consegnato il 14 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as unit 6 roundwood estate dewsbury road ossett, west yorkshire no. Wyk 83546 see doc M15. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Insituform Group Limited
    Transazioni
    • 14 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 15 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 gen 2021Inizio della liquidazione
    14 dic 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praticante
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Stephen Roland Browne
    1 Hill House
    EC4A 3HQ London
    Praticante
    1 Hill House
    EC4A 3HQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0