EASTBOURNE BUSES LIMITED

EASTBOURNE BUSES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEASTBOURNE BUSES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02000069
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EASTBOURNE BUSES LIMITED?

    • Altri trasporti passeggeri urbani, suburbani o metropolitani via terra (non metropolitana o sistemi simili) (49319) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova EASTBOURNE BUSES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Stagecoach Services Limted
    Daw Bank
    SK3 0DU Stockport
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di EASTBOURNE BUSES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per EASTBOURNE BUSES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 dic 2016

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account 26/11/2016
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Robert Montgomery come amministratore in data 04 nov 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Bruce Dingwall come amministratore in data 04 nov 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 13 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2016

    Stato del capitale al 15 apr 2016

    • Capitale: GBP 1,910,002
    SH01

    Bilancio redatto al 30 apr 2015

    26 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 apr 2015

    Stato del capitale al 17 apr 2015

    • Capitale: GBP 1,910,002
    SH01

    Cessazione della carica di Michael John Vaux come amministratore in data 30 ott 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gary James Nolan come amministratore in data 30 ott 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip Ben Norwell come amministratore in data 30 ott 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Samuel Derek Greer come amministratore in data 30 ott 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Gervase Andrew come amministratore in data 30 ott 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 apr 2014

    26 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Samuel Derek Greer il 09 giu 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Philip Ben Norwell il 01 mag 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 13 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 apr 2014

    Stato del capitale al 16 apr 2014

    • Capitale: GBP 1,910,002
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael John Vaux il 20 mar 2014

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Paul Southgate come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 apr 2013

    26 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di EASTBOURNE BUSES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Segretario
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish85970020003
    DINGWALL, Bruce Maxwell
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish185252790001
    BARNETT, Stephen Gordon
    29 Letheren Place
    BN21 1HL Eastbourne
    East Sussex
    Segretario
    29 Letheren Place
    BN21 1HL Eastbourne
    East Sussex
    British71335860004
    CLARK, Anne Lesley
    11 St Johns Road
    BN25 1JW Seaford
    East Sussex
    Segretario
    11 St Johns Road
    BN25 1JW Seaford
    East Sussex
    British2529230001
    DUNN, Kevan Peter
    Clavering Walk
    TN39 4TN Bexhill
    18
    East Sussex
    Segretario
    Clavering Walk
    TN39 4TN Bexhill
    18
    East Sussex
    British172496960001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Segretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    ANDREW, Robert Gervase
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish54172700004
    BACKHOUSE, Robert Henry Ernest
    35 Wade Close
    BN23 6AW Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    35 Wade Close
    BN23 6AW Eastbourne
    East Sussex
    British30512520001
    BARFOOT, Vernon
    1 Montague Court
    Santa Cruz Drive
    BN23 5 Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    1 Montague Court
    Santa Cruz Drive
    BN23 5 Eastbourne
    East Sussex
    British89516570001
    BARNARD, Peter Keith
    30 Heather Close
    Langney
    BN23 8DF Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    30 Heather Close
    Langney
    BN23 8DF Eastbourne
    East Sussex
    British8396760001
    BARNETT, Stephen Gordon
    29 Letheren Place
    BN21 1HL Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    29 Letheren Place
    BN21 1HL Eastbourne
    East Sussex
    British71335860004
    BERRY, Christopher John
    16 Seaside
    BN22 7QJ Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    16 Seaside
    BN22 7QJ Eastbourne
    East Sussex
    United KingdomBritish70342010003
    BOWKER, Roger William
    43 Leigh Drive
    Elsenham
    CM22 6BY Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    43 Leigh Drive
    Elsenham
    CM22 6BY Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritish8614910005
    CHARLTON, Sheila
    16 Kings Drive
    BN21 2NU Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    16 Kings Drive
    BN21 2NU Eastbourne
    East Sussex
    British44100050001
    CLARK, Anne Lesley
    11 St Johns Road
    BN25 1JW Seaford
    East Sussex
    Amministratore
    11 St Johns Road
    BN25 1JW Seaford
    East Sussex
    British2529230001
    CULLEN, Dennis Patrick
    13 Macmillan Drive
    BN21 1SU Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    13 Macmillan Drive
    BN21 1SU Eastbourne
    East Sussex
    British10894610001
    DEGHAYE, Jean-Pierre
    71 Rue Xavier De Maistre
    Rueil Malmaison 92500
    France
    Amministratore
    71 Rue Xavier De Maistre
    Rueil Malmaison 92500
    France
    French114873060001
    DUNN, Kevan Peter
    Clavering Walk
    TN39 4TN Bexhill
    18
    East Sussex
    Amministratore
    Clavering Walk
    TN39 4TN Bexhill
    18
    East Sussex
    EnglandBritish172496960001
    ELKIN, David Walter
    32 Marine Parade
    BN22 7AY Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    32 Marine Parade
    BN22 7AY Eastbourne
    East Sussex
    British71108080001
    ELLIS, Richard William
    6 Rye Street
    BN22 7PN Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    6 Rye Street
    BN22 7PN Eastbourne
    East Sussex
    British59013330001
    GOODYEAR, Nigel Royston
    40 Longstone Road
    BN21 3SN Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    40 Longstone Road
    BN21 3SN Eastbourne
    East Sussex
    EnglandBritish124228350001
    GREER, Samuel Derek
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish140386230006
    HEASMAN, Paul
    48 Wish Hill
    Willingdon Village
    BN20 9HA Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    48 Wish Hill
    Willingdon Village
    BN20 9HA Eastbourne
    East Sussex
    British87686060001
    HERBERT, Simon David, Cllr
    23b Tenterden Close
    BN23 7JB Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    23b Tenterden Close
    BN23 7JB Eastbourne
    East Sussex
    British113840800001
    HOWARD, David Robin
    8 Gresham
    Wallsend Road
    BN24 5LA Pevensey
    East Sussex
    Amministratore
    8 Gresham
    Wallsend Road
    BN24 5LA Pevensey
    East Sussex
    British111193300001
    LEGGETT, Robert Edward
    1 Selwyn House
    Selwyn Road
    BN21 2LF Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    1 Selwyn House
    Selwyn Road
    BN21 2LF Eastbourne
    East Sussex
    British71336040001
    MASON, Leslie
    104 Willingdon Park Drive
    Willingdon
    BN22 0DB Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    104 Willingdon Park Drive
    Willingdon
    BN22 0DB Eastbourne
    East Sussex
    British6077940001
    MEDLICOTT, Philip
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish129614380002
    MONTGOMERY, Robert
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish122403240002
    NOLAN, Gary James
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish65317320002
    NORWELL, Philip Ben
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    EnglandBritish179672190002
    PARSONS, Ronald Arthur
    327 Victoria Drive
    BN20 8XP Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    327 Victoria Drive
    BN20 8XP Eastbourne
    East Sussex
    British29638810001
    RICHON, Stephane Andre
    32 Rue Adrien Chevalier
    St Malo
    35400
    France
    Amministratore
    32 Rue Adrien Chevalier
    St Malo
    35400
    France
    French125127640001
    SKILTON, Maurice, Councillor
    13 Meads Street
    BN20 7QY Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    13 Meads Street
    BN20 7QY Eastbourne
    East Sussex
    United KingdomBritish8396740001

    EASTBOURNE BUSES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 25 lug 2008
    Consegnato il 29 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a warehouse 5, birch road, eastbourne, east sussex t/no ESX24221.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 13 dic 2007
    Consegnato il 22 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Dennis dart plaxton single deck slf bus serial no SFD322BR1WGW12701 dennis dart uvg single deck slf bus serial no SFD322BR1WGW12737 daf SB220 ikarus single deck lf bus chassis no OH007106 for further details of chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alliance & Leicester Commercial Finance PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 mar 1998
    Consegnato il 09 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 ott 1986
    Consegnato il 29 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £575,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    Legal mortgage land and buildings at birchroad, eastbourne comprising a bus depot and offices with all fixtures plant and machinery. Floating charge the companys property including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Eastbourne Borough Council.
    Transazioni
    • 29 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 17 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 08 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 19 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 08 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 21 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 29 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 13 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 23 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0