THAMESMEAD TOWN

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHAMESMEAD TOWN
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale
    Numero di società 02002523
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THAMESMEAD TOWN?

    • (7011) /

    Dove si trova THAMESMEAD TOWN?

    Indirizzo della sede legale
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di THAMESMEAD TOWN?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2000

    Quali sono le ultime deposizioni per THAMESMEAD TOWN?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 set 2016

    6 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2016

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2015

    9 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2015

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2014

    6 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * Baker Tilly Ground Floor Meridien House 69-71 Clarendon Road Watford Herts WD17 1DS* in data 06 giu 2014

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2014

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2013

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2013

    6 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * Baker Tilly 1St Floor 46 Clarendon Road Watford WD17 1JJ* in data 16 apr 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2012

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2012

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2011

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2011

    6 pagine4.68

    Dimissioni di un liquidatore

    1 pagine4.33

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2010

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2010

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2009

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2009

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2008

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2008

    6 pagine4.68

    Chi sono gli amministratori di THAMESMEAD TOWN?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROBINSON, Keith Marshall
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    Segretario
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    British8282250001
    CHARNOCK, William Terence
    11 Burleigh Place
    Cambalt Road
    SW15 6ES London
    Amministratore
    11 Burleigh Place
    Cambalt Road
    SW15 6ES London
    EnglandBritish51990960001
    COX, Anthony
    28 Carronade Place
    Broadwaters
    SE28 0EE West Thamesmead
    London
    Amministratore
    28 Carronade Place
    Broadwaters
    SE28 0EE West Thamesmead
    London
    British56011290001
    SMITH, Jackie
    102 Glimpsing Green
    DA18 4HD Erith
    Kent
    Amministratore
    102 Glimpsing Green
    DA18 4HD Erith
    Kent
    British62032210001
    CROFTON, Derek Fergus Regan
    Wellmeade Oak Lane
    TN13 1UF Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Wellmeade Oak Lane
    TN13 1UF Sevenoaks
    Kent
    British13658170001
    CURRIE, Philip Andrew James
    Lansdowne
    Grayswood Road
    GU27 2BW Haselmere
    Surrey
    Segretario
    Lansdowne
    Grayswood Road
    GU27 2BW Haselmere
    Surrey
    British74930470001
    TEIDEMAN, Charles Richard
    27 Rochester Avenue
    BR1 3DB Bromley
    Kent
    Segretario
    27 Rochester Avenue
    BR1 3DB Bromley
    Kent
    British19125990001
    TUCKER, Maurice Furneaux
    4 Hanson Way
    HP21 9YE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    4 Hanson Way
    HP21 9YE Aylesbury
    Buckinghamshire
    British2385730001
    ANDERSON, Rosemary
    95 Coralline Walk
    SE2 9SX Thamesmead South
    London
    Amministratore
    95 Coralline Walk
    SE2 9SX Thamesmead South
    London
    British44074050001
    BEADLE, Paul Vincent
    171 Maran Way
    DA18 4BT Erith
    Kent
    Amministratore
    171 Maran Way
    DA18 4BT Erith
    Kent
    British53418370001
    BRIGHT, Gerald
    33 Linnet Close
    Thamesmead North
    SE28 8HY London
    Amministratore
    33 Linnet Close
    Thamesmead North
    SE28 8HY London
    British34371680002
    COTTON, Jeremy
    43 Whernside Close
    Thamesmead
    SE28 8HB London
    Amministratore
    43 Whernside Close
    Thamesmead
    SE28 8HB London
    British101812720001
    COX, Stuart Michael
    31 St Katherines Road
    DA18 4DS Erith
    Kent
    Amministratore
    31 St Katherines Road
    DA18 4DS Erith
    Kent
    British26962360001
    COX, Stuart Michael
    31 St Katherines Road
    DA18 4DS Erith
    Kent
    Amministratore
    31 St Katherines Road
    DA18 4DS Erith
    Kent
    British26962360001
    CROFTON, Derek Fergus Regan
    Wellmeade Oak Lane
    TN13 1UF Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Wellmeade Oak Lane
    TN13 1UF Sevenoaks
    Kent
    British13658170001
    CUMMING, John Alan
    8 Prince Consort Drive
    BR7 5SB Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    8 Prince Consort Drive
    BR7 5SB Chislehurst
    Kent
    British22511900001
    CURRIE, Philip Andrew James
    Lansdowne
    Grayswood Road
    GU27 2BW Haselmere
    Surrey
    Amministratore
    Lansdowne
    Grayswood Road
    GU27 2BW Haselmere
    Surrey
    EnglandBritish74930470001
    DANIELS, Patricia Helen
    87 Coralline Walk
    Thamesmead South
    SE2 9SX London
    Amministratore
    87 Coralline Walk
    Thamesmead South
    SE2 9SX London
    British23233990001
    DEVEREUX, Albert
    7 Longworth Close
    Thamesmead North
    SE28 8PE London
    Amministratore
    7 Longworth Close
    Thamesmead North
    SE28 8PE London
    British38854300001
    FOSTER, Carol Madelene
    8 Lytton Strachey Path
    Thamesmead
    SE28 8DU London
    Amministratore
    8 Lytton Strachey Path
    Thamesmead
    SE28 8DU London
    British23234000001
    GALLOWAY, Katharine Anne
    175 Mangold Way
    South Thamesmead
    DA18 4BG Erith
    Kent
    Amministratore
    175 Mangold Way
    South Thamesmead
    DA18 4BG Erith
    Kent
    British38856620001
    GAVIN, Austin Raymond
    1 Osney House
    Hartslock Drive Thamesmead South
    SE2 9XA London
    Amministratore
    1 Osney House
    Hartslock Drive Thamesmead South
    SE2 9XA London
    British43111880001
    GIBSON, Thomas
    1 Octavia Way
    Thamesmead
    SE28 8BU London
    Amministratore
    1 Octavia Way
    Thamesmead
    SE28 8BU London
    British57248970001
    GILL, Charan Joseph
    20 St Martins Close
    DA18 4DZ Erith
    Kent
    Amministratore
    20 St Martins Close
    DA18 4DZ Erith
    Kent
    British41913670001
    GILL, Charan Joseph
    20 St Martins Close
    DA18 4DZ Erith
    Kent
    Amministratore
    20 St Martins Close
    DA18 4DZ Erith
    Kent
    British41913670001
    GLASCOE, Philip Cecil Anthony
    3 Pointer Close
    Thamesmead
    SE28 8PN London
    Amministratore
    3 Pointer Close
    Thamesmead
    SE28 8PN London
    British33338260001
    HATHAWAY, Ian Charles
    119 Aspen Green
    DA18 4HU Erith
    Kent
    Amministratore
    119 Aspen Green
    DA18 4HU Erith
    Kent
    British26962350001
    HOLLOWAY, Keith
    Old Tile House Layters Way
    SL9 7QY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Old Tile House Layters Way
    SL9 7QY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British8749900001
    HUTCHINS, Maurice Raymond
    84 Whinchat Road
    Broadwaters Thamesmead West
    SE28 0EA London
    Amministratore
    84 Whinchat Road
    Broadwaters Thamesmead West
    SE28 0EA London
    British23234040001
    IRONS, Harold David
    33 Waterfield Close
    Thamesmead Central
    SE28 8DD London
    Amministratore
    33 Waterfield Close
    Thamesmead Central
    SE28 8DD London
    British38854320001
    KILLMAN, Valerie Olive
    28 Lensbury Way
    Thamesmead
    SE2 9SY London
    Amministratore
    28 Lensbury Way
    Thamesmead
    SE2 9SY London
    British115400180001
    LOMAX, Gregory James
    Watercroft 1a Marshal's Drive
    AL1 4RB St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Watercroft 1a Marshal's Drive
    AL1 4RB St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish49291200001
    MELLON, James, Sir
    32 Royal Terrace
    EH7 5AH Edinburgh
    Amministratore
    32 Royal Terrace
    EH7 5AH Edinburgh
    ScotlandBritish35900310001
    MOON, Anthony Maurice
    52 Nickelby Close
    SE28 8LY London
    Amministratore
    52 Nickelby Close
    SE28 8LY London
    British32982310001
    MOUNTFIELD, Peter
    Marchants Church Street
    Seal
    TN15 0AR Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Marchants Church Street
    Seal
    TN15 0AR Sevenoaks
    Kent
    British46934930001

    THAMESMEAD TOWN ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 18 feb 2000
    Consegnato il 25 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 mag 1993
    Consegnato il 28 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 61 hailey road, thamesmead, erith, kent, t/no: sgl 498134 and the proceeds of sale thereof by way of assignment the goodwill of the business together with the benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 19 ott 1992
    Consegnato il 23 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    41 hailey road, l/b of bexley title no.SGL498134 (part) and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 30 lug 1992
    Consegnato il 04 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and property k/a 2/6 griffin manor way thamesmead and 2/20 boughton road and 101/115 nathan way and units 1-12,119-121 nathan way thamesmead t/n part of ln 137615 and/or the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 nov 1988
    Consegnato il 08 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding sterling pounds 6,000,000
    Brevi particolari
    All those piece or parcels of f/h land and dwelling houses and flats erected thereon at thamesmead, l/b of bexley and greenwich. (See schedule attached to form 395 for full detals of the properties).
    Persone aventi diritto
    • Woolwich Equitable Building Society
    Transazioni
    • 08 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 02 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 21 set 1988
    Consegnato il 27 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    See schedule attached to form 395 for details of property charged (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Anglia Building Society
    Transazioni
    • 27 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 02 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 27 lug 1987
    Consegnato il 30 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the deed of covenant of even date.
    Brevi particolari
    Floating charge all undertaking and all property and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • London Residuary Body.
    Transazioni
    • 30 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 26 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    THAMESMEAD TOWN ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 mag 2003Inizio della liquidazione
    27 dic 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark John Wilson
    1st Floor
    Centinal
    WD17 1HE 46 Clarendon Road
    Watford
    Praticante
    1st Floor
    Centinal
    WD17 1HE 46 Clarendon Road
    Watford
    Andrew James Clifford
    Baker Tilly
    1st Floor, Centinal
    WD17 1HE 46 Clarendon Road
    Watford
    Praticante
    Baker Tilly
    1st Floor, Centinal
    WD17 1HE 46 Clarendon Road
    Watford

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0