TELEPHONE INFORMATION SERVICES PLC

TELEPHONE INFORMATION SERVICES PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTELEPHONE INFORMATION SERVICES PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 02003242
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TELEPHONE INFORMATION SERVICES PLC?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TELEPHONE INFORMATION SERVICES PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Kpmg Llp
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TELEPHONE INFORMATION SERVICES PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per TELEPHONE INFORMATION SERVICES PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Prenton Way Prenton CH43 3ET a Kpmg Llp 15 Canada Square London E14 5GL in data 08 gen 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 18 dic 2015

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 mar 2015

    Stato del capitale al 04 mar 2015

    • Capitale: GBP 350,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 mar 2014

    Stato del capitale al 17 mar 2014

    • Capitale: GBP 350,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Michael Howard Davies come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Janet Reid come segretario

    3 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Janet Dorothy Reid come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Marie Ross come segretario

    2 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di TELEPHONE INFORMATION SERVICES PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, Michael Howard
    c/o Scottish Power Ltd
    Atlantic Quay, Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    Scotland
    Segretario
    c/o Scottish Power Ltd
    Atlantic Quay, Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    Scotland
    British168272730001
    VENMAN, Marion
    Atlantic Quay
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    Amministratore
    Atlantic Quay
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    ScotlandBritish125700460002
    WARK, David Lewis
    c/o Scottish Power
    Atlantic Quay
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    Amministratore
    c/o Scottish Power
    Atlantic Quay
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    ScotlandBritish46723000002
    GREGG, Rhona
    25 Lammermuir Wynd
    ML9 1UT Larkhall
    Lanarkshire
    Segretario
    25 Lammermuir Wynd
    ML9 1UT Larkhall
    Lanarkshire
    British111591600001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    2 Darluith Park
    PA5 8DD Brookfield
    Renfreshire
    Segretario
    2 Darluith Park
    PA5 8DD Brookfield
    Renfreshire
    British77939460002
    JESSOP, Malcolm George
    Little Buckland
    Ugley Green
    CM22 6HL Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Segretario
    Little Buckland
    Ugley Green
    CM22 6HL Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British81463150001
    MACLEOD, David
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    Segretario
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    British32696310001
    MCCULLOCH, Alan William
    4 Dumbrock Road
    Strathblane
    G63 9EF Glasgow
    Segretario
    4 Dumbrock Road
    Strathblane
    G63 9EF Glasgow
    British66601950003
    MCPHERSON, Donald James
    14 Braid Drive
    Cardross
    G82 5QD Dumbarton
    Dunbartonshire
    Segretario
    14 Braid Drive
    Cardross
    G82 5QD Dumbarton
    Dunbartonshire
    British40519810004
    REID, Janet Dorothy
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1 Atlantic Quay
    Scotland
    Segretario
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1 Atlantic Quay
    Scotland
    British157091230001
    ROSS, Marie Isobel
    c/o Scottish Power
    Atlantic Quay
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    Segretario
    c/o Scottish Power
    Atlantic Quay
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    British42057170004
    SELBY, Adrian Harper
    81 Western Road
    Wolverton
    MK12 5AY Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    81 Western Road
    Wolverton
    MK12 5AY Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British10936800001
    WATERFIELD, Helen
    68 Harcourt Road
    E15 3DU London
    Segretario
    68 Harcourt Road
    E15 3DU London
    British67193500001
    ALLAN, William
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    Amministratore
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    UkBritish111131550001
    BERRY, Charles Andrew
    5 Grange Road
    Bearsden
    G61 3PL Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    5 Grange Road
    Bearsden
    G61 3PL Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish109780690001
    BROOKE, Michael John
    Woods Farm Windlesham Road
    GU24 8SY Chobham
    Surrey
    Amministratore
    Woods Farm Windlesham Road
    GU24 8SY Chobham
    Surrey
    EnglandBritish55934280001
    COCHRANE, Keith Robertson
    15 Brompton Terrace
    PH2 7DQ Perth
    Perthshire
    Amministratore
    15 Brompton Terrace
    PH2 7DQ Perth
    Perthshire
    British105823620001
    DUFFIELD, Sheelagh Jane
    197 Queen Victoria Drive
    Scotstounhill
    G14 9BP Glasgow
    Amministratore
    197 Queen Victoria Drive
    Scotstounhill
    G14 9BP Glasgow
    ScotlandBritish52720790003
    FAIRBAIRN, Anthony Martin
    The White House
    London Road Twyford
    RG10 9EL Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The White House
    London Road Twyford
    RG10 9EL Reading
    Berkshire
    British10936840001
    FARROW, Roger Thomas
    Woodentops 13 Matching Lane
    CM23 2PP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Woodentops 13 Matching Lane
    CM23 2PP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British71282140001
    HADDOW, Neil Scott
    104 Mearns Road
    Clarkston
    G76 7UP Glasgow
    Amministratore
    104 Mearns Road
    Clarkston
    G76 7UP Glasgow
    British53774190001
    HEASLEY, John
    17 Lawmarnock Crescent
    PA11 3AS Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Amministratore
    17 Lawmarnock Crescent
    PA11 3AS Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British100717000001
    JESSOP, Malcolm George
    Little Buckland
    Ugley Green
    CM22 6HL Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Little Buckland
    Ugley Green
    CM22 6HL Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British81463150001
    JONES, Steven Brent
    70 Frogmore Park Drive
    Blackwater
    GU17 0PJ Camberley
    Surrey
    Amministratore
    70 Frogmore Park Drive
    Blackwater
    GU17 0PJ Camberley
    Surrey
    British48323560001
    KRAFFT, Andy
    Highcroft 12 Old Bath Road
    Charvil
    RG10 9QR Twyford
    Berkshire
    Amministratore
    Highcroft 12 Old Bath Road
    Charvil
    RG10 9QR Twyford
    Berkshire
    British48697020001
    MCALOON, William Gerard
    10 Jacks View
    West Kilbride
    KA23 9HX Ayshire
    Ayrshire
    Amministratore
    10 Jacks View
    West Kilbride
    KA23 9HX Ayshire
    Ayrshire
    British108756350001
    MCLAREN, Janice Lewis
    73a Butler Road
    HA1 4DS West Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    73a Butler Road
    HA1 4DS West Harrow
    Middlesex
    British39053720001
    MCLEAN, Gregory Joseph
    Thame Cottage Grange Road
    Tilford
    GU10 2DQ Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Thame Cottage Grange Road
    Tilford
    GU10 2DQ Farnham
    Surrey
    British33612180001
    MCSWEEN, Angus
    5 Ellergreen Road
    Bearsden
    G61 2RU Glasgow
    Scotland
    Amministratore
    5 Ellergreen Road
    Bearsden
    G61 2RU Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish50499250001
    NISH, David Thomas
    Kiloran
    Houston Road
    PA13 4NY Kilmacolm
    Amministratore
    Kiloran
    Houston Road
    PA13 4NY Kilmacolm
    ScotlandBritish57316940002
    RICHARDS, William Samuel Clive
    Lower Hope
    Ullingswick
    HR1 3JF Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    Lower Hope
    Ullingswick
    HR1 3JF Hereford
    Herefordshire
    EnglandBritish70437990001
    RUSSELL, Ian Simon Macgregor
    73 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    73 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish38783050003
    STANLEY, Rupert James
    New School Farm
    6 Station Road Tilbrook
    PE28 0JT Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    New School Farm
    6 Station Road Tilbrook
    PE28 0JT Huntingdon
    Cambridgeshire
    UkBritish50448490001
    WHITEHEAD, David
    4 Farriers Drive
    CM12 0XZ Billericay
    Essex
    Amministratore
    4 Farriers Drive
    CM12 0XZ Billericay
    Essex
    British17689210002

    TELEPHONE INFORMATION SERVICES PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed.
    Creato il 22 set 1994
    Consegnato il 24 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to banque nationale de paris PLC under or pursuant to the performance of the lease.
    Brevi particolari
    The sum of twenty eight thousand eight hundred and ninety pounds (£28,890) or such further monies as may from time to time be due under a rent deposit deed datd 2ND september 1994.
    Persone aventi diritto
    • Banque Nationale De Paris PLC,
    Transazioni
    • 24 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 19 apr 1994
    Consegnato il 21 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 24 feb 1994
    Consegnato il 26 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 24TH february 1994
    Brevi particolari
    The sum of £16590 due under a rent deposit.
    Persone aventi diritto
    • Banque Nationale De Paris PLC
    Transazioni
    • 26 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 feb 1993
    Consegnato il 17 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 28 feb 1989
    Consegnato il 03 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    180 line brite voice system serial numbers 500115 500454 500112 500529 500019 423349 500094 201408 45 eurologic 4 line paytone boards.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 18 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 feb 1987
    Consegnato il 10 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific and equitable charge over the f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, goodwill and the benefit of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co.
    Transazioni
    • 10 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 18 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TELEPHONE INFORMATION SERVICES PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 dic 2015Inizio della liquidazione
    23 nov 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Blair Carnegie Nimmo
    Saltire Court, 20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Praticante
    Saltire Court, 20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Gerard Anthony Friar
    Kpmg Restructuring Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Praticante
    Kpmg Restructuring Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0