PH HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPH HOMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02003672
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PH HOMES LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova PH HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Norcliffe House
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PH HOMES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    QUALITY CARE HOMES LIMITED07 lug 198807 lug 1988
    MEALDRAM LIMITED25 mar 198625 mar 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di PH HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per PH HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Ian Richard Smith come amministratore in data 15 feb 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 dic 2015

    Stato del capitale al 29 dic 2015

    • Capitale: GBP 137.67
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 ott 2015

    • Capitale: GBP 137.67
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share premium account 29/09/2015
    RES13

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Richard Smith il 19 feb 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Robert Taberner il 18 feb 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 dic 2014

    Stato del capitale al 13 dic 2014

    • Capitale: GBP 1,376,692.7
    SH01

    Cessazione della carica di Dominic Jude Kay come amministratore in data 31 ott 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    13 pagineAA

    Cessazione della carica di Dominic Kay come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Abigail Mattison come segretario

    2 pagineAP03

    Dettagli del direttore cambiati per Maureen Claire Royston il 22 mag 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* in data 21 feb 2014

    1 pagineAD01

    Nomina di Maureen Claire Royston come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 dic 2013

    Stato del capitale al 05 dic 2013

    • Capitale: GBP 1,376,692.7
    SH01

    Chi sono gli amministratori di PH HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188574870001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    Amministratore
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    United KingdomBritishCompany Director184190020002
    TABERNER, Benjamin Robert
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritishChartered Accountant150511890001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    BritishCommercial Director38256680007
    DARK, Anthony Hedley
    57 Crescent Lane
    SW4 9PT Clapham
    London
    Segretario
    57 Crescent Lane
    SW4 9PT Clapham
    London
    British84286690001
    GOSLING, Mark David
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    Segretario
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    BritishCompany Secretary66801660001
    JAP, Chee Miau
    33 Cheyne Place
    SW3 4HL London
    Segretario
    33 Cheyne Place
    SW3 4HL London
    Singaporean37858790001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Segretario
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    BritishSolicitor145920530001
    PARK, Sonya C
    138 Dalston Lane
    E8 1NG London
    Segretario
    138 Dalston Lane
    E8 1NG London
    AmericanLawyer75811580001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    ANSTEAD, Hamilton Douglas
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director107751890001
    BAILEY JR, Essel William
    1 Hillside Court
    Ann Arbor
    Mi
    48104
    Usa
    Amministratore
    1 Hillside Court
    Ann Arbor
    Mi
    48104
    Usa
    AmericanCompany Director82601840001
    BANNATYNE, Duncan Walker
    55 Cleveland Avenue
    DL3 7HF Darlington
    County Durham
    Amministratore
    55 Cleveland Avenue
    DL3 7HF Darlington
    County Durham
    BritishDirector53468760002
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Amministratore
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCeo131468590001
    CHAPMAN, Clive Richard
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    Amministratore
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    United KingdomBritishDirector86129050001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director38256680007
    ELLIOTT, Graham Nicholas
    9 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    Amministratore
    9 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    EnglandBritishDirector Of Operations Omega38064300002
    FALLON, Michael Cathel
    The Manor House Church Road
    Sundridge
    TN14 6EA Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    The Manor House Church Road
    Sundridge
    TN14 6EA Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishDirector32022290002
    FLAHERTY, James Paul
    28 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HF London
    Amministratore
    28 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HF London
    AmericanCeo Omega Uk Ltd52843400002
    FRANKE, Thomas Frederick
    410 North Eagle Street
    49068 Marshall
    Michigan
    Usa
    Amministratore
    410 North Eagle Street
    49068 Marshall
    Michigan
    Usa
    United KingdomAmericanProperty Developer50747000001
    GOTTESMAN, Arthur Edward
    38 Chester Terrace
    Regents Park
    NW1 4ND London
    Amministratore
    38 Chester Terrace
    Regents Park
    NW1 4ND London
    AmericanLawyer35293490001
    GROSSART, Hamish Mcleod
    13 Comely Bank
    EH4 1AN Edinburgh
    Amministratore
    13 Comely Bank
    EH4 1AN Edinburgh
    BritishBanker37900001
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Amministratore
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritishChief Executive131288260001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Amministratore
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritishSolicitor145920530001
    MAXWELL, Barbara Ann
    17 Crieff Road
    SW18 2EB London
    Amministratore
    17 Crieff Road
    SW18 2EB London
    IrishCompany Director41693200001
    MCCUE, Joanne
    The Lindens
    34 Carmel Road South
    DL3 8DJ Darlington
    County Durham
    Amministratore
    The Lindens
    34 Carmel Road South
    DL3 8DJ Darlington
    County Durham
    BritishNursing Director75483030001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritishDirector145102120001
    MOWAT, Magnus
    New Park House
    Whitegate
    CW8 2AY Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    New Park House
    Whitegate
    CW8 2AY Northwich
    Cheshire
    BritishDirector24768090001
    NORMAN, Ronald, Sir
    Hart On The Hill
    Dalton Piercy
    TS27 3HY Hartlepool
    Cleveland
    Amministratore
    Hart On The Hill
    Dalton Piercy
    TS27 3HY Hartlepool
    Cleveland
    BritishDirector7751790001
    POULTON, Christopher
    Bells Farm Bells Farm Road
    TN11 0JR Hadlow
    Kent
    Amministratore
    Bells Farm Bells Farm Road
    TN11 0JR Hadlow
    Kent
    BritishRetired52738600001
    ROOT, Christopher
    29 Selwyn Avenue
    TW9 2HB Richmond
    Surrey
    Amministratore
    29 Selwyn Avenue
    TW9 2HB Richmond
    Surrey
    BritishFinancial Director Omega Uk53779540001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Amministratore
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishAccountant103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    Garden View
    5a Pelling Hill
    SL4 2LL Old Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    Garden View
    5a Pelling Hill
    SL4 2LL Old Windsor
    Berkshire
    IrishManaging Director80396000001
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritishCompany Director181082310001
    STONEHOUSE, David Coulson
    44 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    44 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishGroup Finance Director44113920001

    PH HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Agreement
    Creato il 16 set 2004
    Consegnato il 06 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Each security provider assigns the collateral to the lender being each policy and all monies, property and benefits that have accrued and are receivable and that may accrue and be receivable under that policy from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited
    Transazioni
    • 06 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Agreement
    Creato il 16 set 2004
    Consegnato il 06 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right, title, interest and benefit, present and future in and to its collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited
    Transazioni
    • 06 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 set 2004
    Consegnato il 04 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited
    Transazioni
    • 04 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed
    Creato il 06 set 2002
    Consegnato il 14 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 14 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of security
    Creato il 15 giu 1998
    Consegnato il 30 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of them pursuant to the facility documents (as defined) or any of them
    Brevi particolari
    All rights title and interest in and to and the benefit of each and all the assigned documentsand letters of credit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 feb 1998
    Consegnato il 06 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Harbour view lodge nursing home fairview bransty whitehaven cumbria t/n-CU119751.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 feb 1998
    Consegnato il 06 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Northlea court nursing home northumbrian road cramlington northumberland t/n-ND98305.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 feb 1998
    Consegnato il 06 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Southfield court nursing home southfield road huddersfield t/n-WYK585410.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 feb 1998
    Consegnato il 06 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The braeside nursing home tweedmouth berwick on tweed t/n-ND97906.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over a deposit (own account)
    Creato il 22 nov 1996
    Consegnato il 26 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The balance standing to the credit of deposit acct/no 15754170 in the name of the company with the chargee at teesside business banking centre,high street chambers,frinkle st,stockton on tees,cleveland TS18 1AR.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a eastbourne nursing home 7 cobden street darlington the goodwill of all businesses the benefit of all licences, fixtures, fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a burlam road nursing home 111 and 113 burlam road middlesbrough the goodwill of all businesses the benefit of all licences, fixtures, fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a the laurels and regents view nursing home francis way houghton le spring the goodwill of all businesses the benefit of all licences, fixtures, fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a marton road nursing home marton road middlesborough the goodwill of all businesses the benefit of all licences, fixtures, fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a peterlee nursing home and wescott nursing home westcott road peterlee the goodwill of all businesses the benefit of all licences, fixtures fittings plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a warrior park nursing home seaton carew the goowill of all businesses the benefit of all licences, fixtures, fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a herrington grange and the mews north of travers street sunderland the goodwill of all businesses the benefit of all licences, fixtures, fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a roseworth nursing home roseworth stockton on tees the goodwill of all businesses the benefit of all licences, fixtures, fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a byker hall nursing home and lawrence court nursing home allendale road newcastle the goodwill of all businesses the benefit of all licences, fixtures, fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a bannatyne lodge manorway peterlee the goodwill of all businesses the benefit of all licences, fixtures, fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a elswick hall wentworth road elswick the goodwill of all businesses the benefit of all licences, fixtures, fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a swan lodge and hunter hall kent avenue newcastle upon tyne the goodwill of all businesses the benefit of all licences, fixtures, fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a chasedale tynedale drive blyth the goodwill of all businesses the benefit of all licences, fixtures, fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a rydal dodmire junior school darlington the goodwill of all businesses the benefit of all licences, fixtures, fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 09 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a brandon lodge commercial street brandon county durham the goodwill of all businesses the benefit of all licences, fixtures, fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0