CASSELL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CASSELL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02004498 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CASSELL LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CASSELL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Carmelite House 50 Victoria Embankment EC4Y 0DZ London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CASSELL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TESTOPTION PUBLIC LIMITED COMPANY | 26 mar 1986 | 26 mar 1986 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CASSELL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per CASSELL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ott 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2020 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2019 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ott 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 130 Park Drive, Milton Park Milton Abingdon Oxfordshire OX14 4SE England a Hachette Uk Distribution Milton Road Didcot OX11 7HH | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ott 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ott 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 130 Park Drive, Milton Park Milton Abingdon Oxfordshire OX14 4SE | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Pierre De Cacqueray il 15 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Pierre De Cacqueray il 13 apr 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Pierre De Cacqueray il 13 apr 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Orion House 5 Upper Saint Martins Lane London WC2H 9EA a Carmelite House 50 Victoria Embankment London EC4Y 0DZ in data 13 apr 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Pierre De Cacqueray come segretario in data 20 mar 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rowena Swallow come segretario in data 20 mar 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CASSELL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE CACQUERAY, Pierre | Segretario | 50 Victoria Embankment EC4Y 0DZ London Carmelite House England | 196054920001 | |||||||
| DE CACQUERAY, Pierre | Amministratore | 50 Victoria Embankment EC4Y 0DZ London Carmelite House England | England | French | 101089070002 | |||||
| DASS, Pardip | Segretario | 90 Primrose Avenue RM6 4QD Romford Essex | British | 109629050001 | ||||||
| JARVIS, Clare | Segretario | Orion House 5 Upper Saint Martins Lane WC2H 9EA London | 160846790001 | |||||||
| O'SULLIVAN, Matthew | Segretario | 23 Palmerston Road East Sheen SW14 7QA London | British | 46307060001 | ||||||
| OLIVER, Ian Andrew | Segretario | 175 Wickham Chase BR4 0BH West Wickham Kent | British | 71274770001 | ||||||
| PRIOR, Mark | Segretario | 38 Merton Road SW18 1QX London | British | 105616980001 | ||||||
| RONEY, Francis John | Segretario | 88 Woodford Crescent HA5 3TY Pinner Middlesex | British | 20431110001 | ||||||
| SWALLOW, Rowena | Segretario | Orion House 5 Upper Saint Martins Lane WC2H 9EA London | 179506830001 | |||||||
| BINNIE, Stewart John | Amministratore | 36 Glebe Road Barnes SW13 0EA London | England | British | 131771340001 | |||||
| CHEETHAM, Anthony John Valerian | Amministratore | 8 Morpeth Mansions Morpeth Terrace SW1 1ER London | United Kingdom | British | 104796990001 | |||||
| JAEGER, Stephen Owen | Amministratore | 11 Topstone Road Redding Connecticut 06896 FOREIGN Usa | American | 59629570001 | ||||||
| JAKES, Clifford Duncan | Amministratore | Deeracres Lisle Court Road SO41 5SH Lymington Hampshire | United Kingdom | British | 8426370002 | |||||
| O'SULLIVAN, Matthew | Amministratore | 23 Palmerston Road East Sheen SW14 7QA London | British | 46307060001 | ||||||
| ROCHE, Peter Charles Kenneth | Amministratore | 20 Leigh Hill Road KT11 2HX Cobham Field House Surrey | United Kingdom | British | 5584640002 | |||||
| RONEY, Francis John | Amministratore | 88 Woodford Crescent HA5 3TY Pinner Middlesex | British | 20431110001 | ||||||
| STURROCK, Philip James | Amministratore | Flat 14 11 Avenue Road AL1 3QG St Albans Hertfordshire | British | 42327750001 | ||||||
| SWALLOW, Rowena Gay | Amministratore | Orion House 5 Upper Saint Martins Lane WC2H 9EA London | England | British | 179492200001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CASSELL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Orion Publishing Group Limited | 06 apr 2016 | Victoria Embankment EC4Y 0DZ London 50 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CASSELL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Creato il 05 ott 1992 Consegnato il 16 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 09 lug 1991 Consegnato il 20 lug 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 26 mar 1990 Consegnato il 04 apr 1990 | Parzialmente soddisfatta | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge on all the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Instrument | Creato il 26 mag 1989 Consegnato il 06 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,444,300 secured loan stock 1991/1995 due from the company to the stock holders under the terms of the charge. | |
Brevi particolari Undertaking, property & assets, goodwill including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 04 mar 1987 Consegnato il 17 mar 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,083,000 and all other monies due or to become due in respect of loan stock 1990/1994 pursuant tothe terms of the instrument dated 4/3/87. | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 17 ago 1986 Consegnato il 01 set 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0