CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02005951 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Two Snowhill Snowhill Queensway B4 6GA Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ALFRED MCALPINE HOMES SOUTHERN LIMITED | 01 mar 1989 | 01 mar 1989 |
| CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED | 02 apr 1986 | 02 apr 1986 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 14 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Gate House Turnpike Road High Wycombe Buckinghamshire HP12 3NR a Two Snowhill Snowhill Queensway Birmingham B4 6GA in data 25 gen 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ United Kingdom a Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 nov 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Colin Richard Clapham come segretario in data 05 dic 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh come segretario in data 05 dic 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Robert Andrew come amministratore in data 17 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Colin Richard Clapham come amministratore in data 17 lug 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD United Kingdom a 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Segretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 219943480001 | |||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 9684390001 | |||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 34521340004 | |||||
| CARR, Peter Anthony | Segretario | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Segretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | Other | 135438270002 | ||||||
| HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Segretario | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | 76844970003 | ||||||
| HILL, Timothy John | Segretario | 7 Claremont Gardens Purbrook PO7 5LL Waterlooville Hampshire | British | 47617100002 | ||||||
| JORDAN, James John | Segretario | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| PHILLIPS, James | Segretario | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | 8364990001 | ||||||
| WHITE, Ian Michael | Segretario | 4 Garden Close Knowle B93 9QF Solihull West Midlands | British | 10543120002 | ||||||
| ANDREW, Peter Robert | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 113503830003 | |||||
| BURTON, Anthony William Rawes | Amministratore | Foxs Hangout Mislingford Road SO32 2QD Swanmore Hampshire | England | British | 75468170001 | |||||
| CARNEY, Christopher | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125216670001 | |||||
| CARR, Peter Anthony | Amministratore | 551 Avebury Boulevard MK9 3DR Milton Keynes Beech House Buckinghamshire England | England | British | 130306120001 | |||||
| FLOWER, Terry Victor | Amministratore | 30 Apsley Grove Dorridge B93 8QP Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 75464950001 | |||||
| FRESHNEY, Michael John | Amministratore | Apple Orchard 136 Brox Road Ottershaw KT16 0LG Chertsey Surrey | England | British | 45689190001 | |||||
| GROVE, Eric William | Amministratore | The Rye House Catesby Lane Lapworth B94 5QY Solihull West Midlands | England | British | 632880001 | |||||
| HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Amministratore | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | 76844970003 | ||||||
| HOUGH, Timothy | Amministratore | 5 Barton Drive Knowle B93 0PE Solihull West Midlands | British | 38408080002 | ||||||
| JENKINS, Stephen Adrian | Amministratore | Kingsview Manor Road HP10 8JA Penn Buckinghamshire | United Kingdom | British | 49738660003 | |||||
| JORDAN, James John | Amministratore | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British | 120602100002 | |||||
| MCCALLUM, Graeme Reid | Amministratore | The Poplars Whinfield Road Dodford B61 9BG Bromsgrove Worcestershire | United Kingdom | British | 152856250001 | |||||
| MILLS, Stanley | Amministratore | Whitegates Wixford B49 6DA North Alcester Warwickshire | British | 573140004 | ||||||
| MURRIN, Jonathan Charles | Amministratore | 10 Silhill Hall Road B91 1JU Solihull West Midlands | British | 115863170001 | ||||||
| PEACOCK, Raymond Anthony | Amministratore | 9 Grosvenor Road Finchley N3 1EY London | United Kingdom | British | 75750250002 | |||||
| PHILLIPS, James | Amministratore | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | 8364990001 | ||||||
| REDFERN, Peter Timothy | Amministratore | 5 Broadfield Road OX5 1UL Yarnton Oxfordshire | British | 74208670003 | ||||||
| SUTCLIFFE, Ian Calvert | Amministratore | Windlesham Lodge Westwood Road GU20 6LX Windlesham Surrey | United Kingdom | British | 112534590002 | |||||
| WHITE, Ian Michael | Amministratore | 4 Garden Close Knowle B93 9QF Solihull West Midlands | British | 10543120002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mca Holdings Limited | 06 apr 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of composite guarantee and debenture | Creato il 29 ott 1991 Consegnato il 06 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £10,000,000 and all other monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the loan agreement dated 29/10/91 | |
Brevi particolari All stocks, shares, bonds and securities and all other interests, the undertaking and all freehold and leasehold property and any other options (see doc M579 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee & debenture | Creato il 30 nov 1988 Consegnato il 06 dic 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Sequitable mortgage | Creato il 21 giu 1988 Consegnato il 23 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 186/196 ashley road parkstone poole dorset with all buildings & fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Equitable mortgage | Creato il 09 giu 1988 Consegnato il 23 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property k/a land formerly forming part of chalk pit farm whitepanish wiltshire together with all buildings & fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 28 mar 1988 Consegnato il 05 apr 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on east side of telegraph road, west end southampton. Title no: hp 317775. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Memo of deposit | Creato il 30 set 1987 Consegnato il 01 ott 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land lying to the north east of abbey road west moors wimborne dorset. Title no dt 130559 ayalea restaurant ringwood road west moors wimborne dorset title no dt 130882 41 abbey road west moors wimborne dorset title no dt 126066. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 06 gen 1987 Consegnato il 07 gen 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Plots 8,10,11 & 12 avon park off hum road ashley heath, ringwood hampshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 26 nov 1986 Consegnato il 02 dic 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Plots 3-7 avon park off hurn road, ashley heath, ringwood, hampshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 29 set 1986 Consegnato il 03 ott 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Area 2.8 phases 2 & 3 chandler's ford growth area, test valley, hampshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0