GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED

GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02006409
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    • (5530) /

    Dove si trova GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GROUPE CHEZ GERARD LIMITED09 set 199109 set 1991
    LAKEBIRD LEISURE LIMITED13 giu 198613 giu 1986
    LAKEBIND LIMITED03 apr 198603 apr 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 gen 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    GAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    32 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 ott 2013

    26 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 23 ott 2012

    35 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 mag 2012

    39 pagine2.24B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    61 pagine2.17B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    61 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    15 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da * 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH* in data 05 dic 2011

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Provision of articles hereby revoked 29/09/2011
    RES13
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 29 set 2011

    • Capitale: GBP 15,992,000
    4 pagineSH01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 29 set 2011

    • Capitale: GBP 492,000.0
    SH01

    Bilancio redatto al 02 gen 2011

    20 pagineAA

    legacy

    10 pagineMG01

    Nomina di Mr Stephen Rushworth Smith come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di William Rollason come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 29 giu 2010 al 29 dic 2010

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr William Rollason come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Simon George Rowe come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Phillips come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Hill come segretario

    2 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROWE, Simon George
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8-10
    Amministratore
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8-10
    EnglandBritish68119020002
    SMITH, Stephen Rushworth
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    Amministratore
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    United KingdomBritish6894950002
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Segretario
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    British148079910001
    GAMBLE, Stephen
    92 Bressey Grove
    South Woodford
    E18 2HX London
    Segretario
    92 Bressey Grove
    South Woodford
    E18 2HX London
    British106836430001
    GARDNER, Douglas Charles
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    Segretario
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    British75225920001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Segretario
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    British130983750001
    HOLDER, Ian Keith
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    Segretario
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    British60759970001
    ISAACSON, Laurence Ivor
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    Segretario
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    British2996380001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Segretario
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    British62321110002
    ABRAHAM, Neville Victor
    Avenue Louise 368
    1050 Bruxelles
    Belgium
    Amministratore
    Avenue Louise 368
    1050 Bruxelles
    Belgium
    British10579160003
    ABRAHAM, Neville Victor
    82 Addison Road
    W14 8ED London
    Amministratore
    82 Addison Road
    W14 8ED London
    United KingdomBritish10579160002
    BASING, Nicholas Andrew
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    Amministratore
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    EnglandBritish140766360001
    BERTORELLI, Adrian Peter
    2 Bayhurst Drive
    HA6 3SA Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    2 Bayhurst Drive
    HA6 3SA Northwood
    Middlesex
    British15898860001
    BINDER, Simon
    Flat 89
    15 Portman Square
    W1H 6LL London
    Amministratore
    Flat 89
    15 Portman Square
    W1H 6LL London
    United KingdomBritish97451910001
    BROWN, Christopher Niall Bridgmore
    Mallards
    Spade Oak Reach
    SL6 9RQ Cookham
    Berkshire
    Amministratore
    Mallards
    Spade Oak Reach
    SL6 9RQ Cookham
    Berkshire
    EnglandBritish99369900001
    DA COSTA, Michael Phillip
    Flat 4 Saint John's Lodge
    Harley Road
    NW3 3BY London
    Amministratore
    Flat 4 Saint John's Lodge
    Harley Road
    NW3 3BY London
    British26140900002
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Amministratore
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    United KingdomBritish148079910001
    EDWARDS, Terence David
    29 Morley Road
    SM3 9LN Sutton
    Surrey
    Amministratore
    29 Morley Road
    SM3 9LN Sutton
    Surrey
    British15898850001
    ENGLISH, Tina
    8 Kensington Court Place
    Kensington
    W8 5BJ London
    Amministratore
    8 Kensington Court Place
    Kensington
    W8 5BJ London
    British98725570001
    FARROW, Edmund John
    4 Park View 31 Chivalry Road
    SW11 1HT London
    Amministratore
    4 Park View 31 Chivalry Road
    SW11 1HT London
    British51885010001
    GARDNER, Douglas Charles
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    British75225920001
    HAND, Alan
    Ivy Cottage
    3 St Thomas Street
    OX15 0SY Deddington
    Oxfordshire
    Amministratore
    Ivy Cottage
    3 St Thomas Street
    OX15 0SY Deddington
    Oxfordshire
    Irish102272320001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Amministratore
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    EnglandBritish130983750001
    HOLDER, Ian Keith
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    Amministratore
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    British60759970001
    ISAACSON, Laurence Ivor
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    Amministratore
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    United KingdomBritish2996380001
    JELFFS-SHUCKBURGH, Deborah Ann
    6 Brook Valley
    Mid Holmwood
    RH5 4EZ Dorking
    Surrey
    Amministratore
    6 Brook Valley
    Mid Holmwood
    RH5 4EZ Dorking
    Surrey
    British77499800001
    LEDERER, John David
    272 Lillie Road
    SE6 7PX London
    Amministratore
    272 Lillie Road
    SE6 7PX London
    United KingdomBritish86140390001
    MCKAY, Nicholas Adrian Richard
    48 Rawlings Street
    Chelsea
    SW3 2LS London
    Amministratore
    48 Rawlings Street
    Chelsea
    SW3 2LS London
    British14633330001
    MILNER, Pauline Alice
    31 Roupell Street
    SE1 8TB London
    Amministratore
    31 Roupell Street
    SE1 8TB London
    United KingdomBritish51885090002
    MIRRELSON, Joseph Bernard
    107 Cheyne Walk
    SW10 0DJ Chelsea
    London
    Amministratore
    107 Cheyne Walk
    SW10 0DJ Chelsea
    London
    British40430150001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Amministratore
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    PHILLIPS, Mark Randall
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish80508130001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish62321110002
    ROLLASON, William
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    Amministratore
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    United KingdomBritish140347580001
    WHITLEY, Clare Elizabeth
    42 Cornwall Gardens
    SW7 4AA London
    Amministratore
    42 Cornwall Gardens
    SW7 4AA London
    British48012620002

    GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A supplemental security, accession and confirmation deed
    Creato il 22 set 2011
    Consegnato il 28 set 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor, with full title guarantee, in favour of the security trustee (as trustee for the finance parties), hereby respectively charged on the terms set out in the relevant charging clause of the relevant security documents its assets as more specifically referred to in the relevant security documents, the secured liabilities see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 17 lug 2009
    Consegnato il 27 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 set 2006
    Consegnato il 05 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each security provider to the senior finance parties and the mezzanine finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 15 dic 2005
    Consegnato il 17 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 35, 36 and 45 the market covent garden london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 22 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal charge
    Creato il 15 dic 2005
    Consegnato il 16 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the junior finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The mortgaged property being unit 35, 36 and 45 the market covent garden london, the plant and machinery, any goodwill, rental and other money payable and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Starlight Investments Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 16 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 set 2005
    Consegnato il 05 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property at 1 watling street, st paul's, london t/no NGL800172. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 ago 2005
    Consegnato il 02 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the junior finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Unit 6 whitehouse apartments, 9 belvedere road, southbank t/n TGL165663, hasilwood house, 60/64 bishopsgate t/n NGL751095 and 119/120 chancery lane t/n NGL767272 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Starlight Investments Limited (Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 mag 2005
    Consegnato il 27 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 05 nov 2003
    Consegnato il 15 nov 2003
    In corso
    Importo garantito
    £62,500.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    An account set up pursuant to a rent deposit deed.
    Persone aventi diritto
    • Personal Pension Management Limited
    Transazioni
    • 15 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 09 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 ott 2001
    Consegnato il 30 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 24 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer deed
    Creato il 29 ott 1993
    Consegnato il 15 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charges upon; all the property and/or assets of the company listed on the schedule together with all buildings,fixtures and fixed plant and machinery. All other present and f/h and l/h property of the company all the company's present and future goodwill and uncalled capital. Floating charges upon all theundertaking and assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 ago 1989
    Consegnato il 22 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Part basement ground & first floors 11/13 frith st. & 3/5 bateman st. London W1 with fixed plant machinery & other fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 22 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 ago 1989
    Consegnato il 22 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ground floor & basement 39, panton st. London SW1 fixed plant machinery & other fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 22 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 ago 1989
    Consegnato il 22 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    44A & 44B floral street london WC2 fixed plant machinery & other fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 22 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 ago 1989
    Consegnato il 17 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 17 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 lug 1989
    Consegnato il 21 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Twenties publis house, 39, ranelagh grove, london, SW1.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 21 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 09 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 lug 1989
    Consegnato il 20 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Part ground floor and whole of basement, 119/120 chancery lane, london WC2. Together with the fixed plant, machinery and other fixtures goodwill of the business if any and stocks of building materials.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 20 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 lug 1989
    Consegnato il 20 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Part 31 dover street london W1 t/n ngl 339791 together with fixed plant, machinery and other fixtures goodwill of the business if any stocks of building materials.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 20 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 lug 1989
    Consegnato il 20 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    8 charlotte street, fitzroy square, st pancras, london W1. T/n 64653 together with fixed plant, machinery and other fixtures goodwill of the business if any and stocks of building materials.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 20 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 feb 1988
    Consegnato il 26 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    44A floral street london WC2.
    Transazioni
    • 26 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 26 feb 1988
    Consegnato il 26 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    11-13 frith street london W1.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 26 feb 1988
    Consegnato il 26 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    39 panton street london SW1.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 15 feb 1988
    Consegnato il 26 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 12 ago 1987
    Consegnato il 26 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/as being 11/13 frith street and 3/5 bateman street, london W1 including the entirley of the property comprised is a lease dated 14.10.86 of all buildings & fixtures thereon & by way of assignment the goodwill of the business carried on at the above property & the full benefit of all present and future licences held in connection with the said business or any other business carried on at the above.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1987Registrazione di un'ipoteca

    GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 nov 2011Inizio dell'amministrazione
    24 ott 2012Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew David Smith
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    DataTipo
    24 ott 2012Inizio della liquidazione
    16 ago 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew David Smith
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0