SUPERIOR FOOD LIMITED

SUPERIOR FOOD LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUPERIOR FOOD LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02006417
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUPERIOR FOOD LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SUPERIOR FOODS LIMITED02 mag 199602 mag 1996
    SPURHART LIMITED03 apr 198603 apr 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Martin Johnson come amministratore in data 03 giu 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Diarmuid Brendan Conifrey come amministratore in data 24 giu 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Diarmuid Brendan Conifrey come amministratore in data 08 apr 2020

    2 pagineAP01

    Ordinanza giudiziaria

    S1096 Court Order to Rectify
    6 pagineOC

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    22 pagineAA

    legacy

    pagineANNOTATION

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 set 2017

    22 pagineAA

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    legacy

    47 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2017 al 30 set 2017

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    29 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Mark Ian Tentori come amministratore in data 27 apr 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gavin Cox come segretario in data 08 mar 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Gavin Eliot Cox come amministratore in data 07 mar 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Martin Johnson come amministratore in data 25 feb 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 feb 2016

    Stato del capitale al 09 feb 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Mr Mark Ian Tentori come amministratore in data 06 ott 2015

    2 pagineAP01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Agreement 25/09/2015
    RES13

    Chi sono gli amministratori di SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Segretario
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165756710001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    Segretario
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150500890001
    TAYLOR, Michael Dennis
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British18385410004
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    Segretario
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    116685100001
    CHISAMBI, Rodgers Yalamila
    Flat 7
    30 Longridge Road
    SW5 9SJ Earls Court
    London
    Amministratore
    Flat 7
    30 Longridge Road
    SW5 9SJ Earls Court
    London
    Zambian77986900001
    CONIFREY, Diarmuid Brendan
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Amministratore
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandIrish268799160001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Amministratore
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritish153840250001
    FEE, Paul
    285 Yorktown Road
    College Town
    GU47 0QA Sandhurst
    Berkshire
    Amministratore
    285 Yorktown Road
    College Town
    GU47 0QA Sandhurst
    Berkshire
    British55281590001
    GUY, David Simon
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    British119214340001
    HALL, Fraser Scott
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    British4578740001
    HAZELDEAN, William James
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish83660790002
    JOHNSON, Martin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Amministratore
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritish140167360001
    KINGSLEY BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritish132962170001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish157009150001
    MELLORS, William Peter Stewart
    5 Limetree Court
    103 Straight Road
    SL4 2SS Old Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    5 Limetree Court
    103 Straight Road
    SL4 2SS Old Windsor
    Berkshire
    British107055640001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritish51784930002
    NELSON, Finlay Macarthur
    Stamford Road
    Barnack
    PE9 3HA Stamford
    Quarry House
    Lincolnshire
    Amministratore
    Stamford Road
    Barnack
    PE9 3HA Stamford
    Quarry House
    Lincolnshire
    EnglandBritish132363820001
    NUDDS, Anthony John
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    Amministratore
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    British62512350001
    NUDDS, Anthony John
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    Amministratore
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    British62512350001
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Amministratore
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    British96978470001
    SINCLAIR, John Frederick
    16 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    Amministratore
    16 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    British17581780001
    SWAINSTON, Keith Graham
    19 Bedford Street
    SG5 2JG Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    19 Bedford Street
    SG5 2JG Hitchin
    Hertfordshire
    British81821290001
    TAYLOR, Agatha
    Woodstock Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Woodstock Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British58350880001
    TAYLOR, Michael Dennis
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British18385410004
    TENTORI, Mark Ian
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Amministratore
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritish119564310001
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Amministratore
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    EnglandBritish63844650001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    British37845970003
    WEBB, Robert John
    5 Underwood Cottages
    The Coombe, Streatley
    RG8 9RA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    5 Underwood Cottages
    The Coombe, Streatley
    RG8 9RA Reading
    Berkshire
    British65669490001
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Amministratore
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritish232132390001
    WORT, Edward George
    28 Crown Meadow
    Colnbrook
    SL3 0LT Slough
    Berkshire
    Amministratore
    28 Crown Meadow
    Colnbrook
    SL3 0LT Slough
    Berkshire
    British77987180001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Superior Food Group Limited
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    06 apr 2016
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies
    Numero di registrazione05288249
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    SUPERIOR FOOD LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 05 mar 2015
    Consegnato il 11 mar 2015
    In corso
    Breve descrizione
    None.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 11 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 07 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    A fixed charge over all land (I.E. any interest in heritable, freehold or leasehold land) vested in or charged to superior food limited, owned now or in the future. This includes all fixtures and fittings attached to the land and all rents receivable from any lease granted out of the land.. A fixed charge, subject to third party consents, over all intellectual property of superior food limited, owned now or in the future.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 07 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 05 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Punjab National Bank (International) Limited
    Transazioni
    • 05 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 11 apr 2012
    Consegnato il 14 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor or any future obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 11 apr 2012
    Consegnato il 14 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit, a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transazioni
    • 14 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 apr 2008
    Consegnato il 02 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Duke Street Capital General Partner Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 02 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture accession deed
    Creato il 16 feb 2007
    Consegnato il 05 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the property assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)(the Security Agent)
    Transazioni
    • 05 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 14 mar 2006
    Consegnato il 01 apr 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The tenant's interest in all the monies standing to the credit of the account including all interest accruing thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Brixton (Great Western,Southall) 1 Limited
    Transazioni
    • 01 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 31 gen 2006
    Consegnato il 09 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 home counties storage system 17D mezzanine floor, 1 home counties storage system 17C mezzanine floor, 1 ima cooling system cold room 17A, for details of further chattels charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 08 gen 2004
    Consegnato il 10 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 10 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 mar 1999
    Consegnato il 01 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 apr 1994
    Consegnato il 05 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 8 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 apr 1994
    Consegnato il 05 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 4 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 apr 1994
    Consegnato il 05 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 2 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 feb 1994
    Consegnato il 19 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 lug 1990
    Consegnato il 31 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 8 featherstone industrial estate dominion road southall middx and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 set 1989
    Consegnato il 29 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit number 2 feather stone industrial estate southall L.B. of ealing unit number of feather stone industrial estate southall L.B. of ealing and proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0