M J B PROPERTIES (REDBOURN) LIMITED

M J B PROPERTIES (REDBOURN) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàM J B PROPERTIES (REDBOURN) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02006447
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di M J B PROPERTIES (REDBOURN) LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova M J B PROPERTIES (REDBOURN) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Capital Link
    Windsor Road
    CF24 5NG Cardiff
    Wales
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di M J B PROPERTIES (REDBOURN) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TAMBURLAN LIMITED03 apr 198603 apr 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di M J B PROPERTIES (REDBOURN) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al03 apr 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per M J B PROPERTIES (REDBOURN) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 apr 2012

    Stato del capitale al 26 apr 2012

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Nomina di Mr Roy George Ellis come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Killick come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 03 apr 2010

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Atlantic House East Tyndall Street Cardiff South Glamorgan CF10 4PS in data 31 ago 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 mar 2009

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 29 mar 2008

    11 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di M J B PROPERTIES (REDBOURN) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLIS, Roy George
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    Segretario
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    British116788900001
    BURNS, Neil Anthony
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    Amministratore
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    WalesBritish62596180004
    ELLIS, Roy George
    Windsor Road
    CF24 5NG Cardiff
    Capital Link
    Wales
    Amministratore
    Windsor Road
    CF24 5NG Cardiff
    Capital Link
    Wales
    WalesBritish161784490001
    KIRK, Richard Stanley, Mr.
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    Amministratore
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    United KingdomBritish54276260003
    BARTON, Geoffrey
    3 Ledwell Road
    Caddington
    LU1 4JH Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    3 Ledwell Road
    Caddington
    LU1 4JH Luton
    Bedfordshire
    British5172760001
    CHILD, Hugh
    Village House
    Colwinston
    CF7 7NL Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Segretario
    Village House
    Colwinston
    CF7 7NL Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    British16578300001
    KILLICK, Michael David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    Segretario
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    British75927820002
    MORGAN, David John
    74 Inverness Place
    Roath
    CF2 4SA Cardiff
    Segretario
    74 Inverness Place
    Roath
    CF2 4SA Cardiff
    British35923980002
    SHEPPARD, Jonathan Lance
    Borrowdale Close
    Penylan
    CF23 5LQ Cardiff
    7
    Wales
    Segretario
    Borrowdale Close
    Penylan
    CF23 5LQ Cardiff
    7
    Wales
    Welsh98026690002
    WIGLEY, Islwyn Thomas
    21 Windsor Road
    Radyr
    CF4 8BQ Cardiff
    Segretario
    21 Windsor Road
    Radyr
    CF4 8BQ Cardiff
    British49912180001
    BARTON, Geoffrey
    3 Ledwell Road
    Caddington
    LU1 4JH Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    3 Ledwell Road
    Caddington
    LU1 4JH Luton
    Bedfordshire
    British5172760001
    BOARER, Marjorie Joyce
    Hillbury 73 Dunstable Road
    Redbourn
    AL3 7PP St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Hillbury 73 Dunstable Road
    Redbourn
    AL3 7PP St Albans
    Hertfordshire
    British16226080001
    BRYANT, Keith Ralph
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    Amministratore
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    United KingdomBritish54831150003
    BULLAS, Michael Stuart
    Lumb House Farm
    Greenside Road, Thurstonland
    HD4 6XA Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Lumb House Farm
    Greenside Road, Thurstonland
    HD4 6XA Huddersfield
    West Yorkshire
    British86392570001
    CHILD, Hugh
    Village House
    Colwinston
    CF7 7NL Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Amministratore
    Village House
    Colwinston
    CF7 7NL Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    British16578300001
    KILLICK, Michael David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    Amministratore
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    WalesBritish75927820002
    OBRIEN, Michael John
    121 Broadwood Avenue
    HA4 7XU Ruislip
    Middlesex
    Amministratore
    121 Broadwood Avenue
    HA4 7XU Ruislip
    Middlesex
    British5192900001
    PEACOCK, Robert Frank
    Allt Laes Farm
    Cnepyn Lane Peterston Super Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Amministratore
    Allt Laes Farm
    Cnepyn Lane Peterston Super Ely
    CF5 6NE Cardiff
    British13070020001
    WOODHOUSE, Anthony John
    Groesfaen Road
    Peterston-Super-Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Elm House
    Amministratore
    Groesfaen Road
    Peterston-Super-Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Elm House
    United KingdomBritish131678400001

    M J B PROPERTIES (REDBOURN) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture between the company, the chargors (as defined) and the governor and company of the bank of scotland (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined)
    Creato il 02 dic 1999
    Consegnato il 17 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for Itself and Each of Thelenders (As Defined)
    Transazioni
    • 17 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group debenture
    Creato il 03 apr 1997
    Consegnato il 08 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities now or hereafter due owing or incurred to the chargee in it's capacity as security trustee for the secured parties (as defined) and to the secured parties or any of them under any of the financing documents (as defined) and under the debenture in whatsoever manner
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 set 1989
    Consegnato il 08 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    137 high street staines surrey t/no sy 590782.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 09 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 ago 1988
    Consegnato il 07 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    13 cannon street dover kent t/nos k 66012 and k 298113.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 1988
    Consegnato il 14 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    5, castle st. High wycombe, bucks.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0