MMH NSS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMMH NSS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02008285
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MMH NSS LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi (46720) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova MMH NSS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MMH NSS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NEWTON STEEL STOCK LIMITED21 ago 198621 ago 1986
    LOCALBARTER LIMITED09 apr 198609 apr 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di MMH NSS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per MMH NSS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione delle attività

    pagine4.20

    Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagineREST-CVL

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    15 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 gen 2016

    16 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dimissioni di un liquidatore

    2 pagine4.33

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Gateley Llp One Eleven Edmund Street Birmingham B3 2HJ a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 19 feb 2015

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 05 gen 2015

    LRESEX

    Dichiarazione delle attività

    4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Cessazione della carica di Graeme Everitt Hill come amministratore in data 21 lug 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 17 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 lug 2014

    Stato del capitale al 17 lug 2014

    • Capitale: GBP 91,090
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2013

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 17 lug 2013

    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2012

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed newton steel stock LIMITED\certificate issued on 22/05/12
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    22 mag 2012

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM04 - MEANS IN ARTICLES

    CONNOT

    Cessazione della carica di David Lawson come amministratore

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Brightgate House Cobra Court 1 Brightgate Way Trafford Park Manchester M32 0TB* in data 17 mag 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 giu 2011

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MMH NSS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HORNE, David William Murray
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Segretario
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    British41593900004
    LOCKYER, Ian Paul
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish67618470001
    MCGILL, Michael Scott
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    ScotlandBritish99070570001
    NEWELL, Robert Nigel
    Holly Croft Grove Lane Close
    Stalbridge
    DT10 2RF Sturminster Newton
    Dorset
    Segretario
    Holly Croft Grove Lane Close
    Stalbridge
    DT10 2RF Sturminster Newton
    Dorset
    British4580220001
    WAIT, Jennifer Joan
    Hedgerow
    East Stour Common, East Stour
    SP8 5NB Gillingham
    Dorset
    Segretario
    Hedgerow
    East Stour Common, East Stour
    SP8 5NB Gillingham
    Dorset
    British17613870001
    FAYERS, Trevor Paul
    3 Gower Road
    SP7 8RU Shaftesbury
    Dorset
    Amministratore
    3 Gower Road
    SP7 8RU Shaftesbury
    Dorset
    United KingdomBritish67618490001
    HILL, Graeme Everitt
    c/o C/O Gateley Llp
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    England
    Amministratore
    c/o C/O Gateley Llp
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    England
    EnglandBritish144984260001
    LAWSON, David Barrie
    Penshaw House 5 Pinfold Lane
    Misterton
    DN10 4FE Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Penshaw House 5 Pinfold Lane
    Misterton
    DN10 4FE Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish122575270001
    MAYNARD, Alfred Henry Charles
    Weston House
    Stalbridge Weston
    DT10 2LA Sturminster Newton
    Dorset
    Amministratore
    Weston House
    Stalbridge Weston
    DT10 2LA Sturminster Newton
    Dorset
    United KingdomBritish141663640001
    NEWELL, Robert Nigel
    1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House Cobra Court
    Amministratore
    1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House Cobra Court
    United KingdomBritish4580220001
    VINING, Christopher Noel
    The Vicarage
    Stourton Caundle
    DT10 2JH Sturminster Newton
    Dorset
    Amministratore
    The Vicarage
    Stourton Caundle
    DT10 2JH Sturminster Newton
    Dorset
    EnglandBritish141663630001
    WAIT, Gordon
    Hedgerow
    East Stour Common East Stour
    SP8 5NB Gillingham
    Dorset
    Amministratore
    Hedgerow
    East Stour Common East Stour
    SP8 5NB Gillingham
    Dorset
    British17613890001
    WILSON, James Donald Gilmour
    1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House Cobra Court
    Amministratore
    1 Brightgate Way
    Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House Cobra Court
    ScotlandBritish69298770001

    MMH NSS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 20 apr 2010
    Consegnato il 04 mag 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H and l/h property at unit 3 city business centre, basin road, chichester t/no WSX115019 and the property formerly at henstridge airfield and to the north of landshire lane, henstridge t/no's WS30409, WS10242, ST169615, ST117114 and ST106352 and fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 20 apr 2010
    Consegnato il 28 apr 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Supplemental deed
    Creato il 04 dic 2008
    Consegnato il 18 dic 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (Formerly the Governor and Company of the Bank of Scotland)
    Transazioni
    • 18 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 15 feb 2007
    Consegnato il 23 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 25 lug 2005
    Consegnato il 28 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 28 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 lug 2005
    Consegnato il 14 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property lying to the north of landshire lane hestridge airfield henstridge somerset t/n ST106352 WS10242 ST169615 ST117114 and WS30409. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 feb 2003
    Consegnato il 11 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 11 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 dic 2001
    Consegnato il 08 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 3 city business centre basin road chichester west sussex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 feb 1998
    Consegnato il 16 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 7 thrift close stalbridge north dorset.t/no.DT196329.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 feb 1998
    Consegnato il 13 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility to provide finance for the purchase of the property mortgaged
    Brevi particolari
    F/Hold property at 7 thrift close,stalbridge,dorset. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 feb 1994
    Consegnato il 10 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a gibbs marsh trading estate landshire lane henstridge somerset t/nos. ST67891 and ST71108 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 lug 1989
    Consegnato il 14 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property known as warehouse and land at station rd, sturminster newton, dorset.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 03 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MMH NSS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 gen 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    William Kenneth Dawson
    Po Box 500 2 Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    Praticante
    Po Box 500 2 Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    John Charles Reid
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Praticante
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Christopher Mckay
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Praticante
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0