BIR REALISATIONS LIMITED

BIR REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBIR REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02013014
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BIR REALISATIONS LIMITED?

    • (5248) /

    Dove si trova BIR REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BIR REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BIRTHDAYS LIMITED28 nov 199628 nov 1996
    RON WOOD GREETING CARDS LIMITED 04 mar 199404 mar 1994
    RONWOOD GREETING CARDS LIMITED22 apr 198622 apr 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di BIR REALISATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 lug 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per BIR REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    31 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 nov 2012

    8 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 mag 2012

    10 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 nov 2011

    11 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 mag 2011

    9 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Zolfo Cooper Toronto Square Toronto Street Leeds West Yorkshire LS1 2HJ in data 26 mag 2011

    2 pagineAD01

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    18 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 nov 2009

    15 pagine2.24B

    legacy

    1 pagine287

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    44 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    14 pagine2.16B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed birthdays LIMITED\certificate issued on 01/07/09
    2 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    8 pagine395

    legacy

    11 pagine395

    Risoluzioni

    Resolutions
    13 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 29 lug 2007

    21 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di BIR REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARTOG, Barry Raymond
    54 Woodcock Hill
    Kenton
    HA3 0JF Harrow
    Middlesex
    Segretario
    54 Woodcock Hill
    Kenton
    HA3 0JF Harrow
    Middlesex
    British9892960001
    HARTOG, Barry Raymond
    54 Woodcock Hill
    Kenton
    HA3 0JF Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    54 Woodcock Hill
    Kenton
    HA3 0JF Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish9892960001
    LEWIN, Clinton Stuart
    Canes Farm Canes Lane
    Hastingwood
    CM17 9LD Harlow
    Essex
    Amministratore
    Canes Farm Canes Lane
    Hastingwood
    CM17 9LD Harlow
    Essex
    United KingdomBritish1935590001
    LEWIN, Donald John
    Broadoaks High Road
    IG7 6DW Chigwell
    Essex
    Amministratore
    Broadoaks High Road
    IG7 6DW Chigwell
    Essex
    United KingdomBritish1935600002
    KAYE, David Stanley
    3 Egidia Avenue
    Giffnock
    G46 7NH Glasgow
    Segretario
    3 Egidia Avenue
    Giffnock
    G46 7NH Glasgow
    British78278710003
    MCKENNA, John
    12 Streamside Close
    Timperley
    WA15 7PE Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    12 Streamside Close
    Timperley
    WA15 7PE Altrincham
    Cheshire
    British43759940002
    WALKER, Thomas Alexander Goldie
    4 Golf View
    ML10 6AZ Strathaven
    Lanarkshire
    Segretario
    4 Golf View
    ML10 6AZ Strathaven
    Lanarkshire
    British67798320002
    WOODHOUSE, Christopher Kevin
    Oakleigh
    62 Station Road
    BL7 0HA Chapletown
    Turton Bolton
    Segretario
    Oakleigh
    62 Station Road
    BL7 0HA Chapletown
    Turton Bolton
    British48827150001
    BEESLEY, Nicholas William
    Waverley 22 Abbey Road
    West Kirby
    L48 7EW Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Waverley 22 Abbey Road
    West Kirby
    L48 7EW Wirral
    Merseyside
    British54212890002
    BOLAND, Richard Paul
    Hillfoot Cottage
    25 Uttoxeter Road
    WS15 3QR Hill Ridware Rugeley
    Staffordshire
    Amministratore
    Hillfoot Cottage
    25 Uttoxeter Road
    WS15 3QR Hill Ridware Rugeley
    Staffordshire
    British92472430001
    CARTER, Nicholas Michael
    Laverton House
    Laverton
    WR12 7NA Broadway
    Worcs
    Amministratore
    Laverton House
    Laverton
    WR12 7NA Broadway
    Worcs
    EnglandBritish120830070001
    COOKE, Nicholas John
    35 Gingerbread Lane
    CW5 6NH Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    35 Gingerbread Lane
    CW5 6NH Nantwich
    Cheshire
    British22741440001
    DAVIS, Andrew Guy
    50 Somerset Grove
    OL11 5YS Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    50 Somerset Grove
    OL11 5YS Rochdale
    Lancashire
    United KingdomBritish79007370001
    DUXBURY, Nigel David
    7 Holkar Meadows
    Bromley Cross
    BL7 9NA Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    7 Holkar Meadows
    Bromley Cross
    BL7 9NA Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish92190030001
    FORDE, Hugh Aloysius
    217 Medlock Road
    Woodhouses Failsworth
    M35 9NQ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    217 Medlock Road
    Woodhouses Failsworth
    M35 9NQ Manchester
    Lancashire
    EnglandBritish95092810001
    JACKSON, Carl William
    Riverside Cottage Main Street
    Burnsall
    BD23 6BN Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    Riverside Cottage Main Street
    Burnsall
    BD23 6BN Skipton
    North Yorkshire
    British67237250002
    LOVERING, John David
    New House Farm
    Bodiam
    TN32 5UP Robertsbridge
    East Sussex
    Amministratore
    New House Farm
    Bodiam
    TN32 5UP Robertsbridge
    East Sussex
    United KingdomBritish73573160002
    MASON, Stephen Antony
    303 Haslingden Road
    BB4 6RX Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    303 Haslingden Road
    BB4 6RX Rossendale
    Lancashire
    British70769560001
    MCAULEY, Charles
    Witchingham Apartment 8
    Adlington Road
    SK9 2AL Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Witchingham Apartment 8
    Adlington Road
    SK9 2AL Wilmslow
    Cheshire
    British53076620002
    MCCLUSKEY, Brian
    5 Ayr Road
    KA9 1SX Prestwick
    Ayrshire
    Amministratore
    5 Ayr Road
    KA9 1SX Prestwick
    Ayrshire
    United KingdomBritish96335270001
    MCKAY, Robert
    25 Mimosa Close
    Euxton
    PR7 1BT Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    25 Mimosa Close
    Euxton
    PR7 1BT Chorley
    Lancashire
    British99969890001
    MCKENNA, John
    12 Streamside Close
    Timperley
    WA15 7PE Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    12 Streamside Close
    Timperley
    WA15 7PE Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish43759940002
    NASH, Jeffrey Nigel
    Lane Rigg 148 Thornhill Road
    B74 2EH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Lane Rigg 148 Thornhill Road
    B74 2EH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British11989260001
    PREECE, Ian
    Stiggits Barn Annfield Mains
    KY15 7TW Kettlehill
    Fife
    Amministratore
    Stiggits Barn Annfield Mains
    KY15 7TW Kettlehill
    Fife
    ScotlandBritish58430560001
    RICHARDS, Jeffrey
    42 Rookery Rise
    Swallowfield Estate
    CW7 3EA Winsford
    Cheshire
    Amministratore
    42 Rookery Rise
    Swallowfield Estate
    CW7 3EA Winsford
    Cheshire
    British54212990001
    RISK, Keith James
    10 Lyndale Park
    Orton Wistow
    PE2 6FE Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    10 Lyndale Park
    Orton Wistow
    PE2 6FE Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish74726270001
    ROBSON, Bryan
    Clovelly 108 Bankhall Lane
    Hale
    WA15 0PD Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Clovelly 108 Bankhall Lane
    Hale
    WA15 0PD Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish7889130001
    ROME, Ronald
    Holly Cottage
    Tarnsphurst Lane
    CHESHIRE Hazel Grove
    Stockport
    Amministratore
    Holly Cottage
    Tarnsphurst Lane
    CHESHIRE Hazel Grove
    Stockport
    British75311740001
    SHARPLES, Michael
    6 Whitebirk Close
    Greenmount
    BL8 4HE Bury
    Lancashire
    Amministratore
    6 Whitebirk Close
    Greenmount
    BL8 4HE Bury
    Lancashire
    United KingdomBritish4474120001
    SHEPHERD, Edward
    3 Ramwells Court
    Windy Harbour Lane, Bromley Cross
    BL7 9PH Bolton
    Amministratore
    3 Ramwells Court
    Windy Harbour Lane, Bromley Cross
    BL7 9PH Bolton
    United KingdomBritish69015160002
    SHERMAN, Stephen Andrew
    Victorian Lanterns
    16 Miller Street
    BL9 5PX Bury
    Lancashire
    Amministratore
    Victorian Lanterns
    16 Miller Street
    BL9 5PX Bury
    Lancashire
    British69801240001
    SMITH, Michael Joseph
    9 Browgate
    Sawley
    BB7 4LE Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    9 Browgate
    Sawley
    BB7 4LE Clitheroe
    Lancashire
    British29439000002
    TAPP, Christopher
    17 High Street
    Easton On The Hill
    PE9 3LN Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    17 High Street
    Easton On The Hill
    PE9 3LN Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritish65723190003
    WALTERS, Nicholas John
    8 Garrick Avenue
    Newton Mearns Mearnskirk
    G77 5GF Glasgow
    Amministratore
    8 Garrick Avenue
    Newton Mearns Mearnskirk
    G77 5GF Glasgow
    British38462890002
    WOOD, Gail Elizabeth
    Woodlands 23 Station Road
    BL8 4BJ Bury
    Lancashire
    Amministratore
    Woodlands 23 Station Road
    BL8 4BJ Bury
    Lancashire
    EnglandBritish50668920001

    BIR REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 mar 2009
    Consegnato il 06 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each debtor to the charge or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charges, assignments and floating charge see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 06 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    A share charge
    Creato il 23 mar 2009
    Consegnato il 06 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each debtor to the charge or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charges assignments and floating charge see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 06 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 29 ago 2003
    Consegnato il 17 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • A
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Eachother Finance Party
    Transazioni
    • 17 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 29 ago 2003
    Consegnato il 18 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge the chargors shares in birthdays (ireland) limited together with any substituted securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Eachfinance Party
    Transazioni
    • 18 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 15 nov 1999
    Consegnato il 26 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale (As Security Agent for the Security Beneficiaries)
    Transazioni
    • 26 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 21 ott 1996
    Consegnato il 30 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at barlow fold lying to the west of manchester rd,bury; t/nos: la 340783 and gm 471200; land to the north of bridge hall lane,bury; gm 504900 and land on north west side of dummers lane,bury; gm 548027,gm 685848 and gm 694191. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 30 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ago 1993
    Consegnato il 09 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-land on the north west side of dumers lane bury greater manchester. T/n-GM548027. And/or the proceeds of sale thereof and assigns the good will ofthe business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assurance
    Creato il 25 ago 1993
    Consegnato il 27 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the covenants contained in the assurance dated 25 august 1993
    Brevi particolari
    L/H-106 high stree margate.
    Persone aventi diritto
    • Dixon Stores Group Limited and Currys Group PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assurance
    Creato il 25 ago 1993
    Consegnato il 27 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the covenants contained in the assurance dated 25 august 1993
    Brevi particolari
    L/H-39 high street ramsgate.
    Persone aventi diritto
    • Dixons Stores Group Limited and Currys Group PLC
    Transazioni
    • 27 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 apr 1992
    Consegnato il 27 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that plot of land situate to the north of bridge hall lane, bury title no gm 504900 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 mar 1988
    Consegnato il 18 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H whitehouse service station manchester road bury grt manchester and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 ago 1986
    Consegnato il 11 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at barlow fold lying to the west of manchester road bury greater manchester title no la 340783 and/or the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 giu 1986
    Consegnato il 04 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all f/hold & l/hold properties &/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charges over undertaking and all property andassets present and future including goodwill, bookdebts & the benefit of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 12 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BIR REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 mag 2010Fine dell'amministrazione
    20 mag 2009Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Kroll
    3rd Floor
    LS1 4DL Wellington Plaza
    31 Wellington Street Leeds
    Praticante
    Kroll
    3rd Floor
    LS1 4DL Wellington Plaza
    31 Wellington Street Leeds
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DataTipo
    26 ott 2013Data di scioglimento
    11 mag 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praticante
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0