INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED

INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02013410
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED?

    • (7210) /
    • (7250) /
    • (7260) /

    Dove si trova INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Allen House 1 Westmead Road
    Sutton
    SM1 4LA Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INTERCHANGE GROUP LIMITED16 nov 199316 nov 1993
    INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED08 feb 199108 feb 1991
    CIL ENGINEERING LIMITED14 gen 198714 gen 1987
    COMPUTER INVESTMENTS (ENGINEERING) LIMITED27 giu 198627 giu 1986
    EXTRACOMP MARKETING LIMITED23 apr 198623 apr 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine4.72

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 16 mag 2011

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da 4th Floor, Neville House Waterloo Street Birmingham West Midlands B2 5UF England in data 20 mag 2011

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Grahame Griffiths come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 feb 2011

    Stato del capitale al 07 feb 2011

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter David Hoole il 13 dic 2010

    2 pagineCH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2010 al 30 set 2010

    1 pagineAA01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed interchange group LIMITED\certificate issued on 03/11/10
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name03 nov 2010

    Avviso di cambio di nome"

    CONNOT

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 01 ott 2010

    RES15

    Bilancio modificato per una piccola impresa redatto al 31 mar 2009

    10 pagineAAMD

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per David Burrows il 01 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Peter Michael Neville il 01 gen 2010

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Coley & Tilley Neville House Waterloo Street Birmingham West Midlands B2 5UF in data 03 dic 2009

    1 pagineAD01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2008

    10 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Coley & Tilley Neville House Waterloo Street Birmingham West Midlands B2 5UF England in data 25 nov 2009

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Interchange Park Newport Pagnell Buckinghamshire MK16 9PS in data 24 nov 2009

    1 pagineAD01

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    21 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURROWS, David, Mr.
    37 Broom Lane
    S60 3EL Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    37 Broom Lane
    S60 3EL Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishR & D Director119849000001
    FAIRBURN, Barry
    18 Glossop Way
    SG15 6YG Arlesey
    Bedfordshire
    Amministratore
    18 Glossop Way
    SG15 6YG Arlesey
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director23452410002
    HODGSON, Kenneth William
    14 Augusta Avenue
    Collingtree Park
    NN4 0XP Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    14 Augusta Avenue
    Collingtree Park
    NN4 0XP Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishCo Director91739820001
    HOOLE, Peter David
    Greenways
    Bow Brickhill
    MK17 9JP Milton Keynes
    28
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Greenways
    Bow Brickhill
    MK17 9JP Milton Keynes
    28
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishCo Director13747930002
    JONES, Phillip James
    Silverdale
    Old Charlton Road
    SG5 2AJ Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    Silverdale
    Old Charlton Road
    SG5 2AJ Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director36091520004
    NEVILLE, Peter Michael
    22 Nottingham Road
    NG12 5FD Keyworth
    Nottinghamshire
    Amministratore
    22 Nottingham Road
    NG12 5FD Keyworth
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector119849190001
    FRANKLIN, Ian Wynne
    11 Grassington
    Bancroft
    MK13 0QJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    11 Grassington
    Bancroft
    MK13 0QJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British4550230001
    GRIFFITHS, Grahame Nigel
    19 Cartland Road
    Kings Heath
    B14 7NS Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    19 Cartland Road
    Kings Heath
    B14 7NS Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor69984600001
    O'DONNELL, John Gerard
    39 Milton Drive
    MK16 9AS Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Segretario
    39 Milton Drive
    MK16 9AS Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    IrishAccountant37900960001
    ELLIS, Brian James
    The Old Barn Walsh Lane
    Meriden
    CV7 7JY Coventry
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old Barn Walsh Lane
    Meriden
    CV7 7JY Coventry
    Warwickshire
    BritishCo Director4923400002
    FRANKLIN, Ian Wynne
    11 Grassington
    Bancroft
    MK13 0QJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    11 Grassington
    Bancroft
    MK13 0QJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCo Director4550230001
    HOPEWELL, Rosalind Anne
    24 Holland Road
    Ampthill
    MK45 2RS Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    24 Holland Road
    Ampthill
    MK45 2RS Bedford
    Bedfordshire
    BritishDirector23452430002
    LOVETT, Paul John
    Braeside Lovelace Avenue
    B91 3JR Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Braeside Lovelace Avenue
    B91 3JR Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director40369780001
    RAND, Michael Guy
    Widdrington Lodge
    Chiltern Hill, Chalfont St. Peter
    SL9 9TX Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Widdrington Lodge
    Chiltern Hill, Chalfont St. Peter
    SL9 9TX Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director75405790001

    INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 10 lug 2002
    Consegnato il 12 lug 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The account with the bank denominated in sterling designated ltsb re interchange group LTD and numbered 03367628 and any account(s) for the time being replacing the same. And all deposits with the bank's treasury division in the name of the bank re the company in whatever currency denominated.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment of intellectual property rights by way of security
    Creato il 22 apr 1996
    Consegnato il 08 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All copyrights,know-how and other rights,title and interest whatsoever and goodwill of business thereto; all trade/service marks in relation to the software listed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 20 feb 1992
    Consegnato il 28 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £68,596.80 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in the sums payable under the insurances (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 28 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 22 gen 1992
    Consegnato il 28 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from interchange group limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 28 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 28 mag 1991
    Consegnato il 05 giu 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 24 gen 1991
    Consegnato il 31 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on f/h & l/h properties. Fixed charge over goodwill uncalled capital. Book debts & other debts. Floating charge over stock-in-trade property, assets and undertaking.
    Persone aventi diritto
    • Granada Computer Services (UK) Limited
    Transazioni
    • 31 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 14 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 24 gen 1991
    Consegnato il 31 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from lilypush limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed charge on f/h & l/h properties. Fixed charge over goodwill, uncalled capital book debts & other debts. Floating charge over stock-in-trade, property, assets and undertaking.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 31 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 mag 2011Inizio della liquidazione
    23 nov 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Martin Charles Armstrong
    Turpin Barker Armstrong
    Allen House
    SM1 4LA One Westmead Road
    Sutton Surrey
    Praticante
    Turpin Barker Armstrong
    Allen House
    SM1 4LA One Westmead Road
    Sutton Surrey

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0