QUADRO HARSTON LIMITED

QUADRO HARSTON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàQUADRO HARSTON LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02015785
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di QUADRO HARSTON LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
    • Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova QUADRO HARSTON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di QUADRO HARSTON LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SAGENTIA TECHNOLOGY ADVISORY LIMITED20 feb 201420 feb 2014
    SAGENTIA HOLDINGS LIMITED17 mar 200817 mar 2008
    SAGENTIA GROUP LIMITED20 ott 200620 ott 2006
    THE GENERICS GROUP LIMITED17 lug 199017 lug 1990
    GENERICS HOLDINGS CORPORATION LIMITED05 dic 198605 dic 1986
    EQUALHOLD LIMITED30 apr 198630 apr 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di QUADRO HARSTON LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per QUADRO HARSTON LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al11 lug 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma25 lug 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al11 lug 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per QUADRO HARSTON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Sarah Elizabeth Cole il 09 dic 2024

    2 pagineCH01

    Memorandum e Statuto

    4 pagineMA

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2023

    30 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    30 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    30 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 020157850008, creata il 23 dic 2021

    109 pagineMR01

    Cessazione della carica di Sameet Vohra come amministratore in data 30 lug 2021

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 020157850007, creata il 11 ago 2021

    29 pagineMR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    20 pagineAA

    Nomina di Mr Jonathan Brett come amministratore in data 23 lug 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Sarah Elizabeth Cole il 21 mag 2021

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name23 giu 2021

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 23 giu 2021

    RES15

    Cessazione della carica di Rebecca Anne Archer come amministratore in data 09 apr 2021

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 09 mar 2021

    • Capitale: GBP 0.25
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem reserve 17/02/2021
    RES13

    Chi sono gli amministratori di QUADRO HARSTON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLE, Sarah Elizabeth
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    Segretario
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    185002290001
    BRETT, Jonathan
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    Amministratore
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    EnglandBritishAccountant204193690001
    COLE, Sarah Elizabeth
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    Amministratore
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    EnglandBritishSolicitor158070400004
    EDWARDS, Daniel Robert Morgan
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    Amministratore
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector173639950002
    BARRETT HAGUE, Helen Patricia
    Westward Farm
    The Green
    PE28 5PP Winwick
    Cambridgeshire
    Segretario
    Westward Farm
    The Green
    PE28 5PP Winwick
    Cambridgeshire
    British96466480004
    ELTON, Neil
    130 Wapping High Street
    E1W 2NH London
    23 Gun Wharf
    Segretario
    130 Wapping High Street
    E1W 2NH London
    23 Gun Wharf
    153206470001
    FARMER, David
    12 Cherry Orchard
    Fulbourn
    CB1 5EH Cambridge
    Segretario
    12 Cherry Orchard
    Fulbourn
    CB1 5EH Cambridge
    British33510150002
    FROST, Martin John
    4 Evening Court
    Newmarket Road
    CB5 8EA Cambridge
    Segretario
    4 Evening Court
    Newmarket Road
    CB5 8EA Cambridge
    BritishAccountant153090450001
    MARAN, Roger
    12 Clarence Gate Gardens
    NW1 6AY London
    Segretario
    12 Clarence Gate Gardens
    NW1 6AY London
    British9888620001
    MCCARTHY, Guy Jonathan
    1 Cambridge Road
    Foxton
    CB22 6SH Cambridge
    Cambridgeshire
    Segretario
    1 Cambridge Road
    Foxton
    CB22 6SH Cambridge
    Cambridgeshire
    British128742040001
    ARCHER, Rebecca Anne
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    Amministratore
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector185002210010
    BROWN, Alistair John Cameron, Dr
    The Grange Old Pembroke Farm
    21c High Street Burwell
    CB25 0HB Cambridge
    Amministratore
    The Grange Old Pembroke Farm
    21c High Street Burwell
    CB25 0HB Cambridge
    BritishConsultant119604540002
    CLARK, Mark Thomas
    26 Worcester Avenue
    CB3 7XG Hardwick
    Cambridgeshire
    Amministratore
    26 Worcester Avenue
    CB3 7XG Hardwick
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishHead Of It88370060001
    COGGILL, Christopher John
    55 High Street
    West Wratting
    CB1 5LU Cambridge
    Amministratore
    55 High Street
    West Wratting
    CB1 5LU Cambridge
    BritishEconomist14659410001
    COLLINS, Ian Peter
    27 Madingley Road
    CB3 0EG Cambridge
    Amministratore
    27 Madingley Road
    CB3 0EG Cambridge
    United KingdomBritishEngineer41679610002
    CROSSFIELD, Michael, Dr
    Perne Drift Burton End
    West Wickham
    CB1 6SD Cambridge
    Cambridgesgire
    Amministratore
    Perne Drift Burton End
    West Wickham
    CB1 6SD Cambridge
    Cambridgesgire
    BritishPhysicist47393140001
    DANNATT, Margaret Anne, Dr
    13 Church Green
    CM1 4NZ Roxwell
    Essex
    Amministratore
    13 Church Green
    CM1 4NZ Roxwell
    Essex
    BritishHr Director84805750001
    DAVEY, Simon
    2 Windsor Way
    SG19 1JL Sandy
    Bedfordshire
    Amministratore
    2 Windsor Way
    SG19 1JL Sandy
    Bedfordshire
    BritishConsultant83333910002
    EDGE, Gordon Malcolm
    Bishops House Church Street
    Great Chesterford
    CB10 1NP Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Bishops House Church Street
    Great Chesterford
    CB10 1NP Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritishEngineer41047030002
    ELTON, Neil Anthony
    130 Wapping High Street
    E1W 2NH London
    23 Gun Wharf
    Amministratore
    130 Wapping High Street
    E1W 2NH London
    23 Gun Wharf
    EnglandBritishDirector74129080002
    FAIRCLOUGH, John Whitaker, Sir
    The Old Blue Boar 25 St Johns Street
    SO23 8HF Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    The Old Blue Boar 25 St Johns Street
    SO23 8HF Winchester
    Hampshire
    BritishMerchant Banker14451130001
    FLICOS, Daniel James
    71 Little Walden Road
    CB10 2DL Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    71 Little Walden Road
    CB10 2DL Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritishElectronic Engineer116870120001
    FROST, Martin John
    4 Evening Court
    Newmarket Road
    CB5 8EA Cambridge
    Amministratore
    4 Evening Court
    Newmarket Road
    CB5 8EA Cambridge
    EnglandBritishAccountant153090450001
    GREAVES, John Richard Adam
    Manor Farm
    68 Town Street
    CB2 5PE Newton
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Manor Farm
    68 Town Street
    CB2 5PE Newton
    Cambridgeshire
    BritishBusiness Manager81423030001
    HINE, Duncan, Dr
    Glenrue 6 Butt Lane Close
    LE10 1LF Hinckley
    Leicestershire
    Amministratore
    Glenrue 6 Butt Lane Close
    LE10 1LF Hinckley
    Leicestershire
    BritishManaging Director13396990001
    HUDSON, Brent Christopher
    The Grove
    TW11 8AT Teddington
    43
    Middlesex
    England
    Amministratore
    The Grove
    TW11 8AT Teddington
    43
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishDirector146460230001
    HYDE, Peter John, Dr
    Caters Farm
    Cowlinge
    CB8 9HP Newmarket
    Suffolk
    Amministratore
    Caters Farm
    Cowlinge
    CB8 9HP Newmarket
    Suffolk
    BritishEngineer29675940001
    HYDE, Peter John, Dr
    Caters Farm
    Cowlinge
    CB8 9HP Newmarket
    Suffolk
    Amministratore
    Caters Farm
    Cowlinge
    CB8 9HP Newmarket
    Suffolk
    BritishEngineer29675940001
    KYLBERG, Lars Vilhelm
    Ostermalmsgatan 101
    Stockholm
    Se 11549
    Sweden
    Amministratore
    Ostermalmsgatan 101
    Stockholm
    Se 11549
    Sweden
    SwedishCompany Director95021110001
    LAWSON, Peter Gerald
    Froyls
    High Street
    RH16 2MR Lindfield
    Sussex
    Amministratore
    Froyls
    High Street
    RH16 2MR Lindfield
    Sussex
    BritishCompany Director29675990001
    LEE, Robin Michael, Dr
    Paddock View
    30 Back Road
    CB1 6JF Linton
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Paddock View
    30 Back Road
    CB1 6JF Linton
    Cambridgeshire
    BritishConsultant81423140001
    LUDVIGSSON, Per Ake
    Avenue D`Hougoumont 17
    Bruxelles B1180
    Belgium
    Amministratore
    Avenue D`Hougoumont 17
    Bruxelles B1180
    Belgium
    SwedishManaging Director76594300001
    MCCARTHY, Guy Jonathan
    1 Cambridge Road
    Foxton
    CB22 6SH Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    1 Cambridge Road
    Foxton
    CB22 6SH Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritishAccountant128742040001
    MOODY, Peter Brian
    2 Alwyne Place
    N1 2NL London
    Amministratore
    2 Alwyne Place
    N1 2NL London
    BritishCompany Director46801630001
    MORLAND, Robert John
    1 Mortlock Close
    SG8 6DA Melbourn
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Mortlock Close
    SG8 6DA Melbourn
    Hertfordshire
    EnglandBritishEngineer118685420001

    Chi sono le persone con controllo significativo di QUADRO HARSTON LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Science Group Plc
    Royston Road
    Harston
    CB22 7GG Cambridge
    Harston Mill
    England
    06 apr 2016
    Royston Road
    Harston
    CB22 7GG Cambridge
    Harston Mill
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleThe Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales Companies Register
    Numero di registrazione06536543
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    QUADRO HARSTON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 23 dic 2021
    Consegnato il 23 dic 2021
    In corso
    Breve descrizione
    The properties known as land on the north west side of royston road, harston, cambridge CB22 7GG registered at hm land registry with title number CB234341 and harston mill, royston road, harston, cambridge CB22 7GG and registered at hm land registry with title number CB114439.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 11 ago 2021
    Consegnato il 12 ago 2021
    In corso
    Breve descrizione
    By legal mortgage the freehold property known as harston mill, royston road, harston, cambrodge, CB22 7GG and land on the north west side of royston road, harston (title numbers: CB114439 and CB234341).
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (Crn: 00002065)
    Transazioni
    • 12 ago 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Mortgage
    Creato il 21 giu 2006
    Consegnato il 23 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a harston mill, harston, cambridge, cambridgeshire t/no CB114439 and CB234341. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 23 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ott 2000
    Consegnato il 15 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a approx. 8 acres of land at manor farm harston south cambridgeshire t/no;-CB234341 and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2025Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 27 giu 2000
    Consegnato il 14 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a harston mill harston cambridge. T/no. CB114439. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2025Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 01 ott 1996
    Consegnato il 07 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property hereinafter described and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property and an assignment of the goodwill and connection of any business or businesses from time to time carried on in or upon the property or any part or parts thereof together with the full benefit of all licences including any registrations viz: f/h-harston mill royston road harston cambridgeshire t/n-CB114439.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 1995
    Consegnato il 09 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property known as harston mill, royston road, harston, cambridgeshire and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2025Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 13 dic 1991
    Consegnato il 02 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 02 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0