LTG GATESHEAD LIMITED

LTG GATESHEAD LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLTG GATESHEAD LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02018906
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di LTG GATESHEAD LIMITED?

    • (2852) /

    Dove si trova LTG GATESHEAD LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BEGBIES TRAYNOR CENTRAL LLP
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LTG GATESHEAD LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LTG 5 LIMITED20 mar 200320 mar 2003
    CRABTREE OF GATESHEAD LTD12 nov 198612 nov 1986
    CARLIOT LIMITED12 mag 198612 mag 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di LTG GATESHEAD LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2006
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 ott 2007
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2005

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per LTG GATESHEAD LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al21 feb 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma07 mar 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per LTG GATESHEAD LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per LTG GATESHEAD LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Throgmorton Secretaries Limited come segretario in data 30 apr 2008

    1 pagineTM02

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:form 4.40 - notice of ceasing to act as voluntary liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 mar 2010

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    12 pagine1.4

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    4 pagine1.1

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    16 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    20 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    25 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2002

    30 pagineAA

    legacy

    1 pagine244

    Chi sono gli amministratori di LTG GATESHEAD LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PALMER, Louise
    58 The Hill
    Glapwell
    S44 5LY Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    58 The Hill
    Glapwell
    S44 5LY Chesterfield
    Derbyshire
    British118087000001
    KLEIN, Albert Kenngott
    45 Albert Hall Mansions
    Kensington Gore
    SW7 2AW London
    Amministratore
    45 Albert Hall Mansions
    Kensington Gore
    SW7 2AW London
    GermanyGermanDirector69826640001
    BANGE, Udo Karl
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    Segretario
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    GermanDirector69193840001
    CHESSER, David
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    Segretario
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    British64149560002
    COOPER, Matthew
    Newlands
    Marchburn Lane
    NE44 6DN Riding Mill
    Northumberland
    Segretario
    Newlands
    Marchburn Lane
    NE44 6DN Riding Mill
    Northumberland
    British35122920001
    DAVIDSON, Alan
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Segretario
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    BritishAccountant30827780001
    HUNTER, Nicholas James
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    Segretario
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    BritishFinance Director94273950001
    THROGMORTON SECRETARIES LIMITED
    42 Portman Road
    RG30 1EA Reading
    Berkshire
    Segretario
    42 Portman Road
    RG30 1EA Reading
    Berkshire
    80839850001
    BANGE, Udo Karl
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    Amministratore
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    GermanDirector69193840001
    COOPER, Matthew
    Newlands
    Marchburn Lane
    NE44 6DN Riding Mill
    Northumberland
    Amministratore
    Newlands
    Marchburn Lane
    NE44 6DN Riding Mill
    Northumberland
    United KingdomBritishCo Secretary35122920001
    HARGRAVE, Stephen Thomas
    47 Lambs Conduit Street
    WC1N 3NG London
    Amministratore
    47 Lambs Conduit Street
    WC1N 3NG London
    EnglandBritishCompany Director60918490001
    HOLMES, John Edwin
    45 Linden Road Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    45 Linden Road Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    BritishDirector42461820001
    HUNTER, Nicholas James
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    Amministratore
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    EnglandBritishFinancial Director94273950001
    JOHNSON, Luke Oliver
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    Amministratore
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    BritishCompany Director56699270001
    MCDOWELL, Stephen
    29 Farne Avenue
    Red House Farm Gosforth
    NE3 2BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    29 Farne Avenue
    Red House Farm Gosforth
    NE3 2BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishDirector87525450001
    OURY, Richard Anthony
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant29821230002
    STEVEN, Andrew, Dr
    Barlow Lane End
    Lead Road Greenside
    NE40 4RQ Ryton On Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Barlow Lane End
    Lead Road Greenside
    NE40 4RQ Ryton On Tyne
    Tyne & Wear
    BritishManaging Director77572560001
    WATKIN, Karl Eric
    Syllheugh Longhorsley
    Morpeth
    NE65 8RF Northumberland
    Amministratore
    Syllheugh Longhorsley
    Morpeth
    NE65 8RF Northumberland
    EnglishManaging Director28095460001
    WILLIAMSON, Michael
    222 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LB London
    Amministratore
    222 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LB London
    BritishAccountant90174630001
    ZIEGENBEIN, Kristian Axel
    11 Runnymede Road
    Darras Hall
    NE20 9HE Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    11 Runnymede Road
    Darras Hall
    NE20 9HE Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    GermanDirector67297990002

    LTG GATESHEAD LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 17 mag 2002
    Consegnato il 18 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed between the company (1) crabtree holdings (us) limited (2) crabtree holdings limited (3) crabtree of gateshead limited (4) and landesbank baden-wurttenberg (the bank) (2)
    Creato il 12 lug 1999
    Consegnato il 02 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    (A) the secured parties have made available to the companies a loan facility of up to dem 19,800,000 on the terms set out in a facility agreement (the" crabtree facilities agreement") dated 11 november 1998 made between the companies as borrower (1) ltg technologies PLC as guarantor (2) and the chargee (3) for the purpose of refinancing existing loan facilities of the companies.(b) the obligations of the companies to the secured parties under or pursuant to inter alia the crabtree facilities agreement are secured by a composite guarantee and debenture dated 15 december 1998
    Brevi particolari
    Pursuant to the supplemental deed the debenture has been amended so that schedule 2 (properties),schedule 3 (fixed plant and machinery) and schedule 4 (intellectual property rights) to the debenture are deleted in their entirety and replaced by the respective schedules set out in annexure a of the supplemental deed. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Landesbank Baden-Wurttenberg (The Successor Entity Following the Merger on 1 January 1999 of Landesgirokasse Offentliche Bank Und Landessparkasse,Sudwestdeutsche Landesbank Girozentrale and Landeskreditbank Baden Wurttenberg)
    Transazioni
    • 02 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture between crabtree group PLC (1), crabtree holdings (us) limited (2), crabtree holdings limited (3), crabtree of gateshead limited (4) and landesgirokasse offentliche bank und landessparkasse (the "chargee")(5)
    Creato il 15 dic 1998
    Consegnato il 22 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the chargee under or pursuant to the "secured documents" (as defined) together and each as it may from time to time be amended varied novated supplemented or replaced
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landesgirokasse Offentliche Bank Und Landessparkasse
    Transazioni
    • 22 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 26 apr 1990
    Consegnato il 04 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 27 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 giu 1988
    Consegnato il 09 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 ott 1986
    Consegnato il 13 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property described in three underleases dated 13.9.63, 29.3.62, 11.12.70 and an underlease and supplemental deed dated 22.11.65.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 30 ott 1986
    Consegnato il 13 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1.35 million
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Vickers PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 30 ott 1986
    Consegnato il 01 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 nov 1986Registrazione di un'ipoteca

    LTG GATESHEAD LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 ago 2008Data della riunione per approvare il CVA
    08 apr 2009Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Morris
    Begbies Traynor (South) Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praticante
    Begbies Traynor (South) Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    2
    DataTipo
    16 lug 2009Inizio della liquidazione
    15 giu 2010Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Neil John Mather
    Begbies Traynor
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praticante
    Begbies Traynor
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Christopher Morris
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praticante
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0