GOLDACRE (OFFICES) LIMITED

GOLDACRE (OFFICES) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGOLDACRE (OFFICES) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02021103
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?

    • (7020) /

    Dove si trova GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BOURNE END PROPERTIES (OFFICES) LIMITED24 nov 199324 nov 1993
    DAWNAY, DAY PROPERTIES PLC11 mar 199111 mar 1991
    DRAWPLUS LIMITED20 mag 198620 mag 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al24 mar 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    9 pagine4.72

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 set 2013

    21 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 ago 2013

    21 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 feb 2013

    21 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 feb 2013

    21 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    10 pagine2.16B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 27 set 2012

    22 pagine2.24B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    28 pagine2.17B

    Risultato della riunione dei creditori

    2 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    27 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da * 3Rd Floor 5 Wigmore Street London W1U 1PB* in data 04 apr 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio redatto al 24 mar 2011

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 lug 2011

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 ago 2011

    Stato del capitale al 22 ago 2011

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Bilancio redatto al 24 mar 2010

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Trafalgar Officers Limited il 28 lug 2010

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Reit(Corporate Services) Limited il 09 dic 2009

    2 pagineCH04

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Segretario
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    Amministratore
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6745658
    135533720001
    PINCUS, Barry Martin
    35 Newberries Avenue
    WD7 7EJ Radlett
    Hertfordshire
    Segretario
    35 Newberries Avenue
    WD7 7EJ Radlett
    Hertfordshire
    British46444010001
    SHEPPARD, Martin Paul
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    Segretario
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    British127658820001
    SMITH, Ivor
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    Segretario
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    British21120940001
    WARD, Geoffrey Colin Neville
    131 Bishopsteignton
    Shoeburyness
    SS3 8BQ Southend On Sea
    Essex
    Segretario
    131 Bishopsteignton
    Shoeburyness
    SS3 8BQ Southend On Sea
    Essex
    British67300170001
    BAIN, Duncan Whiteford Taylor
    St Huberts Hill Marley Common
    GU27 3PT Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    St Huberts Hill Marley Common
    GU27 3PT Haslemere
    Surrey
    British28099480001
    HANCOCK, Christopher
    Kynnersley
    Park Road Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Amministratore
    Kynnersley
    Park Road Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    EnglandBritish87069290001
    KLIMT, Peter Richard
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    Amministratore
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    United KingdomBritish23621230001
    MCGRATH, Kevin David
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    Amministratore
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    EnglandBritish83872490002
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Amministratore
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    NOE, Leopold
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    EnglandBritish64965010001
    NOE, Philip Martin
    97 Bridge Lane
    NW11 0EE London
    Amministratore
    97 Bridge Lane
    NW11 0EE London
    United KingdomBritish156342420001
    PINCUS, Barry Martin
    35 Newberries Avenue
    WD7 7EJ Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    35 Newberries Avenue
    WD7 7EJ Radlett
    Hertfordshire
    British46444010001
    ROBERTS, David Ian
    Old Brookside House
    Winkfield Road
    SL5 7LX Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Old Brookside House
    Winkfield Road
    SL5 7LX Ascot
    Berkshire
    British38276960001
    SHEPPARD, Martin Paul
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    Amministratore
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    United KingdomBritish127658820001
    SMITH, Ivor
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    Amministratore
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    British21120940001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    GOLDACRE (OFFICES) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fifteenth supplemental trust deed
    Creato il 02 set 2005
    Consegnato il 05 set 2005
    In corso
    Importo garantito
    The principal of and interest of the £75,000,000 10 3/4 per cent.first mortgage debenture stock 2025 of ashpol PLC and all other monies intended to be secured by the deed and the ptincipal trust deed dated 6 december 1985 and deeds supplemental thereto of various dates
    Brevi particolari
    F/H land k/a land and buildings on the north west side of london road harlow essex t/no ex 532570. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Law Debenture Trustees Limited
    Transazioni
    • 05 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed
    Creato il 24 giu 1998
    Consegnato il 14 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender supplemental to the legal charge dated 17TH september 1996
    Brevi particolari
    193-209 (odd) fleet road fleet hampshire t/no.HP315793 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 14 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed
    Creato il 10 ott 1997
    Consegnato il 25 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group member (as defined) to the chargee; as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 17TH september 1996
    Brevi particolari
    F/H property k/a being land on seamer road scarborough north yorkshire together with all buildings erections and fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 25 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Form of supplemental deed
    Creato il 03 ott 1996
    Consegnato il 15 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group member to the chargee supplemental to the deed of legal charge dated 17TH september 1996 and a standard security dated 17TH september 1996
    Brevi particolari
    The properties listed below together with all buildings erections fixtures fixed plant and machinery. Gosforth valley shopping centre portland road dronfield t/no. DY242772. 448,450,452 & 454 high road tottenham haringey MX90275 and MX267467. 242/262 fleet road (even) fleet hampshire t/no. HP463772. 91 cranby street leicester t/no. LT44946. 16 chatham street leicester t/no. LT29268. Land and buildings on the south east side of chatham street and the north west side of york street leicester t/no. LT38753.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 15 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of legal charge
    Creato il 17 set 1996
    Acquisito il 27 nov 1997
    Consegnato il 17 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £66,943,075 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Freehold properties:- (I) 42-46 upper parliament st,nottingham;t/no nt 134743; (ii) staveton house,east hampstead rd,wokingham; t/nos: sk 159854 and bk 222469; (iii) anchor mills,stockton st,hartlepool; t/no bm 202556; (iv) haybarn house,116-118 south st,dorking; t/no sy 419077; (v) alpha numeric house,72 furlong rd,bourne end; t/no bm 172657 and the l/hold property known as sword house,high wycombr; t/no bm 202556.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 17 dic 1997Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of legal charge
    Creato il 17 set 1996
    Consegnato il 01 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from bourne end properties PLC and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of bourne end properties PLC to the chargee on any account whatsoever and in any manner whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south side of drayton road shirley k/a drayton house drayton road shirley solihull west midlands t/n WK152502 and land and buildings k/a 148/152 west end lane and land to the rear of I52 west end lane hampstead t/n's LN238327,NGL167269,NGL167270,NGL158341,NGL458342,NGL328222 and NGL23135 and various other properties (see form 395) and by way of floating charge all the company's assets rights and revenues including uncalled share capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 01 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creato il 09 dic 1994
    Consegnato il 20 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £11,523,100 and all other monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the "principal deeds" (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    Various properties as specified on form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Fire Insurance Society Limited
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transazioni
    • 20 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of collateral charge
    Creato il 25 mar 1994
    Consegnato il 08 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from goldacre investments limited to the chargee under the terms of the principal deeds (as defined) and this collateral charge
    Brevi particolari
    Various l/hold and f/hold properties listed on form 395.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 08 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 21 dic 1993
    Consegnato il 08 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as dawnay day properties LTD.) and/or euroview investments limited under the terms of the principal deeds (as defined in the deed)
    Brevi particolari
    Various properties as specified. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 08 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 giu 1991
    Consegnato il 04 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £12,500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge
    Brevi particolari
    L/Hold land at tollhouse hill, nottingham with buildings thereon known as city gate, tollhouse hill nottingham t/no nt 82283.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 04 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 giu 1991
    Consegnato il 27 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee
    Brevi particolari
    Legal mortgage over f/hold chaucer house, isambard brunel road, portsmouth t/no. Hp 231553 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 giu 1991
    Consegnato il 27 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,150,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee
    Brevi particolari
    F/Hold - chaucer house isambard brunel road portsmouth t/no hp 231553.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 27 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 dic 1990
    Consegnato il 17 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £4,300,000 and all other monies due or to become due from athe company to the chargee. Under the terms of this charge
    Brevi particolari
    F/H land abutting cumberland place, southampton together with buildings k/a grosvenor house, 18-20 cumberland place, southampton.
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transazioni
    • 17 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 dic 1990
    Consegnato il 09 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £6,250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H land to the south east of rhodaus town, canterbury k/a clarkson house and land adjoining and land to the rear of 22 old dover road rhodaus town canterbury title nos K78007, k 593099, K359160, K71352 & k 596197.
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transazioni
    • 09 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 set 1990
    Consegnato il 18 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the chargee.
    Brevi particolari
    F/Hold land abutting camden high street including 97 and 99 camden high street L.B. of camden t/no ngl 356660.
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transazioni
    • 18 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 giu 1990
    Consegnato il 21 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ige Capital Corporation (Funding) Limited
    Transazioni
    • 21 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further charge
    Creato il 01 giu 1990
    Consegnato il 12 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,750,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the existing security (as defined) and this charge.
    Brevi particolari
    Properties as follows:- first freehold property known as drayton house drayton road shirley solihull-registered under title no sgl 218598. secondly leasehold premises known as 150 and 152 west end lane and land at rear of 152 west end lane hampstead london borough of camden registered under title no ngl 23135. thirdly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in a lease date 15 1 1964 - registered under title no ln 238327. fourthly premises at the rear of 146 and 146A west end lane hampstead aforesaid. As comprised in a lease dated 3 10 1975 registered under title no ngl 458342 fifthly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in a lease dated 1 11 1977 registered under title no ngl 458341. sixthly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in a lease dated 18 6 1986 and made between the british railways board (1) malacarp terrazzo co LTD acting by the direction of j m iredale and s p l mahon (2) seventhly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in an underlease dated 29 3 71 registered under title no ngl 167270 eighthly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in an underlease dated 29 3 71 - registered under title no ngl 167269.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Fire Insurance Society Limited
    Transazioni
    • 12 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 mag 1990
    Consegnato il 18 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    97/99 camden high street camden, L.B. of camden t/no ngl 356660.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 23 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 lug 1989
    Consegnato il 18 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from stencroft properties limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    The workshop, 3 blackburn road, hampstead, l/b of camden including all buildings, fixtures (including trade) fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Royal Trust Bank
    Transazioni
    • 18 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 mar 1989
    Consegnato il 05 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    104 west end lane hampstead. (Fixed charge only).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral charge
    Creato il 29 set 1988
    Consegnato il 03 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,380,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of a legal charge dated 23/10/86 and this charge
    Brevi particolari
    Four head leases in respect of land & buildings lying to the east of west end lane hampstead title no: ngl 458342 ngl 458341, ln 238327 and two under leases title nos ngl 167269 and ngl 167270 (for details see form 395 and continuation sheet).
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Fire Insurance Society Limited
    Transazioni
    • 03 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 ott 1986
    Consegnato il 27 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,380,000
    Brevi particolari
    The properties specified on the form M395 title nos: sgl 218598 wk 152502; ngl 23135.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Fire Insurance Society Limited
    Transazioni
    • 27 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 ott 1986
    Consegnato il 25 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The properties specified on form M395 together with all fixed machinery buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878, together with all book and other debts in connection with the business.
    Persone aventi diritto
    • Mount Credit Corporation LTD
    Transazioni
    • 25 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 28 mar 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GOLDACRE (OFFICES) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 mar 2012Inizio dell'amministrazione
    10 set 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praticante
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praticante
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    2
    DataTipo
    10 set 2013Inizio della liquidazione
    23 set 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praticante
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praticante
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0