GOLDACRE (OFFICES) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GOLDACRE (OFFICES) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02021103 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?
- (7020) /
Dove si trova GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 32 Cornhill EC3V 3BT London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BOURNE END PROPERTIES (OFFICES) LIMITED | 24 nov 1993 | 24 nov 1993 |
| DAWNAY, DAY PROPERTIES PLC | 11 mar 1991 | 11 mar 1991 |
| DRAWPLUS LIMITED | 20 mag 1986 | 20 mag 1986 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 24 mar 2011 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 9 pagine | 4.72 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 set 2013 | 21 pagine | 2.24B | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 ago 2013 | 21 pagine | 2.24B | ||||||||||
Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori | 1 pagine | 2.34B | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 feb 2013 | 21 pagine | 2.24B | ||||||||||
Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione | 1 pagine | 2.31B | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 feb 2013 | 21 pagine | 2.24B | ||||||||||
Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B | 10 pagine | 2.16B | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 27 set 2012 | 22 pagine | 2.24B | ||||||||||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 28 pagine | 2.17B | ||||||||||
Risultato della riunione dei creditori | 2 pagine | 2.23B | ||||||||||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 27 pagine | 2.17B | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 3Rd Floor 5 Wigmore Street London W1U 1PB* in data 04 apr 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un amministratore | 1 pagine | 2.12B | ||||||||||
Bilancio redatto al 24 mar 2011 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 lug 2011 | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 24 mar 2010 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 lug 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Trafalgar Officers Limited il 28 lug 2010 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Reit(Corporate Services) Limited il 09 dic 2009 | 2 pagine | CH04 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GOLDACRE (OFFICES) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Segretario | 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
| 79571870006 | ||||||||||
| BENADY, Maurice Moses | Amministratore | 57/63 Line Wall Road Gibraltar Gibraltar | Gibraltar | British | 69435160001 | |||||||||
| WHITE, Christopher George | Amministratore | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | 80132540006 | |||||||||
| TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Amministratore | 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor |
| 135533720001 | ||||||||||
| PINCUS, Barry Martin | Segretario | 35 Newberries Avenue WD7 7EJ Radlett Hertfordshire | British | 46444010001 | ||||||||||
| SHEPPARD, Martin Paul | Segretario | 53 Etchingham Park Road N3 2EB London | British | 127658820001 | ||||||||||
| SMITH, Ivor | Segretario | 1 Bridge Lane NW11 0EA London | British | 21120940001 | ||||||||||
| WARD, Geoffrey Colin Neville | Segretario | 131 Bishopsteignton Shoeburyness SS3 8BQ Southend On Sea Essex | British | 67300170001 | ||||||||||
| BAIN, Duncan Whiteford Taylor | Amministratore | St Huberts Hill Marley Common GU27 3PT Haslemere Surrey | British | 28099480001 | ||||||||||
| HANCOCK, Christopher | Amministratore | Kynnersley Park Road Stoke Poges SL2 4PG Slough | England | British | 87069290001 | |||||||||
| KLIMT, Peter Richard | Amministratore | Redington Road NW3 7RS London 54 | United Kingdom | British | 23621230001 | |||||||||
| MCGRATH, Kevin David | Amministratore | 19 Elm Avenue W5 3XA London | England | British | 83872490002 | |||||||||
| NAGGAR, Guy Anthony | Amministratore | Avenue Road NW8 6HR London 61 | United Kingdom | Italian | 1496660001 | |||||||||
| NOE, Leopold | Amministratore | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | England | British | 64965010001 | |||||||||
| NOE, Philip Martin | Amministratore | 97 Bridge Lane NW11 0EE London | United Kingdom | British | 156342420001 | |||||||||
| PINCUS, Barry Martin | Amministratore | 35 Newberries Avenue WD7 7EJ Radlett Hertfordshire | British | 46444010001 | ||||||||||
| ROBERTS, David Ian | Amministratore | Old Brookside House Winkfield Road SL5 7LX Ascot Berkshire | British | 38276960001 | ||||||||||
| SHEPPARD, Martin Paul | Amministratore | 53 Etchingham Park Road N3 2EB London | United Kingdom | British | 127658820001 | |||||||||
| SMITH, Ivor | Amministratore | 1 Bridge Lane NW11 0EA London | British | 21120940001 | ||||||||||
| REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Amministratore | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
GOLDACRE (OFFICES) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Fifteenth supplemental trust deed | Creato il 02 set 2005 Consegnato il 05 set 2005 | In corso | Importo garantito The principal of and interest of the £75,000,000 10 3/4 per cent.first mortgage debenture stock 2025 of ashpol PLC and all other monies intended to be secured by the deed and the ptincipal trust deed dated 6 december 1985 and deeds supplemental thereto of various dates | |
Brevi particolari F/H land k/a land and buildings on the north west side of london road harlow essex t/no ex 532570. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed | Creato il 24 giu 1998 Consegnato il 14 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due by any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender supplemental to the legal charge dated 17TH september 1996 | |
Brevi particolari 193-209 (odd) fleet road fleet hampshire t/no.HP315793 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed | Creato il 10 ott 1997 Consegnato il 25 ott 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group member (as defined) to the chargee; as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 17TH september 1996 | |
Brevi particolari F/H property k/a being land on seamer road scarborough north yorkshire together with all buildings erections and fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Form of supplemental deed | Creato il 03 ott 1996 Consegnato il 15 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group member to the chargee supplemental to the deed of legal charge dated 17TH september 1996 and a standard security dated 17TH september 1996 | |
Brevi particolari The properties listed below together with all buildings erections fixtures fixed plant and machinery. Gosforth valley shopping centre portland road dronfield t/no. DY242772. 448,450,452 & 454 high road tottenham haringey MX90275 and MX267467. 242/262 fleet road (even) fleet hampshire t/no. HP463772. 91 cranby street leicester t/no. LT44946. 16 chatham street leicester t/no. LT29268. Land and buildings on the south east side of chatham street and the north west side of york street leicester t/no. LT38753. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of legal charge | Creato il 17 set 1996 Acquisito il 27 nov 1997 Consegnato il 17 dic 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £66,943,075 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Freehold properties:- (I) 42-46 upper parliament st,nottingham;t/no nt 134743; (ii) staveton house,east hampstead rd,wokingham; t/nos: sk 159854 and bk 222469; (iii) anchor mills,stockton st,hartlepool; t/no bm 202556; (iv) haybarn house,116-118 south st,dorking; t/no sy 419077; (v) alpha numeric house,72 furlong rd,bourne end; t/no bm 172657 and the l/hold property known as sword house,high wycombr; t/no bm 202556. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of legal charge | Creato il 17 set 1996 Consegnato il 01 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from bourne end properties PLC and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of bourne end properties PLC to the chargee on any account whatsoever and in any manner whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the south side of drayton road shirley k/a drayton house drayton road shirley solihull west midlands t/n WK152502 and land and buildings k/a 148/152 west end lane and land to the rear of I52 west end lane hampstead t/n's LN238327,NGL167269,NGL167270,NGL158341,NGL458342,NGL328222 and NGL23135 and various other properties (see form 395) and by way of floating charge all the company's assets rights and revenues including uncalled share capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of legal charge | Creato il 09 dic 1994 Consegnato il 20 dic 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £11,523,100 and all other monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the "principal deeds" (as defined in the charge) | |
Brevi particolari Various properties as specified on form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of collateral charge | Creato il 25 mar 1994 Consegnato il 08 apr 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from goldacre investments limited to the chargee under the terms of the principal deeds (as defined) and this collateral charge | |
Brevi particolari Various l/hold and f/hold properties listed on form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed | Creato il 21 dic 1993 Consegnato il 08 gen 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company (formerly known as dawnay day properties LTD.) and/or euroview investments limited under the terms of the principal deeds (as defined in the deed) | |
Brevi particolari Various properties as specified. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 28 giu 1991 Consegnato il 04 lug 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £12,500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge | |
Brevi particolari L/Hold land at tollhouse hill, nottingham with buildings thereon known as city gate, tollhouse hill nottingham t/no nt 82283. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 25 giu 1991 Consegnato il 27 giu 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee | |
Brevi particolari Legal mortgage over f/hold chaucer house, isambard brunel road, portsmouth t/no. Hp 231553 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 25 giu 1991 Consegnato il 27 giu 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £5,150,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee | |
Brevi particolari F/Hold - chaucer house isambard brunel road portsmouth t/no hp 231553. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 28 dic 1990 Consegnato il 17 gen 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £4,300,000 and all other monies due or to become due from athe company to the chargee. Under the terms of this charge | |
Brevi particolari F/H land abutting cumberland place, southampton together with buildings k/a grosvenor house, 18-20 cumberland place, southampton. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 21 dic 1990 Consegnato il 09 gen 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £6,250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge | |
Brevi particolari F/H land to the south east of rhodaus town, canterbury k/a clarkson house and land adjoining and land to the rear of 22 old dover road rhodaus town canterbury title nos K78007, k 593099, K359160, K71352 & k 596197. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 set 1990 Consegnato il 18 set 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the chargee. | |
Brevi particolari F/Hold land abutting camden high street including 97 and 99 camden high street L.B. of camden t/no ngl 356660. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 20 giu 1990 Consegnato il 21 giu 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Further charge | Creato il 01 giu 1990 Consegnato il 12 giu 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,750,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the existing security (as defined) and this charge. | |
Brevi particolari Properties as follows:- first freehold property known as drayton house drayton road shirley solihull-registered under title no sgl 218598. secondly leasehold premises known as 150 and 152 west end lane and land at rear of 152 west end lane hampstead london borough of camden registered under title no ngl 23135. thirdly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in a lease date 15 1 1964 - registered under title no ln 238327. fourthly premises at the rear of 146 and 146A west end lane hampstead aforesaid. As comprised in a lease dated 3 10 1975 registered under title no ngl 458342 fifthly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in a lease dated 1 11 1977 registered under title no ngl 458341. sixthly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in a lease dated 18 6 1986 and made between the british railways board (1) malacarp terrazzo co LTD acting by the direction of j m iredale and s p l mahon (2) seventhly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in an underlease dated 29 3 71 registered under title no ngl 167270 eighthly premises lying to the east of west end lane hampstead aforesaid as comprised in an underlease dated 29 3 71 - registered under title no ngl 167269. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 11 mag 1990 Consegnato il 18 mag 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 97/99 camden high street camden, L.B. of camden t/no ngl 356660. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 14 lug 1989 Consegnato il 18 lug 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from stencroft properties limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari The workshop, 3 blackburn road, hampstead, l/b of camden including all buildings, fixtures (including trade) fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 28 mar 1989 Consegnato il 05 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 104 west end lane hampstead. (Fixed charge only). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral charge | Creato il 29 set 1988 Consegnato il 03 ott 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,380,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of a legal charge dated 23/10/86 and this charge | |
Brevi particolari Four head leases in respect of land & buildings lying to the east of west end lane hampstead title no: ngl 458342 ngl 458341, ln 238327 and two under leases title nos ngl 167269 and ngl 167270 (for details see form 395 and continuation sheet). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 ott 1986 Consegnato il 27 ott 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,380,000 | |
Brevi particolari The properties specified on the form M395 title nos: sgl 218598 wk 152502; ngl 23135. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 ott 1986 Consegnato il 25 ott 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The properties specified on form M395 together with all fixed machinery buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878, together with all book and other debts in connection with the business. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
GOLDACRE (OFFICES) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In amministrazione |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0