PARK HALL LEISURE (DERBYSHIRE) LIMITED

PARK HALL LEISURE (DERBYSHIRE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPARK HALL LEISURE (DERBYSHIRE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02021934
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PARK HALL LEISURE (DERBYSHIRE) LIMITED?

    • (9272) /

    Dove si trova PARK HALL LEISURE (DERBYSHIRE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lynton House
    Ackhurst Park,Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley,Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PARK HALL LEISURE (DERBYSHIRE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MATAHARI 113 LIMITED21 mag 198621 mag 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di PARK HALL LEISURE (DERBYSHIRE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per PARK HALL LEISURE (DERBYSHIRE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 feb 2011

    Stato del capitale al 23 feb 2011

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per John Clement Kay il 17 feb 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per John Clement Kay il 17 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr St John Stott il 17 feb 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    10 pagineAA

    legacy

    3 pagine403a

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    10 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    11 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    11 pagineAA

    legacy

    6 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    10 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di PARK HALL LEISURE (DERBYSHIRE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KAY, John Clement
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    Segretario
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    British27891540001
    KAY, John Clement
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish27891540001
    STOTT, St John
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish83024660001
    LLOYD, Roger William
    1 Glen Park Close
    Chellaston
    DE73 5NT Derby
    Derbyshire
    Segretario
    1 Glen Park Close
    Chellaston
    DE73 5NT Derby
    Derbyshire
    British123160110001
    LORD, Vernon James
    Malmesbury House
    New Pale Road
    WA14 3HG Manley
    Cheshire
    Segretario
    Malmesbury House
    New Pale Road
    WA14 3HG Manley
    Cheshire
    British64957780001
    LUCK, Stuart Richard
    2 Ollerton Close
    Northenden
    M22 4HG Manchester
    Segretario
    2 Ollerton Close
    Northenden
    M22 4HG Manchester
    British63728750002
    PARROTT, Graham Joseph
    30 Kings Road
    EN5 4EE Barnet
    Hertfordshire
    Segretario
    30 Kings Road
    EN5 4EE Barnet
    Hertfordshire
    British6741720001
    PENROSE, Ian Richard
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    Segretario
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    British32311080001
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    Segretario
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    British83024660001
    ALLEN, Charles Lamb
    132 Westbourne Grove
    W11 2RR London
    Amministratore
    132 Westbourne Grove
    W11 2RR London
    British63372790001
    BROOME, John Lawson
    Rednal Manor
    Rednal, West Felton
    SY11 4HT Oswestry
    Shropshire
    Amministratore
    Rednal Manor
    Rednal, West Felton
    SY11 4HT Oswestry
    Shropshire
    British67181090001
    HEMMINGS, Craig John
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish180952730001
    HEMMINGS, Craig John
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish180952730001
    LUCK, Stuart Richard
    19 Lime Close
    Bromham
    MK43 8HD Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    19 Lime Close
    Bromham
    MK43 8HD Bedford
    Bedfordshire
    British63728750001
    MAVITY, Harold Roger Wallis
    187 Hammersmith Grove
    LU6 0NP London
    Amministratore
    187 Hammersmith Grove
    LU6 0NP London
    United KingdomBritish122138820001
    PENROSE, Ian Richard
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    British32311080001
    REVITT, Kathryn
    3 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    3 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish49315020001
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    Amministratore
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    United KingdomBritish83024660001
    SUNLEY, Anthony William
    22 East Grinstead Road
    RH7 6EP Lingfield
    Surrey
    Amministratore
    22 East Grinstead Road
    RH7 6EP Lingfield
    Surrey
    British6467980001
    WHITE, Robert Andrew
    6 The Dovecote
    SG7 5PE Ashwell
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 The Dovecote
    SG7 5PE Ashwell
    Hertfordshire
    British8583060001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    Amministratore
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish2272770002
    WILLIAMS, John Owen
    3 Wolsey Drive
    Bowden
    WA14 3QU Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    3 Wolsey Drive
    Bowden
    WA14 3QU Altrincham
    Cheshire
    British12556640002

    PARK HALL LEISURE (DERBYSHIRE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    1ST party commercail legal charge
    Creato il 28 feb 1997
    Consegnato il 06 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    The l/h property k/a britannia park ilkestone amber valley derbyshire t/no dy 146087 & f/h property K.a land on the north west and south east side of pit lane shupley derby t/no dy 272903 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 feb 1997
    Consegnato il 06 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0