EPS MAINTENANCE LIMITED

EPS MAINTENANCE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEPS MAINTENANCE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02022463
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EPS MAINTENANCE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova EPS MAINTENANCE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EPS MAINTENANCE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IPM ENGINEERING LIMITED22 mag 198622 mag 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di EPS MAINTENANCE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per EPS MAINTENANCE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per EPS MAINTENANCE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del segretario cambiati per Mitie Company Secretarial Services Limited il 20 gen 2014

    1 pagineCH04

    Bilancio annuale redatto al 19 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 gen 2014

    Stato del capitale al 21 gen 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 8 Monarch Court the Brooms Emersons Green Bristol BS16 7FH in data 20 gen 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Peter Iain Maynard Skoulding il 23 ago 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 19 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Mitie Administration 2 Limited come amministratore in data 31 gen 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mitie Administration 1 Limited come amministratore in data 31 gen 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 19 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    4 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 1 Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green Bristol England BS16 7FN

    1 pagineAD02

    Nomina di Peter Iain Maynard Skoulding come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Clark come amministratore

    1 pagineTM01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 19 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Nomina di Mitie Company Secretarial Services Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Nomina di Mitie Administration 2 Limited come amministratore

    3 pagineAP02

    Chi sono gli amministratori di EPS MAINTENANCE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    Segretario
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5228356
    148474450001
    SKOULDING, Peter Iain Maynard
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    Amministratore
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    United KingdomBritish186216730001
    GINGER, Deborah
    Galabrae
    32 Chevening Road, Chipstead
    TN13 2RZ Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Galabrae
    32 Chevening Road, Chipstead
    TN13 2RZ Sevenoaks
    Kent
    British7200150002
    HOLMES, Peter James
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    Segretario
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    British97375340001
    MORLEY, Nigel
    25 Applecross Close
    ME1 1SQ Rochester
    Kent
    Segretario
    25 Applecross Close
    ME1 1SQ Rochester
    Kent
    British65393440001
    RAJENDRA, George Rajkumar
    29 Higher Green
    KT17 3BB Epsom
    Surrey
    Segretario
    29 Higher Green
    KT17 3BB Epsom
    Surrey
    British4618730002
    ANDERSON, David John
    Hall Farm
    Hall Lane Shenfield
    CM15 0SH Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Hall Farm
    Hall Lane Shenfield
    CM15 0SH Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish65141060002
    CLARKE, James Ian
    The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    Amministratore
    The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    United KingdomBritish135276530001
    GINGER, Brian George
    Galabrae
    32 Chevening Road, Chipstead
    TN13 2RZ Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Galabrae
    32 Chevening Road, Chipstead
    TN13 2RZ Sevenoaks
    Kent
    British7200160002
    GINGER, Deborah
    Galabrae
    32 Chevening Road, Chipstead
    TN13 2RZ Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Galabrae
    32 Chevening Road, Chipstead
    TN13 2RZ Sevenoaks
    Kent
    British7200150002
    GINGER, Lee Brian
    Downs View Close
    Pratts Bottom
    BR6 7SU Orpington
    2
    Kent
    Amministratore
    Downs View Close
    Pratts Bottom
    BR6 7SU Orpington
    2
    Kent
    British97505650002
    GRIFFIN, Peter
    12 Hurst Green Road
    RH8 9BT Oxted
    Surrey
    Amministratore
    12 Hurst Green Road
    RH8 9BT Oxted
    Surrey
    United KingdomBritish77000520001
    HOLMES, Peter James
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    Amministratore
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    EnglandBritish97375340001
    JEFFERYS, Gary Stephen
    Apperfield Road
    Biggin Hill
    TW16 3LX Westerham
    77
    Kent
    Amministratore
    Apperfield Road
    Biggin Hill
    TW16 3LX Westerham
    77
    Kent
    British38836490003
    LEWIS, Matthew Donald Lewis
    Apartment 4 Calverley Court
    Downs Bridge Road
    BR3 5HX Beckenham
    Kent
    Amministratore
    Apartment 4 Calverley Court
    Downs Bridge Road
    BR3 5HX Beckenham
    Kent
    British73626100001
    MORLEY, Nigel
    25 Applecross Close
    ME1 1SQ Rochester
    Kent
    Amministratore
    25 Applecross Close
    ME1 1SQ Rochester
    Kent
    British65393440001
    ODONNELL, James Michael
    35 The Avenue
    Highams Park
    E4 9LB London
    Amministratore
    35 The Avenue
    Highams Park
    E4 9LB London
    British78300340001
    READER, Paul David
    8a Torrance Close
    RM11 1JT Hornchurch
    Essex
    Amministratore
    8a Torrance Close
    RM11 1JT Hornchurch
    Essex
    British92246340002
    REEVE, Simon
    1 Forge Cottages
    Chilbrook Road
    KT11 3PD Cobham
    Surrey
    Amministratore
    1 Forge Cottages
    Chilbrook Road
    KT11 3PD Cobham
    Surrey
    British93064280001
    ENVIRONMENTAL PROPERTY SERVICES PLC
    Broadwalk House
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    Amministratore
    Broadwalk House
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    64155070001
    MITIE ADMINISTRATION 1 LIMITED
    The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    Amministratore
    The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06537612
    148505960001
    MITIE ADMINISTRATION 2 LIMITED
    The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    Amministratore
    The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06537610
    148506020001

    EPS MAINTENANCE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 19 apr 2002
    Consegnato il 27 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The interest of eps maintenance limited in the £23,100 deposited in the interest earning deposit account designated.
    Persone aventi diritto
    • Jeremy Miles Allan Thompson and Jennifer Mary Thompson
    Transazioni
    • 27 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 13 ago 1999
    Consegnato il 18 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 07 dic 1998
    Consegnato il 21 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 ago 1989
    Consegnato il 10 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 27 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0