ASHWORTH ASSURED TENANCIES LIMITED

ASHWORTH ASSURED TENANCIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASHWORTH ASSURED TENANCIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02022745
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASHWORTH ASSURED TENANCIES LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova ASHWORTH ASSURED TENANCIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    54 Manor Road
    Cheam
    SM2 7AG Sutton
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASHWORTH ASSURED TENANCIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ANGLIA CONVEYANCING SERVICES LIMITED23 mag 198623 mag 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASHWORTH ASSURED TENANCIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2023

    Quali sono le ultime deposizioni per ASHWORTH ASSURED TENANCIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2023

    7 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 020227450009 in pieno

    1 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da Global House 1 Ashley Avenue Epsom Surrey KT18 5FL England a 54 Manor Road Cheam Sutton SM2 7AG in data 28 mar 2023

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 nov 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2022

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di John Charles Bentlif South come amministratore in data 14 giu 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2021

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mrs Joanna Katie Hunt come amministratore in data 19 ott 2020

    2 pagineAP01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2020

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2019

    15 pagineAA

    Nomina di Mrs Joanna Katie Hunt come segretario in data 28 dic 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di John Charles Bentlif South come segretario in data 28 dic 2018

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2018

    15 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Charles Bentlif South il 01 giu 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr John Charles Bentlif South il 01 giu 2018

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di ASHWORTH ASSURED TENANCIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HUNT, Joanna Katie
    Mallinson Road
    SW11 1BJ London
    120
    England
    Segretario
    Mallinson Road
    SW11 1BJ London
    120
    England
    254137130001
    BURGESS, Richard John
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    Amministratore
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British35427700001
    HUNT, Joanna Katie
    Manor Road
    Cheam
    SM2 7AG Sutton
    54
    England
    Amministratore
    Manor Road
    Cheam
    SM2 7AG Sutton
    54
    England
    EnglandBritish201982420001
    FATH, Wendy Butler
    Flat 4 Claremont Hall
    Highdale Road
    BS21 7LW Clevedon
    Avon
    Segretario
    Flat 4 Claremont Hall
    Highdale Road
    BS21 7LW Clevedon
    Avon
    British41883380001
    NOWELL, Stephen Gerrard
    Belmont Abson Road
    Pucklechurch
    BS16 9SD Bristol
    Segretario
    Belmont Abson Road
    Pucklechurch
    BS16 9SD Bristol
    British55554710001
    SOUTH, John Charles Bentlif
    Ferry Road
    Studland
    BH19 3AQ Swanage
    Knighton House
    England
    Segretario
    Ferry Road
    Studland
    BH19 3AQ Swanage
    Knighton House
    England
    British21451100002
    TREVELYAN, Michael Charles Edward
    12 Church Lane
    Backwell
    BS19 3PQ Bristol
    Avon
    Segretario
    12 Church Lane
    Backwell
    BS19 3PQ Bristol
    Avon
    British2706360001
    WOOD, David James
    13 Vermuyden Way
    Fen Drayton
    CB4 5TA Cambridge
    Cambridgeshire
    Segretario
    13 Vermuyden Way
    Fen Drayton
    CB4 5TA Cambridge
    Cambridgeshire
    British19531650001
    ZANT BOER, Ian
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    Segretario
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    British80009300004
    BENTHAM, Harry
    43 Blackpool Road
    Ansdell
    FY8 4EJ Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    43 Blackpool Road
    Ansdell
    FY8 4EJ Lytham St Annes
    Lancashire
    British39161320001
    COOK, Graham Ronald
    Barclosh
    DG5 4PL Dalbeattie
    Kirkcudbrightshire
    Amministratore
    Barclosh
    DG5 4PL Dalbeattie
    Kirkcudbrightshire
    United KingdomBritish1233160001
    CORNISH, John Frederick Dadds
    Rosemont Church Road
    Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    Avon
    Amministratore
    Rosemont Church Road
    Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    Avon
    British19019770001
    MANSFIELD, Linda Marjorie
    11 Hopkins Close
    Milton Keynes Village
    MK10 9AS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    11 Hopkins Close
    Milton Keynes Village
    MK10 9AS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British42338210001
    NEAVES, Barry James
    40 Barrington Road
    NN10 0NJ Rushden
    Northamptonshire
    Amministratore
    40 Barrington Road
    NN10 0NJ Rushden
    Northamptonshire
    British44749950001
    SOUTH, John Charles Bentlif
    Ferry Road
    Studland
    BH19 3AQ Swanage
    Knighton House
    Dorset
    United Kingdom
    Amministratore
    Ferry Road
    Studland
    BH19 3AQ Swanage
    Knighton House
    Dorset
    United Kingdom
    EnglandBritish21451100005
    TORRANCE, Hugh
    8 Hillpark Avenue
    EH4 7AT Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    8 Hillpark Avenue
    EH4 7AT Edinburgh
    Midlothian
    British342380001
    TREVELYAN, Michael Charles Edward
    12 Church Lane
    Backwell
    BS19 3PQ Bristol
    Avon
    Amministratore
    12 Church Lane
    Backwell
    BS19 3PQ Bristol
    Avon
    British2706360001
    WHITE, Keith
    6 Pine Court
    Little Brington
    NN7 4EZ Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    6 Pine Court
    Little Brington
    NN7 4EZ Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish34410500001
    WILLINGHAM, Steven Craig
    53 Rochelle Way
    Duston
    NN5 6YJ Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    53 Rochelle Way
    Duston
    NN5 6YJ Northampton
    Northamptonshire
    British63092720002
    WOOD, David James
    13 Vermuyden Way
    Fen Drayton
    CB4 5TA Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    13 Vermuyden Way
    Fen Drayton
    CB4 5TA Cambridge
    Cambridgeshire
    British19531650001
    ZANT BOER, Ian
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    Amministratore
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    EnglandBritish80009300004

    Chi sono le persone con controllo significativo di ASHWORTH ASSURED TENANCIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Ashley Avenue
    KT18 5FL Epsom
    Global House
    Surrey
    England
    06 apr 2016
    Ashley Avenue
    KT18 5FL Epsom
    Global House
    Surrey
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02307652
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ASHWORTH ASSURED TENANCIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 21 mag 2018
    Consegnato il 23 mag 2018
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 23 mag 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 ago 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 gen 2011
    Consegnato il 03 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 03 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 ago 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 30 giu 2010
    Consegnato il 02 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    22/23 pritchard street bristol by way of fixed charge all plant and machinery owned by the borrower and its interest in any plant and machinery. All fixtures and fittings all other chattels and all benefits in respect of the insurances including claims and the refund of any premiums.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 02 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 ago 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 30 giu 2010
    Consegnato il 02 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    34-36 cumberland street bristol by way of fixed charge all plant and machinery owned by the borrower and its interest in any plant and machinery. All fixtures and fittings all other chattels and all benefits in respect of the insurances including claims and the refund of any premiums.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 02 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 ago 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 feb 2003
    Consegnato il 21 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 21 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 27 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 14 feb 2003
    Consegnato il 18 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property known as 21-24 pritchard street bristol title number AV188752 and 14 brunswick square (34-36 cumberland street) bristol title number GR899. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 18 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 06 mar 1998
    Consegnato il 14 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Properties k/a 1,2,5,6,9 and 15 buckingham court marlborough drive estate t/nos DU166614 DU166619 DU166621 DU166623 and DU166628. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 14 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 dic 1996
    Consegnato il 18 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Inclusive of property at plots 1 to 14 jesmond court (comprising 2-28 goodwood close (even no'S.) chester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 18 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third party charge
    Creato il 09 dic 1996
    Consegnato il 17 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land being plots 1 to 14 goodwood close chester comprising numbers: 2 to 28 (even numbers only) goodwood close chester t/n CH318086 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on that property and the goodwill of any business carried on on that property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 17 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ASHWORTH ASSURED TENANCIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 set 1994Data della dichiarazione di solvibilità giurata
    30 set 1994Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0