E.J. HORROCKS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | E.J. HORROCKS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Liquidazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02023634 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di E.J. HORROCKS LIMITED?
- Altre installazioni in costruzioni (43290) / Costruzioni
- Stuccature (43310) / Costruzioni
- Rivestimento di pavimenti e pareti (43330) / Costruzioni
Dove si trova E.J. HORROCKS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 4 Abbey Orchard Street SW1P 2HT London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di E.J. HORROCKS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CARILLION CONTRACT SERVICES LIMITED | 28 lug 2011 | 28 lug 2011 |
| EAGA CONTRACT SERVICES LIMITED | 11 giu 2010 | 11 giu 2010 |
| E. J. HORROCKS LIMITED | 13 nov 1995 | 13 nov 1995 |
| E.J. HORROCKS (PLASTERING CONTRACTORS) LIMITED | 28 mag 1986 | 28 mag 1986 |
Quali sono gli ultimi bilanci di E.J. HORROCKS LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2017 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2018 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per E.J. HORROCKS LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 10 giu 2019 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 24 giu 2019 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 10 giu 2018 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per E.J. HORROCKS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Alison Margaret Shepley come segretario in data 21 dic 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a 4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HT in data 04 ott 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX in data 01 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Carillion Energy Services Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Ordine del tribunale di liquidazione | 3 pagine | COCOMP | ||||||||||
Cessazione della carica di Westley Maffei come segretario in data 09 lug 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Francis Tapp come amministratore in data 06 lug 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Alison Margaret Shepley il 25 giu 2018 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Howson come amministratore in data 15 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Alison Margaret Shepley il 20 nov 2017 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Zafar Iqbal Khan come amministratore in data 11 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Westley Maffei come segretario in data 01 lug 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Francis George come segretario in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Hayward come amministratore in data 06 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Zafar Iqbal Khan il 01 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Zafar Iqbal Khan come amministratore in data 31 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Adam come amministratore in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed carillion contract services LIMITED\certificate issued on 16/07/15 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di E.J. HORROCKS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGE, Timothy Francis | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 161244710001 | |||||||
| HORROCKS, Edward John | Segretario | 4 Heythrop Drive CH60 1YQ Wirral Merseyside | British | 15600830002 | ||||||
| JUDD, Christopher | Segretario | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne & Wear | British | 69049410002 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 235183710001 | |||||||
| SHEPLEY, Alison Margaret | Segretario | 7-12 Tavistock Street WC1H 9LT London Lynton House, 2nd Floor United Kingdom | 160706050001 | |||||||
| ADAM, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| CRYER, Frank Mayo | Amministratore | 61 Osmaston Road Prenton CH42 8LR Birkenhead Wirral | England | British | 9024920001 | |||||
| DHANAK, Mitesh | Amministratore | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne & Wear | England | British | 155689080001 | |||||
| HAYWARD, Alan | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 154549030001 | |||||
| HOLLAND, Eric | Amministratore | Rose Cottage Alderley Road Winnington CW8 4BS Northwich Cheshire | British | 15569920001 | ||||||
| HORROCKS, Colin | Amministratore | Heather Cottage The Ridge Heswall L60 6SP Wirral Merseyside | British | 15600840002 | ||||||
| HORROCKS, Derek Ian | Amministratore | Dorset House Latchfore Road Gayton CH60 3RW Wirral | England | British | 47819720005 | |||||
| HORROCKS, Edward | Amministratore | River View Lillyfield CH60 8NT Wirral Merseyside | British | 70700420002 | ||||||
| HORROCKS, Edward John | Amministratore | 4 Heythrop Drive CH60 1YQ Wirral Merseyside | British | 15600830002 | ||||||
| HORROCKS, Olive | Amministratore | Riverview Lillyfield CH60 8NT Wirral Merseyside | British | 15569940003 | ||||||
| HOWSON, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| LAWSON, Gary Ian | Amministratore | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne & Wear | United Kingdom | British | 85842790001 | |||||
| LAWSON, Gary Ian | Amministratore | 1 Clifton Court WA7 4UT Runcorn Cheshire | United Kingdom | British | 85842790001 | |||||
| MCDONOUGH, John | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | Uk | British | 74536340007 | |||||
| MCMAHON, Michael | Amministratore | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne & Wear | United Kingdom | British | 112505130001 | |||||
| ROCHE, John | Amministratore | 92 Rosslyn Avenue Maghull L31 8AT Liverpool Merseyside | British | 74416950001 | ||||||
| SHARP, Giles Henry | Amministratore | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne & Wear | United Kingdom | British | 112704610001 | |||||
| SPANN, Neil | Amministratore | Regent Farm Road Gosforth NE3 3AF Newcastle Upon Tyne Partnership House United Kingdom | United Kingdom | British | 154870250001 | |||||
| SYMONDS, Jonathan Campbell | Amministratore | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne & Wear | England | British | 176880120001 | |||||
| TAPP, Richard Francis | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 173852420001 | |||||
| TIDBALL, Graham Paul | Amministratore | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne & Wear | England | British | 158266980001 | |||||
| VARLEY, Paul Richard | Amministratore | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House United Kingdom | United Kingdom | British | 137984880002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di E.J. HORROCKS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion Energy Services Limited | 06 apr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
E.J. HORROCKS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 12 dic 2005 Consegnato il 29 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Creato il 30 gen 2001 Consegnato il 05 feb 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari High interest business account number 90519367. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 02 mar 1992 Consegnato il 20 mar 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from thecompany and/or horrocks constuction limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari See form 395 ref M418C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
E.J. HORROCKS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione coatta |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0